BROONALE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | BROONALE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01137141 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BROONALE LIMITED ?
Adresse du siège social | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BROONALE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour BROONALE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Ashby House 1 Bridge Street Staines Middlesex TW18 4TP le 22 déc. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Anne Louise Oliver le 04 nov. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Anne Louise Oliver le 04 nov. 2011 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 3 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sean Michael Paterson le 14 oct. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Sean Michael Paterson en tant qu'administrateur le 29 sept. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Craig Tedford en tant que directeur le 29 sept. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Charles Low en tant qu'administrateur le 29 août 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William John Payne en tant que directeur le 29 août 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Retrait de la demande de radiation de la société | 2 pages | DS02 | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 2 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 3 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BROONALE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVER, Anne Louise | Secrétaire | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | British | 132910690001 | ||||||
LOW, John Charles | Administrateur | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 162758370001 | ||||
OLIVER, Anne Louise | Administrateur | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | United Kingdom | British | Uk Tax Manager | 132910690001 | ||||
PATERSON, Sean Michael | Administrateur | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | Scotland | British | Accountant | 141021760002 | ||||
AVES, Simon Howard | Secrétaire | Swanston Gardens EH10 1DJ Edinburgh 5 | British | Head Of Uk Tax | 132259650001 | |||||
HOMER, Neville Rex | Secrétaire | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
STEVENS, Mark | Secrétaire | 75 Wallace Mill Gardens EH53 0BG Mid Calder West Lothian | British | Company Secretary | 80951870003 | |||||
AVES, Simon Howard | Administrateur | Swanston Gardens EH10 1DJ Edinburgh 5 | Scotland | British | Head Of Uk Tax | 132259650001 | ||||
HOMER, Neville Rex | Administrateur | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | Chartered Secretary | 895960001 | |||||
IZATT, George Gordon Maclean | Administrateur | 11 Broom Road KY13 8BU Kinross Kinross Shire | United Kingdom | British | Company Director | 895970001 | ||||
IZATT, George Gordon Maclean | Administrateur | 11 Broom Road KY13 8BU Kinross Kinross Shire | United Kingdom | British | Director | 895970001 | ||||
MILLER, Louise | Administrateur | 13 Traquair Park West EH12 7AN Edinburgh Midlothian | British | Chartered Secretary | 63895470001 | |||||
PAYNE, William John | Administrateur | Scottsdale TD6 9QE Melrose 5 Roxburghshire | Scotland | British | Solicitor | 136005370001 | ||||
PEAREY, Michael John | Administrateur | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | Solicitor | 46305030001 | |||||
STEVENS, Mark | Administrateur | 75 Wallace Mill Gardens EH53 0BG Mid Calder West Lothian | British | Company Secretary | 80951870003 | |||||
TEDFORD, Craig | Administrateur | 2 Rosslyn Terrace Dowanhill G12 9NB Glasgow | United Kingdom | British | Company Director | 106867030001 | ||||
SCOTTISH & NEWCASTLE BREWERIES(SERVICES) LIMITED | Administrateur | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 2-4 | 68666210006 |
BROONALE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Créé le 04 oct. 1983 Livré le 06 oct. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Property situate and known as the masons arms, thrope street, thorpe hesley, rotherham title no syk 157715 together with all fixtures & fittings and the goodwill of the business carried on upon the premises & the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 mars 1983 Livré le 25 mars 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/Hold "the limes hotel" broom lane, rotherham, south yorkshire together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof to the property or any part thereof other than machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 01 sept. 1982 Livré le 17 sept. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti Ukp 7,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee including monies due for goods supplied | |
Brèves mentions F/Hold the masons arms, thorpe, hesley, near rotherham south yorkshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 27 oct. 1975 Livré le 31 oct. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 2500 sq yds adjoining the travellers rest milton street swinton mexborough south yorks with all fixtures. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 06 mai 1975 Livré le 12 mai 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (A) milton street swinton tog with fixtures (see doc m/10) goodwill of the business. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 07 avr. 1975 Livré le 14 avr. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Floating charge on the (see doc m/9). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0