BROONALE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBROONALE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01137141
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BROONALE LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BROONALE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BROONALE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STARPSHIRE LIMITED01 oct. 197301 oct. 1973

    Quels sont les derniers comptes de BROONALE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour BROONALE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A0OM6GAP

    Changement d'adresse du siège social de Ashby House 1 Bridge Street Staines Middlesex TW18 4TP le 22 déc. 2011

    1 pagesAD01
    X0OQ4L48

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 nov. 2011

    État du capital au 04 nov. 2011

    • Capital: GBP 9,999
    SH01
    X8R2SYYM

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Anne Louise Oliver le 04 nov. 2011

    2 pagesCH01
    X8R2RYYL

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Anne Louise Oliver le 04 nov. 2011

    1 pagesCH03
    X8R2QYYK

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    3 pagesAA
    EQODZ004

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sean Michael Paterson le 14 oct. 2011

    2 pagesCH01
    X1LWSYDI

    Nomination de Mr Sean Michael Paterson en tant qu'administrateur le 29 sept. 2011

    2 pagesAP01
    XZNLLY9W

    Cessation de la nomination de Craig Tedford en tant que directeur le 29 sept. 2011

    1 pagesTM01
    XZNIZY97

    Nomination de Mr John Charles Low en tant qu'administrateur le 29 août 2011

    2 pagesAP01
    XPR9PXGO

    Cessation de la nomination de William John Payne en tant que directeur le 29 août 2011

    1 pagesTM01
    XPR9NXGM

    Retrait de la demande de radiation de la société

    2 pagesDS02
    AKJQ2WMN

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    ALJH3WJD

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    XXFG2P0G

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    2 pagesAA
    S2SGDM23

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    X3ZSNF3W

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    2 pagesAA
    A7CRO8S8

    legacy

    1 pages288b
    ARZDP7QZ

    legacy

    1 pages288b
    AYKNI7FJ

    legacy

    3 pages288a
    A0WGV7AY

    legacy

    3 pages288a
    A9LDK6Y5

    legacy

    2 pages288a
    ADCJA6VT

    legacy

    4 pages363a
    X3AA04J7

    Qui sont les dirigeants de BROONALE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OLIVER, Anne Louise
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Secrétaire
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    British132910690001
    LOW, John Charles
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Administrateur
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant162758370001
    OLIVER, Anne Louise
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Administrateur
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    United KingdomBritishUk Tax Manager132910690001
    PATERSON, Sean Michael
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Administrateur
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    ScotlandBritishAccountant141021760002
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Secrétaire
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    BritishHead Of Uk Tax132259650001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Secrétaire
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    BritishCompany Secretary80951870003
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Administrateur
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    ScotlandBritishHead Of Uk Tax132259650001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    BritishChartered Secretary895960001
    IZATT, George Gordon Maclean
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    Administrateur
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    United KingdomBritishCompany Director895970001
    IZATT, George Gordon Maclean
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    Administrateur
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    United KingdomBritishDirector895970001
    MILLER, Louise
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Secretary63895470001
    PAYNE, William John
    Scottsdale
    TD6 9QE Melrose
    5
    Roxburghshire
    Administrateur
    Scottsdale
    TD6 9QE Melrose
    5
    Roxburghshire
    ScotlandBritishSolicitor136005370001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Administrateur
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    BritishSolicitor46305030001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Administrateur
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    BritishCompany Secretary80951870003
    TEDFORD, Craig
    2 Rosslyn Terrace
    Dowanhill
    G12 9NB Glasgow
    Administrateur
    2 Rosslyn Terrace
    Dowanhill
    G12 9NB Glasgow
    United KingdomBritishCompany Director106867030001
    SCOTTISH & NEWCASTLE BREWERIES(SERVICES) LIMITED
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    2-4
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    2-4
    68666210006

    BROONALE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 04 oct. 1983
    Livré le 06 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property situate and known as the masons arms, thrope street, thorpe hesley, rotherham title no syk 157715 together with all fixtures & fittings and the goodwill of the business carried on upon the premises & the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1983Enregistrement d'une charge
    • 26 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 mars 1983
    Livré le 25 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold "the limes hotel" broom lane, rotherham, south yorkshire together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof to the property or any part thereof other than machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transactions
    • 25 mars 1983Enregistrement d'une charge
    • 26 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 sept. 1982
    Livré le 17 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Ukp 7,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee including monies due for goods supplied
    Brèves mentions
    F/Hold the masons arms, thorpe, hesley, near rotherham south yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Whitebead East Penines Limited
    Transactions
    • 17 sept. 1982Enregistrement d'une charge
    • 26 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 27 oct. 1975
    Livré le 31 oct. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2500 sq yds adjoining the travellers rest milton street swinton mexborough south yorks with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1975Enregistrement d'une charge
    • 26 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 06 mai 1975
    Livré le 12 mai 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (A) milton street swinton tog with fixtures (see doc m/10) goodwill of the business.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 1975Enregistrement d'une charge
    • 26 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 07 avr. 1975
    Livré le 14 avr. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge on the (see doc m/9). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 1975Enregistrement d'une charge
    • 26 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0