TOREX RETAIL (AM) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOREX RETAIL (AM) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01146442
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOREX RETAIL (AM) LIMITED ?

    • (7222) /

    Où se situe TOREX RETAIL (AM) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TOREX RETAIL (AM) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALPHAMERIC RETAIL LIMITED11 mai 200011 mai 2000
    PENNINE RETAIL SYSTEMS LIMITED20 oct. 199920 oct. 1999
    PENNINE COMPUTER SERVICES LIMITED20 nov. 197320 nov. 1973

    Quels sont les derniers comptes de TOREX RETAIL (AM) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2005

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TOREX RETAIL (AM) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TOREX RETAIL (AM) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 juin 2014

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 déc. 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 juin 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 déc. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 juin 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 déc. 2011

    5 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de 62 Wilson Street London EC2A 2BU le 30 sept. 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 juin 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 déc. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 juin 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 déc. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 juin 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 déc. 2008

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages287

    Déclaration des affaires

    6 pages4.20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de TOREX RETAIL (AM) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Secrétaire
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    OtherDirector123425810001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Administrateur
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    UsaOtherDirector123425810001
    ARTHURS, Barbara
    The Old Vicarage Streethouse Lane
    OL3 5QX Dobcross Oldham
    Lancashire
    Secrétaire
    The Old Vicarage Streethouse Lane
    OL3 5QX Dobcross Oldham
    Lancashire
    British73793490001
    BURTON, Steven John
    9 South View
    Woodley
    SK6 1PD Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    9 South View
    Woodley
    SK6 1PD Stockport
    Cheshire
    BritishFinance Director58305750001
    GREGORY, Andrew Nicholas
    12 Glendene Avenue
    Bramhall
    SK7 1BH Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    12 Glendene Avenue
    Bramhall
    SK7 1BH Stockport
    Cheshire
    BritishAccountant63728320001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    BritishSolicitor109926660001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Secrétaire
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    LEEK, Marcus
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    Secrétaire
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director115960470001
    MINIKIN, Claire Louise
    Dunholme
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    Secrétaire
    Dunholme
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    British77770730001
    SOULSBY, James Andrew
    Bramshott Lodge
    Woolmer Hill
    GU27 1QA Haslemere
    Surrey
    Secrétaire
    Bramshott Lodge
    Woolmer Hill
    GU27 1QA Haslemere
    Surrey
    British38342300002
    WARRINGTON, Lorri
    Applecroft
    Plaistow Road Ifold
    RH14 0TU Billingshurst
    West Sussex
    Secrétaire
    Applecroft
    Plaistow Road Ifold
    RH14 0TU Billingshurst
    West Sussex
    British84757210001
    ARTHURS, Barbara
    The Old Vicarage Streethouse Lane
    OL3 5QX Dobcross Oldham
    Lancashire
    Administrateur
    The Old Vicarage Streethouse Lane
    OL3 5QX Dobcross Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director73793490001
    ARTHURS, John Duncan
    The Old Vicarage Streethouse Lane
    OL3 5QX Dobcross Oldham
    Lancashire
    Administrateur
    The Old Vicarage Streethouse Lane
    OL3 5QX Dobcross Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director17668130001
    BITTLESTON, Timothy Steven
    The Chimneys
    73 Station Road
    DE13 8DS Barton Under Needwood
    Staffordshire
    Administrateur
    The Chimneys
    73 Station Road
    DE13 8DS Barton Under Needwood
    Staffordshire
    BritishCompany Director74438980001
    BLATHERWICK, Andrew
    Ranworth
    Doggetts Wood Lane
    HP8 4TJ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Ranworth
    Doggetts Wood Lane
    HP8 4TJ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDivisional Managing Director176086350001
    BURTON, Steven John
    9 South View
    Woodley
    SK6 1PD Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    9 South View
    Woodley
    SK6 1PD Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritishFinance Director58305750001
    CANNING, Phillip Francis
    Roeside
    Bradshaw Lane, Chapel En Le Frith
    SK23 9UL High Peak
    Derbyshire
    Administrateur
    Roeside
    Bradshaw Lane, Chapel En Le Frith
    SK23 9UL High Peak
    Derbyshire
    BritishManaging Director70379550001
    COATMAN, Nigel Godfrey
    55 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6LQ Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    55 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6LQ Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director87862230001
    COOKSLEY, Graeme
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    Administrateur
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    New ZealanderDirector122786180001
    DOBIE, Timothy Arthur Ross
    1 St Andrews Road
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8BP Blackburn
    Lancashire
    Administrateur
    1 St Andrews Road
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8BP Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritishDirector97704830001
    GREENOUGH, Michael
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    Administrateur
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    CanadianDirector123427350001
    GREGORY, Andrew Nicholas
    12 Glendene Avenue
    Bramhall
    SK7 1BH Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    12 Glendene Avenue
    Bramhall
    SK7 1BH Stockport
    Cheshire
    BritishAccountant63728320001
    HELLEWELL, Brian
    5 Bradda Mount
    SK7 3BX Bramhall
    Cheshire
    Administrateur
    5 Bradda Mount
    SK7 3BX Bramhall
    Cheshire
    BritishSales Director111292040001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    BritishSolicitor109926660001
    LEEK, Marcus
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director115960470001
    LEES, Iain Roger
    Church Farm
    School Lane
    WA16 0JF Pickmere
    Cheshire
    Administrateur
    Church Farm
    School Lane
    WA16 0JF Pickmere
    Cheshire
    EnglandBritishFinancial Director72628960001
    MAHER, Anthony Robert, Director
    49 Calderfield Close
    Stockton Heath
    WA4 6PJ Warrington
    Administrateur
    49 Calderfield Close
    Stockton Heath
    WA4 6PJ Warrington
    United KingdomBritishDirector34190040002
    MCLAREN, Michael Gerald
    October House 4 The Mount Drive
    RH2 0EZ Reigate
    Surrey
    Administrateur
    October House 4 The Mount Drive
    RH2 0EZ Reigate
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant68561640002
    MEADE, Michael Gerald
    54 Clapham Common North Side
    SW4 9RX London
    Administrateur
    54 Clapham Common North Side
    SW4 9RX London
    EnglandBritish,IrishFinance Director142059750001
    MINIKIN, Claire Louise
    Dunholme
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Dunholme
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    BritishChartered Accountant77770730001
    MITCHELL, Robert Neil Whyte
    50 Leckford Road
    Jericho
    OX2 6HY Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    50 Leckford Road
    Jericho
    OX2 6HY Oxford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director116745740001
    MORCOMBE, Alan William
    Waverley House
    Kitcombe Wood
    GU34 3ND Faringdon
    Hampshire
    Administrateur
    Waverley House
    Kitcombe Wood
    GU34 3ND Faringdon
    Hampshire
    BritishCompany Director32807230004
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector57516220003
    PERRIN, David Anthony
    4 Norwood Road
    Gatley
    SK8 4AJ Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    4 Norwood Road
    Gatley
    SK8 4AJ Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishNone97028100001
    RANDALL, Martin Keith
    Jacks Platt
    Duddleswell
    TN22 3JR Uckfield
    East Sussex
    Administrateur
    Jacks Platt
    Duddleswell
    TN22 3JR Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritishGroup Finance Director40012240002

    TOREX RETAIL (AM) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage of shares
    Créé le 05 janv. 2006
    Livré le 13 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First legal mortgage all the shares,first fixed charge all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transactions
    • 13 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage of shares
    Créé le 12 mai 2005
    Livré le 26 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all the shares owned by it or held by any nominee on its behalf and by way of first fixed charge all related rights being any dividend or interest paid or payable, any right, money or property accruing or offered at any time. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facilityagent)
    Transactions
    • 26 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 29 nov. 2004
    Livré le 03 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from torex retail PLC, each chargor and/or any subsidiary of torex retail PLC to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee) as Trustee and Agent for the Lenders
    Transactions
    • 03 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Créé le 01 mai 1999
    Livré le 06 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 févr. 1990
    Livré le 07 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    3 stockport road, romiley, greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    Deed of charge.
    Créé le 05 juil. 1989
    Livré le 13 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book and other debts.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TOREX RETAIL (AM) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 déc. 2007Commencement of winding up
    27 avr. 2015Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon James Underwood
    Ukw
    10 Fenchurch Avenue
    EC3M 5BN London
    practitioner
    Ukw
    10 Fenchurch Avenue
    EC3M 5BN London
    Kevin James Wilson Weir
    Ukw
    10 Fenchurch Avenue
    EC3M 5BN London
    practitioner
    Ukw
    10 Fenchurch Avenue
    EC3M 5BN London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0