MLE REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMLE REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01146745
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MLE REALISATIONS LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe MLE REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    38 De Montfort Street
    LE1 7GS Leicester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MLE REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MOLINARE LIMITED31 déc. 197831 déc. 1978
    MOLINARE SOUND LIMITED21 nov. 197321 nov. 1973

    Quels sont les derniers comptes de MLE REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour MLE REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    23 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 juin 2018

    18 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 juin 2017

    14 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 juin 2016

    14 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 juin 2015

    12 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 juin 2014

    13 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 03 juin 2013

    16 pages2.24B

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 06 déc. 2012

    14 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    48 pages2.17B

    Avis d'ordonnance pour traiter les biens grevés

    5 pages2.28B

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Certificat de changement de nom

    Company name changed molinare LIMITED\certificate issued on 18/06/12
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name18 juin 2012

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Changement d'adresse du siège social de * Harcourt House 19 Cavendish Square London W1A 2AW United Kingdom* le 13 juin 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    27 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 92 King Street London W6 0QW* le 22 juin 2011

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * 19 Cavendish Square London Greater London W1A 2AW* le 10 juin 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 mai 2011

    État du capital au 18 mai 2011

    • Capital: GBP 101,710
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Abhieshek Tewari le 18 mai 2011

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de MLE REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHARMA, Anish Kumar
    R-756 New Rajinder Nagar
    FOREIGN New Delhi
    110060
    India
    Administrateur
    R-756 New Rajinder Nagar
    FOREIGN New Delhi
    110060
    India
    IndiaIndianDirector127876360001
    TEWARI, Abhieshek
    C-67 Friends Colony East
    New Delhi
    110065
    India
    Administrateur
    C-67 Friends Colony East
    New Delhi
    110065
    India
    IndiaIndianDirector135317410001
    TIWARI, Anand Kumar
    C-67 Friends Colony East
    New Delhi
    110065
    India
    Administrateur
    C-67 Friends Colony East
    New Delhi
    110065
    India
    IndiaIndianDirector130605760001
    TIWARI, Probodh
    C-67 Friends Colony East
    FOREIGN New Delhi
    110065
    India
    Administrateur
    C-67 Friends Colony East
    FOREIGN New Delhi
    110065
    India
    IndiaIndianDirector127876480001
    BALDWIN, Peter Alan Charles, Major General
    Acorns Oak End Way
    SL9 8DA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Acorns Oak End Way
    SL9 8DA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishConsultant50762530001
    HAMMOND, Michael Lawley
    64 Edna Road
    SW20 8BT London
    Secrétaire
    64 Edna Road
    SW20 8BT London
    British48477380001
    LASSMAN, Keith
    19 Cavendish Square
    W1A 2AW London
    Secrétaire
    19 Cavendish Square
    W1A 2AW London
    BritishSolicitor52423420003
    LAWSON-TANCRED, Andrew
    Aldborough Manor
    YO51 9EP Boroughbridge
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Aldborough Manor
    YO51 9EP Boroughbridge
    North Yorkshire
    British62085530001
    ROBERTS, Nigel John
    32 Werna House
    31 Monument Street
    EC3R 8BT London
    Secrétaire
    32 Werna House
    31 Monument Street
    EC3R 8BT London
    British93265570001
    ROSAMOND, Mark
    35 Peckarmans Wood
    Crescent Wood Road
    SE26 6RY London
    Secrétaire
    35 Peckarmans Wood
    Crescent Wood Road
    SE26 6RY London
    British35664160001
    SIDDA, Deepak Kumar
    Edith Grove
    SW10 0NH London
    Basement Flat 106
    Secrétaire
    Edith Grove
    SW10 0NH London
    Basement Flat 106
    British139159680001
    SIKKA, Deepak Kumar
    Basement Flat
    106 Edith Grove
    SW10 0NH London
    Secrétaire
    Basement Flat
    106 Edith Grove
    SW10 0NH London
    BritishAccountant103446470001
    ANDERSON, Martin Hume Caldicot
    Long House Farm
    Penrhos
    NP5 2DE Raglan
    Gwent
    Administrateur
    Long House Farm
    Penrhos
    NP5 2DE Raglan
    Gwent
    United KingdomBritishManaging Director105198750001
    BATE, Terence
    105 Hamri Street
    Ghajnsielem
    Gozo
    Malta
    Administrateur
    105 Hamri Street
    Ghajnsielem
    Gozo
    Malta
    MaltaCanadianDirector51047490001
    BRILLIANT, Andrew Prince
    17 Kenilworth Avenue
    10580 Rye
    New York
    Usa
    Administrateur
    17 Kenilworth Avenue
    10580 Rye
    New York
    Usa
    AmericanCompany Executive33119060001
    BROWN, Colin
    5 Binden Road
    W12 9RJ London
    Administrateur
    5 Binden Road
    W12 9RJ London
    United KingdomBritishDirector34528720001
    CALLEN, Stephen Gibson
    14 St Pauls Road
    TW9 2HH Richmond
    Surrey
    Administrateur
    14 St Pauls Road
    TW9 2HH Richmond
    Surrey
    EnglandBritishFinancial Director1530360001
    DION, Jean-Francois, Mon
    41 Avenue Simon Bolivar
    75019 Paris
    France
    Administrateur
    41 Avenue Simon Bolivar
    75019 Paris
    France
    FrenchCompany Executive33119070001
    DODD, Ia
    Flat 6 64 Canfield Gardens
    NW6 3EB London
    Administrateur
    Flat 6 64 Canfield Gardens
    NW6 3EB London
    BritishFacilities (Tv) Director58865960001
    DUNN, Victoria Ceris
    17 Arlington Square
    N1 7DR Islington
    London
    Administrateur
    17 Arlington Square
    N1 7DR Islington
    London
    United KingdomBritishCompany Director59058660002
    FIRMIN, Barry Howard
    Broad Oaks
    Lewes Road
    RH17 7SP Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Broad Oaks
    Lewes Road
    RH17 7SP Haywards Heath
    West Sussex
    BritishChartered Accountant17772130002
    FIRMIN, Barry Howard
    Broad Oaks
    Lewes Road
    RH17 7SP Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Broad Oaks
    Lewes Road
    RH17 7SP Haywards Heath
    West Sussex
    BritishChartered Accountant17772130002
    FOLIGNO, Mark Wayne
    70 Bolton Road
    SL4 3JL Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    70 Bolton Road
    SL4 3JL Windsor
    Berkshire
    EnglandBritishManaging Director125294570001
    FOULSER, Jeffrey
    13 Spencer Road
    Strawberry Hill
    TW2 5TH Twickenham
    Administrateur
    13 Spencer Road
    Strawberry Hill
    TW2 5TH Twickenham
    EnglandBritishTv Executive51047430002
    GEORGE, Catherine Mary
    184 Revelstoke Road
    SW18 5NW London
    Administrateur
    184 Revelstoke Road
    SW18 5NW London
    BritishFacilities Director109835070001
    GLAUM, Susan
    9 Bushwood Drive
    SE1 5RE London
    Administrateur
    9 Bushwood Drive
    SE1 5RE London
    BritishAccountant59634630002
    GUILLOU, Bernard Louis, Monsieur
    1 Square De Chatillon
    75014 Paris
    Paris
    Administrateur
    1 Square De Chatillon
    75014 Paris
    Paris
    FrenchCompany Executive31222040001
    HART, Richard John
    15 Gurdon Road
    Charlton
    SE7 7RN London
    Administrateur
    15 Gurdon Road
    Charlton
    SE7 7RN London
    United KingdomBritishOperations Director109834980001
    JESSUP, Patrick
    6 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    6 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    BritishDirector33119080001
    JESSUP, Patrick
    6 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    6 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    BritishDirector33119080001
    JONES, Richard Edward
    13 Puttenham Road
    Chineham
    RG24 8RB Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    13 Puttenham Road
    Chineham
    RG24 8RB Basingstoke
    Hampshire
    BritishSales Director64114590001
    LAWSON-TANCRED, Andrew
    Aldborough Manor
    YO51 9EP Boroughbridge
    North Yorkshire
    Administrateur
    Aldborough Manor
    YO51 9EP Boroughbridge
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director/Lawyer62085530001
    MILNE, Steven John
    South Lodge
    112 London Road
    GU34 4EW Holybourne
    Hampshire
    Administrateur
    South Lodge
    112 London Road
    GU34 4EW Holybourne
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector92303450002
    ROSAMOND, Mark
    35 Peckarmans Wood
    Crescent Wood Road
    SE26 6RY London
    Administrateur
    35 Peckarmans Wood
    Crescent Wood Road
    SE26 6RY London
    EnglandBritishChartered Accountant35664160001
    ROWLANDS, Christopher John
    Buchan House
    24 Northumberland Road Redland
    BS6 7BB Bristol
    Administrateur
    Buchan House
    24 Northumberland Road Redland
    BS6 7BB Bristol
    United KingdomBritishDirector4524130002

    MLE REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 janv. 2009
    Livré le 31 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of India
    Transactions
    • 31 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge
    Créé le 08 févr. 2006
    Livré le 13 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 13 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 2005
    Livré le 25 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 mai 2004
    Livré le 24 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 17 sept. 1999
    Livré le 24 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 nov. 1996
    Livré le 19 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 19 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 18 janv. 1995
    Livré le 27 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a licence dated 18 january 1995
    Brèves mentions
    The licensee's interest in the deposit fund and all property from time to time withdrawn from the deposit fund by way of security for the payment of any sums payable by the licensee under or pursuant to the provisions of a licence dated 18 january 1995.
    Personnes ayant droit
    • Reiner Moritz Associates Limited
    Transactions
    • 27 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 02 sept. 1985
    Livré le 23 sept. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts charge by way of legal mortgage l/h premises situate third floor 44 great marlborough street, london W1 l/h premises situate fourth floor 44 great marlborough street london W1 l/h premises situate at ground floor and basement 45 great marlborough street london W1 l/h premises situate at 3O/39 and 41/43 fouberts place london W1 and the proceeds of sale therof.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 sept. 1985Enregistrement d'une charge
    • 24 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 1984
    Livré le 10 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1984Enregistrement d'une charge
    Further guarantee & debenture
    Créé le 25 janv. 1984
    Livré le 15 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charged by the princiapl deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1984Enregistrement d'une charge
    Trust deed
    Créé le 10 févr. 1983
    Livré le 22 févr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing debenture stock of molinare holdings PLC amounting to £1,593,600 10% secured loan stock 1988
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 févr. 1983Enregistrement d'une charge
    Further guarantee and debenture
    Créé le 20 janv. 1983
    Livré le 28 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    • 24 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 22 oct. 1982
    Livré le 01 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or craven hall productions limited to chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 15 août 1980
    Livré le 27 août 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 août 1980Enregistrement d'une charge

    MLE REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 juin 2012Administration started
    03 juin 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Situl Devji Raithatha
    38 De Montfort Street
    LE1 7GS Leicester
    Leicestershire
    practitioner
    38 De Montfort Street
    LE1 7GS Leicester
    Leicestershire
    2
    DateType
    03 juin 2013Commencement of winding up
    19 oct. 2019Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Situl Devji Raithatha
    38 De Montfort Street
    LE1 7GS Leicester
    Leicestershire
    practitioner
    38 De Montfort Street
    LE1 7GS Leicester
    Leicestershire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0