NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED

NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01148045
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?

    • Développement de logiciels professionnels et grand public (62012) / Information et communication

    Où se situe NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8th Floor Mander House
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PRESS COMPUTER SYSTEMS LIMITED28 nov. 197328 nov. 1973

    Quels sont les derniers comptes de NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au09 mai 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation23 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au09 mai 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 30 déc. 2023

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 mai 2024 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Change of company name 28/03/2024
    RES13

    Certificat de changement de nom

    Company name changed press computer systems LIMITED\certificate issued on 07/04/24
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name07 avr. 2024

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business 17/01/2024
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    13 pagesMA

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Changement d'adresse du siège social de 51-53 Queen Street Wolverhampton West Midlands WV1 1ES à 8th Floor Mander House Mander Centre Wolverhampton WV1 3NH le 20 déc. 2023

    1 pagesAD01

    Nomination de Mrs Sheree Olivia Manning en tant qu'administrateur le 09 nov. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Douglas Easton en tant que secrétaire le 29 sept. 2023

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Simon Dale Weare en tant que directeur le 29 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Matthew James Whiles en tant que directeur le 29 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Matthew James Whiles en tant que secrétaire le 29 sept. 2023

    1 pagesTM02

    Notification de National World Publishing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 sept. 2023

    2 pagesPSC02

    Cessation de Claverley Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 sept. 2023

    1 pagesPSC07

    Nomination de Mr Mark Thomas Hollinshead en tant qu'administrateur le 29 sept. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David John Montgomery en tant qu'administrateur le 29 sept. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Edward Alexander Graham en tant que directeur le 29 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gareth Haydn Williams en tant que directeur le 29 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Phillip Anthony Inman en tant que directeur le 29 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2022

    28 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Graeme Peter Clifford en tant que directeur le 31 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Edward Alexander Graham le 01 déc. 2022

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EASTON, Douglas
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    Secrétaire
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    314489440001
    HOLLINSHEAD, Mark Thomas
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    Administrateur
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    ScotlandBritishDirector178356860001
    MANNING, Sheree Olivia
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    Administrateur
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    EnglandBritish,AustralianChief Financial Officer315878060001
    MONTGOMERY, David John
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    Administrateur
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    EnglandBritishDirector72116200002
    CROSS, Robert Maurice
    Hall End Lane
    Pattingham
    WV6 7BL Wolverhampton
    17
    West Midlands
    Great Britain
    Secrétaire
    Hall End Lane
    Pattingham
    WV6 7BL Wolverhampton
    17
    West Midlands
    Great Britain
    BritishDirector132289330001
    WARD, Michael Arnold Charles
    18 Queens Road
    WS5 3NF Walsall
    West Midlands
    Secrétaire
    18 Queens Road
    WS5 3NF Walsall
    West Midlands
    British32360190001
    WHILES, Matthew James
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Secrétaire
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    255298040001
    WILLIAMS, Gareth Haydn
    WV16
    Secrétaire
    WV16
    199102940001
    ALLATT, John David
    Lerida
    Haughton Lane
    TF11 8HW Shifnal
    Shropshire
    Administrateur
    Lerida
    Haughton Lane
    TF11 8HW Shifnal
    Shropshire
    BritishCompany Director1518610001
    BRIGGS, Sean Francis
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Administrateur
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishNon Executive Director200011590002
    BROWN, Steven John
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishGroup Ceo154185360001
    CLIFFORD, Graeme Peter
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Administrateur
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishManaging Director86723850002
    COWARD, Christopher Vincent
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Administrateur
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishManagement Consultant67532460003
    CROSS, Robert Maurice
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Administrateur
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishGroup Finance Director132289330001
    DZIUBA, Stanislaw
    10 Lindy Close
    Kinoulton
    NG12 3RD Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    10 Lindy Close
    Kinoulton
    NG12 3RD Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompany Director141766580001
    EVERS, Graham William
    Bluntington
    Chaddesley Corbett
    DY10 4QL Kidderminster
    The Pound Cottage
    Worcestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Bluntington
    Chaddesley Corbett
    DY10 4QL Kidderminster
    The Pound Cottage
    Worcestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector1518570006
    GRAHAM, Edward Alexander
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    England
    EnglandBritishNew Media Executive174816060004
    GRAHAM, Eric Alan
    Le Formentor
    Avenue Princess Grace
    MONACO Monte Carlo
    Monaco
    Administrateur
    Le Formentor
    Avenue Princess Grace
    MONACO Monte Carlo
    Monaco
    FranceBritishCompany Director1625250001
    HEDGES, Jeremy John Russell
    135 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SJ Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    135 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SJ Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director28691210001
    HILL, Lawrence John
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishCommercial Director45659290001
    INMAN, Phillip Anthony
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Administrateur
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishGroup Chief Executive245426860001
    LINES, Robert Andrew
    41 Hall End Lane
    Pattingham
    WV6 7BN Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    41 Hall End Lane
    Pattingham
    WV6 7BN Wolverhampton
    West Midlands
    BritishDirector45844110002
    LLOYD, Hannah Jane Madge
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Administrateur
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishMarketing Director254149010001
    MEIER, Paul Stryker
    Eastham Park Farm
    Eastham
    WR15 8NN Tenbury Wells
    Worcestershire
    Administrateur
    Eastham Park Farm
    Eastham
    WR15 8NN Tenbury Wells
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director14112590002
    MILLER, David Jenkin
    Madehurst Road
    Madehurst
    BN18 0NU Arundel
    Court Cottage
    West Sussex
    England
    Administrateur
    Madehurst Road
    Madehurst
    BN18 0NU Arundel
    Court Cottage
    West Sussex
    England
    United KingdomBritishDirector105300820003
    MUNFORD, Margaret
    Rivendell
    Lower Penkridge Road, Acton Trussell
    ST17 0RJ Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    Rivendell
    Lower Penkridge Road, Acton Trussell
    ST17 0RJ Stafford
    Staffordshire
    BritishCompany Director32866370002
    READ, Mark
    Greystoke Drive
    DY6 8DX Kingswinford
    1
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Greystoke Drive
    DY6 8DX Kingswinford
    1
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishSales Director127443910001
    SMITH, Iain Mcfarlan
    Plantation View
    Silsoe
    MK45 4GG Bedford
    18
    England
    Administrateur
    Plantation View
    Silsoe
    MK45 4GG Bedford
    18
    England
    BritainBritishSales Director194887680002
    WALKER, Philip
    Stafford Road
    TF10 7LZ Newport
    23
    Salop
    United Kingdom
    Administrateur
    Stafford Road
    TF10 7LZ Newport
    23
    Salop
    United Kingdom
    United KingdomBritishTechnical Director101833800001
    WARD, Michael Arnold Charles
    18 Queens Road
    WS5 3NF Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    18 Queens Road
    WS5 3NF Walsall
    West Midlands
    BritishDirector32360190001
    WEARE, Simon Dale
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Administrateur
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    United KingdomBritishDevelopment Director254132730001
    WHILES, Matthew James
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Administrateur
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishOperations Director251451970001
    WILLIAMS, Gareth Haydn
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Administrateur
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishOperations Director196992700002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    National World Publishing Limited
    Joseph's Well
    Hanover Walk
    LS3 1AB Leeds
    Suite E3
    United Kingdom
    29 sept. 2023
    Joseph's Well
    Hanover Walk
    LS3 1AB Leeds
    Suite E3
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleEnglish
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies For England And Wales
    Numéro d'enregistrement11499982
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Claverley Group Limited
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    England
    06 avr. 2016
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUk Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Register Of Companies For England And Wales
    Numéro d'enregistrement05213110
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 25 juin 2019
    Livré le 25 juin 2019
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 déc. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 15 mai 2019
    Livré le 16 mai 2019
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 16 mai 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 déc. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 déc. 2009
    Livré le 04 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 févr. 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    Limited debenture
    Créé le 31 août 2007
    Livré le 12 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Star Group Pension Scheme and Includes the Trustees Thereof for the Timebeing
    Transactions
    • 12 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Limited debenture
    Créé le 31 août 2007
    Livré le 12 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Star Executive Pension Scheme and Includes the Trustees Thereof for Thetime Being
    Transactions
    • 12 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 août 2007
    Livré le 06 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 27 avr. 1992
    Livré le 06 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £800,000 and all other moneys due or to brcome due from the company to midland news association limited under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Freehold property situate and known as roman house ,newport road, albrighton ,shropshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland News Association Limited
    Transactions
    • 06 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0