NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01148045 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?
Adresse du siège social | 8th Floor Mander House Mander Centre WV1 3NH Wolverhampton England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 mai 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 23 mai 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 mai 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 30 déc. 2023 | 29 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 mai 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed press computer systems LIMITED\certificate issued on 07/04/24 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Statuts | 13 pages | MA | ||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 51-53 Queen Street Wolverhampton West Midlands WV1 1ES à 8th Floor Mander House Mander Centre Wolverhampton WV1 3NH le 20 déc. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Nomination de Mrs Sheree Olivia Manning en tant qu'administrateur le 09 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Douglas Easton en tant que secrétaire le 29 sept. 2023 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Dale Weare en tant que directeur le 29 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew James Whiles en tant que directeur le 29 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew James Whiles en tant que secrétaire le 29 sept. 2023 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Notification de National World Publishing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 sept. 2023 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Claverley Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 sept. 2023 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Mark Thomas Hollinshead en tant qu'administrateur le 29 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr David John Montgomery en tant qu'administrateur le 29 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Edward Alexander Graham en tant que directeur le 29 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Gareth Haydn Williams en tant que directeur le 29 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Phillip Anthony Inman en tant que directeur le 29 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2022 | 28 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Graeme Peter Clifford en tant que directeur le 31 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Edward Alexander Graham le 01 déc. 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASTON, Douglas | Secrétaire | Mander Centre WV1 3NH Wolverhampton 8th Floor Mander House England | 314489440001 | |||||||
HOLLINSHEAD, Mark Thomas | Administrateur | Mander Centre WV1 3NH Wolverhampton 8th Floor Mander House England | Scotland | British | Director | 178356860001 | ||||
MANNING, Sheree Olivia | Administrateur | Mander Centre WV1 3NH Wolverhampton 8th Floor Mander House England | England | British,Australian | Chief Financial Officer | 315878060001 | ||||
MONTGOMERY, David John | Administrateur | Mander Centre WV1 3NH Wolverhampton 8th Floor Mander House England | England | British | Director | 72116200002 | ||||
CROSS, Robert Maurice | Secrétaire | Hall End Lane Pattingham WV6 7BL Wolverhampton 17 West Midlands Great Britain | British | Director | 132289330001 | |||||
WARD, Michael Arnold Charles | Secrétaire | 18 Queens Road WS5 3NF Walsall West Midlands | British | 32360190001 | ||||||
WHILES, Matthew James | Secrétaire | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands | 255298040001 | |||||||
WILLIAMS, Gareth Haydn | Secrétaire | WV16 | 199102940001 | |||||||
ALLATT, John David | Administrateur | Lerida Haughton Lane TF11 8HW Shifnal Shropshire | British | Company Director | 1518610001 | |||||
BRIGGS, Sean Francis | Administrateur | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands | England | British | Non Executive Director | 200011590002 | ||||
BROWN, Steven John | Administrateur | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands England | United Kingdom | British | Group Ceo | 154185360001 | ||||
CLIFFORD, Graeme Peter | Administrateur | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands | England | British | Managing Director | 86723850002 | ||||
COWARD, Christopher Vincent | Administrateur | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands | England | British | Management Consultant | 67532460003 | ||||
CROSS, Robert Maurice | Administrateur | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands | England | British | Group Finance Director | 132289330001 | ||||
DZIUBA, Stanislaw | Administrateur | 10 Lindy Close Kinoulton NG12 3RD Nottingham Nottinghamshire | England | British | Company Director | 141766580001 | ||||
EVERS, Graham William | Administrateur | Bluntington Chaddesley Corbett DY10 4QL Kidderminster The Pound Cottage Worcestershire United Kingdom | England | British | Director | 1518570006 | ||||
GRAHAM, Edward Alexander | Administrateur | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands England | England | British | New Media Executive | 174816060004 | ||||
GRAHAM, Eric Alan | Administrateur | Le Formentor Avenue Princess Grace MONACO Monte Carlo Monaco | France | British | Company Director | 1625250001 | ||||
HEDGES, Jeremy John Russell | Administrateur | 135 Hyperion Road Stourton DY7 6SJ Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 28691210001 | ||||
HILL, Lawrence John | Administrateur | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands England | United Kingdom | British | Commercial Director | 45659290001 | ||||
INMAN, Phillip Anthony | Administrateur | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands | England | British | Group Chief Executive | 245426860001 | ||||
LINES, Robert Andrew | Administrateur | 41 Hall End Lane Pattingham WV6 7BN Wolverhampton West Midlands | British | Director | 45844110002 | |||||
LLOYD, Hannah Jane Madge | Administrateur | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands | England | British | Marketing Director | 254149010001 | ||||
MEIER, Paul Stryker | Administrateur | Eastham Park Farm Eastham WR15 8NN Tenbury Wells Worcestershire | England | British | Company Director | 14112590002 | ||||
MILLER, David Jenkin | Administrateur | Madehurst Road Madehurst BN18 0NU Arundel Court Cottage West Sussex England | United Kingdom | British | Director | 105300820003 | ||||
MUNFORD, Margaret | Administrateur | Rivendell Lower Penkridge Road, Acton Trussell ST17 0RJ Stafford Staffordshire | British | Company Director | 32866370002 | |||||
READ, Mark | Administrateur | Greystoke Drive DY6 8DX Kingswinford 1 West Midlands England | United Kingdom | British | Sales Director | 127443910001 | ||||
SMITH, Iain Mcfarlan | Administrateur | Plantation View Silsoe MK45 4GG Bedford 18 England | Britain | British | Sales Director | 194887680002 | ||||
WALKER, Philip | Administrateur | Stafford Road TF10 7LZ Newport 23 Salop United Kingdom | United Kingdom | British | Technical Director | 101833800001 | ||||
WARD, Michael Arnold Charles | Administrateur | 18 Queens Road WS5 3NF Walsall West Midlands | British | Director | 32360190001 | |||||
WEARE, Simon Dale | Administrateur | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands | United Kingdom | British | Development Director | 254132730001 | ||||
WHILES, Matthew James | Administrateur | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands | England | British | Operations Director | 251451970001 | ||||
WILLIAMS, Gareth Haydn | Administrateur | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 West Midlands | England | British | Operations Director | 196992700002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National World Publishing Limited | 29 sept. 2023 | Joseph's Well Hanover Walk LS3 1AB Leeds Suite E3 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Claverley Group Limited | 06 avr. 2016 | Queen Street WV1 1ES Wolverhampton 51-53 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 25 juin 2019 Livré le 25 juin 2019 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 15 mai 2019 Livré le 16 mai 2019 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 23 déc. 2009 Livré le 04 janv. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Limited debenture | Créé le 31 août 2007 Livré le 12 sept. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Limited debenture | Créé le 31 août 2007 Livré le 12 sept. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 31 août 2007 Livré le 06 sept. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 27 avr. 1992 Livré le 06 mai 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £800,000 and all other moneys due or to brcome due from the company to midland news association limited under the terms of the charge. | |
Brèves mentions Freehold property situate and known as roman house ,newport road, albrighton ,shropshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0