PARKMAN CONSULTING ENGINEERS
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PARKMAN CONSULTING ENGINEERS |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
| Numéro de société | 01148668 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PARKMAN CONSULTING ENGINEERS ?
| Adresse du siège social | Tempsford Hall Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire Great Britain |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PARKMAN CONSULTING ENGINEERS ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2006 |
Quels sont les derniers dépôts pour PARKMAN CONSULTING ENGINEERS ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 10 mai 2017
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Bethan Melges le 08 déc. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anoop Kang en tant que directeur le 21 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Lee Foreman en tant qu'administrateur le 21 déc. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Giles Stewart Pearson en tant que directeur le 26 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Bethan Melges en tant qu'administrateur le 26 févr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Anoop Kang en tant qu'administrateur le 26 févr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Export House Cawsey Way Woking Surrey GU21 6QX à Tempsford Hall Tempsford Hall Sandy Bedfordshire SG19 2BD le 16 oct. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Adrian Rayner en tant que directeur le 08 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul England en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Giles Stewart Pearson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Amanda Massie en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Amanda Massie en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Adrian Rayner en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PARKMAN CONSULTING ENGINEERS ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREMAN, Thomas Lee | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | 221070030001 | |||||
| MELGES, Bethan Anne Elizabeth | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | 199583330002 | |||||
| ENGMANN, Catherine | Secrétaire | 11 Tudor Way SL4 5LT Windsor Berkshire | British | 92722710004 | ||||||
| HAMES, Victoria Elizabeth | Secrétaire | Flat 5 70 Elmbourne Road SW17 8JJ London | British | 102613150001 | ||||||
| LEE, Kelly | Secrétaire | Friars Stile Place TW10 6NL Richmond 6 Surrey United Kingdom | British | 138708240001 | ||||||
| MASSIE, Amanda Jane Emilia | Secrétaire | Bradlow Sandy Lane GU3 1HF Guildford Surrey | British | 36957420004 | ||||||
| PREECE, Richard Alec | Secrétaire | 3 Moorings Close Parkgate CH64 6TL South Wirral | British | 7353920001 | ||||||
| SHAW, Christine | Secrétaire | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | 164623930001 | |||||||
| SJOGREN, Carl | Secrétaire | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | 153647840001 | |||||||
| BOND, Eric | Administrateur | Henfold 120 Henfold Road Astley M29 7EX Manchester Lancashire | British | 11646690001 | ||||||
| CLEVERLY, Graham | Administrateur | Claremont 68 Tarvin Road CH3 7DF Chester Cheshire | United Kingdom | British | 86693320001 | |||||
| EAKIN, William Robert George | Administrateur | Stainton Firs Tower Road North Heswall L60 6RS Wirral Merseyside | British | 76548530001 | ||||||
| ENGLAND, Paul David | Administrateur | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | England | British | 153205540001 | |||||
| HANDLEY, John | Administrateur | Brook Cottage Brinsea Batch, Congresbury BS49 5JP Bristol | British | 97439420001 | ||||||
| HAYES, Brian | Administrateur | 1 Woodbank Hall Cottage Shotwick Lane CH1 6HY Woodbank Chester | British | 36639460001 | ||||||
| KANG, Anoop | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | 198683900001 | |||||
| KILNER, Robert Graham | Administrateur | 11 The Limes Culcheth WA3 4HE Warrington Cheshire | British | 11487410002 | ||||||
| LLOYD, Michael John | Administrateur | 45 Hough Green CH4 8JW Chester | British | 12243520001 | ||||||
| MASSIE, Amanda Jane Emilia | Administrateur | Bradlow Sandy Lane GU3 1HF Guildford Surrey | United Kingdom | British | 36957420004 | |||||
| NOTT, Nigel Alfred | Administrateur | 19 Shoscombe BA2 8LS Bath | England | British | 11646680001 | |||||
| OGDEN, David William | Administrateur | 16 Elm Drive Greasby CH49 3NP Wirral Merseyside | British | 30192420001 | ||||||
| PARKMAN, Hugh Charles | Administrateur | 38 East Saint Helen Street OX14 5EB Abingdon Oxfordshire | British | 11486420002 | ||||||
| PEARSON, Giles Stewart | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | United Kingdom | British | 180473890001 | |||||
| PREECE, Richard Alec | Administrateur | 20 Mereworth Caldy CH48 1QT Wirral | British | 7353920002 | ||||||
| RAYNER, Paul Adrian | Administrateur | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 45628680002 | |||||
| TALLIS, John Amos | Administrateur | Foye Cottage School Bank Norley WA6 8NP Warrington Cheshire | British | 16563370001 | ||||||
| TOMLINSON, David | Administrateur | Arden 33 Cambridge Road BS21 7DN Clevedon North Somerset | England | British | 31228190001 | |||||
| YOUNG, Kevin Andrew | Administrateur | 35 Dean Close GU22 8NX Pyrford Surrey | England | British | 102706960001 |
PARKMAN CONSULTING ENGINEERS a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Further guarantee and debenture | Créé le 14 août 1981 Livré le 25 août 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on on any account whatsoever. | |
Brèves mentions All that property, undertaking and assets charged by the principal deed and further deeds. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture | Créé le 12 août 1980 Livré le 18 août 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the parkman holdings limited to the chargee | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the goodwill, bookdebts buildings, fixtures, fixed plant and machinery (sec doc M17). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Further guarantee & debenture | Créé le 09 mai 1979 Livré le 21 mai 1979 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions All that property undertaking assets charged by the principal deed & further deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 01 août 1977 Livré le 22 août 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H 49 wilson patten street, warrington, cheshire. Title no. Ch 111456. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Further guarantee & debenture | Créé le 17 déc. 1975 Livré le 06 janv. 1976 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other company named therein. To the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 13 nov. 1975 Livré le 24 nov. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or parkman holdings limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions First fixed and floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. (See doc 12). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0