PARKMAN CONSULTING ENGINEERS

PARKMAN CONSULTING ENGINEERS

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARKMAN CONSULTING ENGINEERS
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 01148668
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARKMAN CONSULTING ENGINEERS ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe PARKMAN CONSULTING ENGINEERS ?

    Adresse du siège social
    Tempsford Hall
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Bedfordshire
    Great Britain
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PARKMAN CONSULTING ENGINEERS ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WARD,ASHCROFT AND PARKMAN30 nov. 197330 nov. 1973

    Quels sont les derniers comptes de PARKMAN CONSULTING ENGINEERS ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour PARKMAN CONSULTING ENGINEERS ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 10 mai 2017

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Bethan Melges le 08 déc. 2016

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Anoop Kang en tant que directeur le 21 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Thomas Lee Foreman en tant qu'administrateur le 21 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 juin 2016

    État du capital au 27 juin 2016

    • Capital: GBP 96,011
    SH01

    Cessation de la nomination de Giles Stewart Pearson en tant que directeur le 26 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Bethan Melges en tant qu'administrateur le 26 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Anoop Kang en tant qu'administrateur le 26 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Export House Cawsey Way Woking Surrey GU21 6QX à Tempsford Hall Tempsford Hall Sandy Bedfordshire SG19 2BD le 16 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juil. 2015

    État du capital au 16 juil. 2015

    • Capital: GBP 96,011
    SH01

    Cessation de la nomination de Paul Adrian Rayner en tant que directeur le 08 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 août 2014

    État du capital au 18 août 2014

    • Capital: GBP 96,011
    SH01

    Cessation de la nomination de Paul England en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Giles Stewart Pearson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 juin 2013

    État du capital au 24 juin 2013

    • Capital: GBP 96,011
    SH01

    Cessation de la nomination de Amanda Massie en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Amanda Massie en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Paul Adrian Rayner en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de PARKMAN CONSULTING ENGINEERS ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FOREMAN, Thomas Lee
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    Administrateur
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    EnglandBritish221070030001
    MELGES, Bethan Anne Elizabeth
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    Administrateur
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    EnglandBritish199583330002
    ENGMANN, Catherine
    11 Tudor Way
    SL4 5LT Windsor
    Berkshire
    Secrétaire
    11 Tudor Way
    SL4 5LT Windsor
    Berkshire
    British92722710004
    HAMES, Victoria Elizabeth
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    Secrétaire
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    British102613150001
    LEE, Kelly
    Friars Stile Place
    TW10 6NL Richmond
    6
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Friars Stile Place
    TW10 6NL Richmond
    6
    Surrey
    United Kingdom
    British138708240001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    British36957420004
    PREECE, Richard Alec
    3 Moorings Close
    Parkgate
    CH64 6TL South Wirral
    Secrétaire
    3 Moorings Close
    Parkgate
    CH64 6TL South Wirral
    British7353920001
    SHAW, Christine
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    164623930001
    SJOGREN, Carl
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    153647840001
    BOND, Eric
    Henfold 120 Henfold Road
    Astley
    M29 7EX Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    Henfold 120 Henfold Road
    Astley
    M29 7EX Manchester
    Lancashire
    British11646690001
    CLEVERLY, Graham
    Claremont
    68 Tarvin Road
    CH3 7DF Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Claremont
    68 Tarvin Road
    CH3 7DF Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish86693320001
    EAKIN, William Robert George
    Stainton Firs Tower Road North
    Heswall
    L60 6RS Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    Stainton Firs Tower Road North
    Heswall
    L60 6RS Wirral
    Merseyside
    British76548530001
    ENGLAND, Paul David
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish153205540001
    HANDLEY, John
    Brook Cottage
    Brinsea Batch, Congresbury
    BS49 5JP Bristol
    Administrateur
    Brook Cottage
    Brinsea Batch, Congresbury
    BS49 5JP Bristol
    British97439420001
    HAYES, Brian
    1 Woodbank Hall Cottage
    Shotwick Lane
    CH1 6HY Woodbank
    Chester
    Administrateur
    1 Woodbank Hall Cottage
    Shotwick Lane
    CH1 6HY Woodbank
    Chester
    British36639460001
    KANG, Anoop
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    Administrateur
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    EnglandBritish198683900001
    KILNER, Robert Graham
    11 The Limes
    Culcheth
    WA3 4HE Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    11 The Limes
    Culcheth
    WA3 4HE Warrington
    Cheshire
    British11487410002
    LLOYD, Michael John
    45 Hough Green
    CH4 8JW Chester
    Administrateur
    45 Hough Green
    CH4 8JW Chester
    British12243520001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish36957420004
    NOTT, Nigel Alfred
    19 Shoscombe
    BA2 8LS Bath
    Administrateur
    19 Shoscombe
    BA2 8LS Bath
    EnglandBritish11646680001
    OGDEN, David William
    16 Elm Drive
    Greasby
    CH49 3NP Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    16 Elm Drive
    Greasby
    CH49 3NP Wirral
    Merseyside
    British30192420001
    PARKMAN, Hugh Charles
    38 East Saint Helen Street
    OX14 5EB Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    38 East Saint Helen Street
    OX14 5EB Abingdon
    Oxfordshire
    British11486420002
    PEARSON, Giles Stewart
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    Administrateur
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    United KingdomBritish180473890001
    PREECE, Richard Alec
    20 Mereworth
    Caldy
    CH48 1QT Wirral
    Administrateur
    20 Mereworth
    Caldy
    CH48 1QT Wirral
    British7353920002
    RAYNER, Paul Adrian
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish45628680002
    TALLIS, John Amos
    Foye Cottage School Bank
    Norley
    WA6 8NP Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    Foye Cottage School Bank
    Norley
    WA6 8NP Warrington
    Cheshire
    British16563370001
    TOMLINSON, David
    Arden 33 Cambridge Road
    BS21 7DN Clevedon
    North Somerset
    Administrateur
    Arden 33 Cambridge Road
    BS21 7DN Clevedon
    North Somerset
    EnglandBritish31228190001
    YOUNG, Kevin Andrew
    35 Dean Close
    GU22 8NX Pyrford
    Surrey
    Administrateur
    35 Dean Close
    GU22 8NX Pyrford
    Surrey
    EnglandBritish102706960001

    PARKMAN CONSULTING ENGINEERS a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Further guarantee and debenture
    Créé le 14 août 1981
    Livré le 25 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All that property, undertaking and assets charged by the principal deed and further deeds.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 1981Enregistrement d'une charge
    • 11 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 12 août 1980
    Livré le 18 août 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the parkman holdings limited to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the goodwill, bookdebts buildings, fixtures, fixed plant and machinery (sec doc M17). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Dr M A. Ismail
    Transactions
    • 18 août 1980Enregistrement d'une charge
    Further guarantee & debenture
    Créé le 09 mai 1979
    Livré le 21 mai 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All that property undertaking assets charged by the principal deed & further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 1979Enregistrement d'une charge
    • 11 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 août 1977
    Livré le 22 août 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 49 wilson patten street, warrington, cheshire. Title no. Ch 111456.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 août 1977Enregistrement d'une charge
    • 11 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee & debenture
    Créé le 17 déc. 1975
    Livré le 06 janv. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other company named therein. To the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 janv. 1976Enregistrement d'une charge
    • 11 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 13 nov. 1975
    Livré le 24 nov. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or parkman holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    First fixed and floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. (See doc 12).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 1975Enregistrement d'une charge
    • 11 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0