GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED

GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01148888
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED ?

    • Commerce de gros non spécialisé (46900) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Broadway
    Hyde
    SK14 4QF
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 août 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 mai 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au25 mars 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation08 avr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au25 mars 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 31 août 2023

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de David Bernard-Cuisinier en tant que directeur le 05 avr. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 août 2022

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2021

    23 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 août 2020

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Stephane Bernard Gigou en tant qu'administrateur le 18 mars 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Marie Helene Simone Feuillet en tant que directeur le 18 mars 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Francois Marie Feuillet en tant que directeur le 18 mars 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2019

    21 pagesAA

    Nomination de Mr David Bernard-Cuisinier en tant qu'administrateur le 19 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jerome Durand en tant que directeur le 16 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2018

    21 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 août 2017

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2016

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 avr. 2016

    État du capital au 18 avr. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 août 2015

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 mars 2015

    État du capital au 30 mars 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Qui sont les dirigeants de GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FREICHE, Michel
    Les Marchis
    Chanos Curson
    26600
    France
    Secrétaire
    Les Marchis
    Chanos Curson
    26600
    France
    FrenchCfo81010610001
    FREICHE, Michel
    Rue Petit
    Paris
    100
    75019
    France
    Administrateur
    Rue Petit
    Paris
    100
    75019
    France
    FranceFrenchManaging Director147770660001
    GIGOU, Stephane Bernard
    Broadway
    Hyde
    SK14 4QF
    Administrateur
    Broadway
    Hyde
    SK14 4QF
    FranceFrenchChair Person281280650001
    OWEN, Christine Edith
    12 Robins Close
    Bramhall
    SK7 2PF Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    12 Robins Close
    Bramhall
    SK7 2PF Stockport
    Cheshire
    British7658750001
    WELHAM, Anthony Frederick
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    BritishCertified Accountant21912090001
    YATES, John Martyn
    5 Melia Close
    BB4 6RQ Rossendale
    Lancashire
    Secrétaire
    5 Melia Close
    BB4 6RQ Rossendale
    Lancashire
    BritishSolicitor7608780001
    BERNARD-CUISINIER, David
    Broadway
    Hyde
    SK14 4QF
    Administrateur
    Broadway
    Hyde
    SK14 4QF
    FranceFrenchCompany Director260965170001
    BLUTH, Thomas
    289 Landines Blvd
    Weston
    33327
    Usa
    Administrateur
    289 Landines Blvd
    Weston
    33327
    Usa
    AmericanAttorney70476630001
    DAVIDSON, Bruce Wood Hardy
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector117111790001
    DAVIES, Carol Ann
    40 Meadows View
    Marford
    LL12 8LS Wrexham
    Clwyd
    Administrateur
    40 Meadows View
    Marford
    LL12 8LS Wrexham
    Clwyd
    BritishCompany Director7658770003
    DURAND, Jerome
    Chemin Du Brian
    Chavannes
    Chemin Du Brian
    26260
    France
    Administrateur
    Chemin Du Brian
    Chavannes
    Chemin Du Brian
    26260
    France
    FranceFrenchDirector134423070001
    FAWCETT, Michael Alan
    94 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    Administrateur
    94 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    BritishAccountant38913590002
    FEUILLET, Francois Marie
    Rue De Lubeck
    FOREIGN Paris
    38
    75116
    France
    Administrateur
    Rue De Lubeck
    FOREIGN Paris
    38
    75116
    France
    FranceFrenchDirector68087480002
    FEUILLET, Marie Helene Simone
    Rue De Lubeck
    FOREIGN Paris
    38
    75116
    France
    Administrateur
    Rue De Lubeck
    FOREIGN Paris
    38
    75116
    France
    FranceFrenchDirector81010520002
    FOX, Patrick Adam Charles
    30 Dorville Crescent
    W6 0HJ London
    Administrateur
    30 Dorville Crescent
    W6 0HJ London
    BritishCompany Director34607130001
    HALL, John Maddison
    The Granary Briery Hall Farm
    Chevet Lane
    WF2 6PT Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Granary Briery Hall Farm
    Chevet Lane
    WF2 6PT Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director61236690001
    HALL, John Maddison
    The Granary Briery Hall Farm
    Chevet Lane
    WF2 6PT Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Granary Briery Hall Farm
    Chevet Lane
    WF2 6PT Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector61236690001
    HERSH, Robert
    6700 Sw 88 Terrace
    Miami
    FOREIGN Florida
    33156
    United States
    Administrateur
    6700 Sw 88 Terrace
    Miami
    FOREIGN Florida
    33156
    United States
    United StatesExecutive72215110001
    MARBLE, Stephen Gerald
    10430 Sw 20 Street
    Davie
    Florida
    Fl33324
    Usa
    Administrateur
    10430 Sw 20 Street
    Davie
    Florida
    Fl33324
    Usa
    AmericanCfo86928580001
    OWEN, Christine Edith
    12 Robins Close
    Bramhall
    SK7 2PF Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    12 Robins Close
    Bramhall
    SK7 2PF Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Secretary7658750001
    OWEN, Christopher John
    197 Grove Lane
    Cheadle Hulme
    SK8 7NG Cheadle
    Cheshire
    Administrateur
    197 Grove Lane
    Cheadle Hulme
    SK8 7NG Cheadle
    Cheshire
    BritishCompany Director7658760002
    PRICE, William Anthony
    34 Lea Drive
    Shepley
    HD8 8HA Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    34 Lea Drive
    Shepley
    HD8 8HA Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director45498850001
    RAPPAPORT, Dean
    11988 Classic Drive
    Coral Springs
    Florida 33071
    Usa
    Administrateur
    11988 Classic Drive
    Coral Springs
    Florida 33071
    Usa
    AmericanExecutive71410030001
    RODNEY, Gary
    3101 Pierson Drive
    FLORIDA Delray Beach
    33483
    Usa
    Administrateur
    3101 Pierson Drive
    FLORIDA Delray Beach
    33483
    Usa
    AmericanDirector102721900001
    SASNETT, David Warren
    16254 S.W.67 Court
    Fort Lauderdale
    Florida 33331
    Usa
    Administrateur
    16254 S.W.67 Court
    Fort Lauderdale
    Florida 33331
    Usa
    AmericanAccountant76805900001
    SKILLEN, Robert Lynn
    Apt 510
    7345 Fairway Drive
    FOREIGN Miami Lakes
    Florida 33014
    United States
    Administrateur
    Apt 510
    7345 Fairway Drive
    FOREIGN Miami Lakes
    Florida 33014
    United States
    BritishCfo80493540001
    TOROSSIAN, Henri
    Costebelle Ii
    Saint Peray
    07130
    France
    Administrateur
    Costebelle Ii
    Saint Peray
    07130
    France
    FrenchDirector82005290001
    VARAKIAN, Robert
    17555 Collins Avenue Apt 1703
    FLORIDA Sunny Isles Beach
    33160
    America
    Administrateur
    17555 Collins Avenue Apt 1703
    FLORIDA Sunny Isles Beach
    33160
    America
    AmericanDirector102721240001
    WELHAM, Anthony Frederick
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCertified Accountant21912090001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Francois Marie Feuillet
    100 Rue Petit
    75165
    Paris
    Trigan
    Cedex 19
    France
    06 avr. 2016
    100 Rue Petit
    75165
    Paris
    Trigan
    Cedex 19
    France
    Non
    Nationalité: French
    Pays de résidence: France
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Trigano Sa
    Rue Petit
    75165
    Paris
    100
    Cedex 19
    France
    06 avr. 2016
    Rue Petit
    75165
    Paris
    100
    Cedex 19
    France
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementFrance
    Autorité légaleFrench Law
    Lieu d'enregistrementFrance
    Numéro d'enregistrement722049459
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 18 avr. 2005
    Livré le 25 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H land on the west side of broadway hyde t/no GM12514. By way of fixed charge all other property, all computer vehicles equipment, the benefit of all contracts, all charges securities, the security accounts, the intellectual property and all the goodwill and uncalled capital. Assigns the relevant contracts, the insurances, the security accounts and all receivables. Floating charge all assets and undertaking and heritable property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture (supplementing and amending a guarantee and debenture dated 23 december 2003)
    Créé le 23 déc. 2004
    Livré le 04 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the blocked accounts, book debts,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Congress Financial Corporation (Florida) as Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders
    Transactions
    • 04 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 23 déc. 2003
    Livré le 24 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Congress Financial Corporation (Florida) (the Agent) as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Lenders
    Transactions
    • 24 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Loan and security agreement
    Créé le 23 déc. 2003
    Livré le 09 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any or all of borrowers to agent or any lender and/or any of their affiliates under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The collateral being all accounts all general intangibles including without limitation all intellectual property all goods all real property and fixtures all chattel paper all instruments all documents and all deposit accounts * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Congress Financial Corporation (Florida), in Its Capacity as Agent for Lenders (the Agent)
    Transactions
    • 09 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 mai 2002
    Livré le 14 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilites due owing or incurred by each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The leasehold property known as marlborough works marlborough road accrington england BB5 5BE title number LA858360. Freehold property known as beza road hunslet leeds england LS10 2BR title number WYK569370. The leasehold property known as broadway broadway industrial estate hyde greater manchester SK14 5BE title number GM12514. For further details of properties charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Suntrust Bank as Trustee and Agent for the Banks
    Transactions
    • 14 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 18 août 2000
    Livré le 01 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilites due owing or incurred by each obligor to the chargee under or in connection with the facilities or any document given as security therefor by any such obligor on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Suntrust Bank as Trustee and Agent for the Banks (As Defined) ("Administrative Agent")
    Transactions
    • 01 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 nov. 1998
    Livré le 12 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 15 nov. 1996
    Livré le 22 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 nov. 1996
    Livré le 20 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 19 déc. 1995
    Livré le 20 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 20 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 28 sept. 1995
    Livré le 30 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Factors Limited
    Transactions
    • 30 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed equitable charge
    Créé le 28 sept. 1995
    Livré le 30 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts invoice debts accounts,notes bills,acceptances and/or other forms of obligation the subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Factors Limited
    Transactions
    • 30 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 27 mai 1988
    Livré le 08 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all the book and other debts floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 19 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mai 1985
    Livré le 10 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and a legal mortgage over unit 4, pottinger street, ashton-u-lyne. Tameside OL7 0PS greater manchester title no la 265114 and/or the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 mai 1985Enregistrement d'une charge
    • 27 nov. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 30 nov. 1982
    Livré le 03 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge or all book & other debts with a floating charge on undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. (Please see-doc M21).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 03 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 22 août 1980
    Livré le 28 août 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £60,000
    Brèves mentions
    Unit 4, pottinger street, ashton-under-lyne, greater manchester. Title no:- LA265114.
    Personnes ayant droit
    • Sun Life Assurance Society Limited.
    Transactions
    • 28 août 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0