PNEUPAC LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPNEUPAC LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01148992
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PNEUPAC LIMITED ?

    • usinage (25620) / Industries manufacturières

    Où se situe PNEUPAC LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1500 Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    Kent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PNEUPAC LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SIMS PNEUPAC LIMITED17 nov. 199717 nov. 1997
    PNEUPAC LIMITED03 déc. 197303 déc. 1973

    Quels sont les derniers comptes de PNEUPAC LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour PNEUPAC LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    État du capital au 19 avr. 2023

    • Capital: GBP 0.50
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Deloitte Llp 2 New Street Square London EC4A 3BZ United Kingdom à Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF

    1 pagesAD02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2021

    3 pagesAA

    Nomination de Brian Bonnell en tant qu'administrateur le 25 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Ramon De Ridder en tant qu'administrateur le 25 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Cornelis De Rooij en tant qu'administrateur le 25 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Miss Jasmine Annabelle Cleaver en tant que secrétaire le 30 sept. 2021

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Joanne Ede en tant que secrétaire le 30 sept. 2021

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2020

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Eversheds Llp, Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES England à Deloitte Llp 2 New Street Square London EC4A 3BZ

    1 pagesAD02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2019

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2018

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PNEUPAC LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLEAVER, Jasmine Annabelle
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    Secrétaire
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    288430580001
    BARK, Nigel John
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    United Kingdom
    Administrateur
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    United Kingdom
    United KingdomBritishVice President Sales, Emea170963820001
    BONNELL, Brian
    Calle Amanecer
    San Clemente
    951
    California
    United States
    Administrateur
    Calle Amanecer
    San Clemente
    951
    California
    United States
    United StatesAmericanBusinessman291877250001
    DE RIDDER, Ramon
    Hofspoor
    3994 Vz
    Houten
    3
    Netherlands
    Administrateur
    Hofspoor
    3994 Vz
    Houten
    3
    Netherlands
    NetherlandsDutchBusiness Executive291361500001
    DE ROOIJ, Cornelis
    Hofspoor
    3994 Vz
    Houten
    3
    Netherlands
    Administrateur
    Hofspoor
    3994 Vz
    Houten
    3
    Netherlands
    NetherlandsDutchBusiness Executive291876980001
    JONES, Louis Philip
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    United Kingdom
    Administrateur
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director209239660001
    BENNETT, Roisin
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    Other137268090001
    BURDETT, Neil Robert
    765 Finchley Road
    NW11 8DS London
    Secrétaire
    765 Finchley Road
    NW11 8DS London
    British188620003
    CARTER, Brian Sydney
    17 Exenden Park Drive
    CT6 8UB Herne Bay
    Kent
    Secrétaire
    17 Exenden Park Drive
    CT6 8UB Herne Bay
    Kent
    British4836800001
    EDE, Joanne
    1500 Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    Smiths Medical International Limited
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    1500 Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    Smiths Medical International Limited
    Kent
    United Kingdom
    203676310001
    KENTISH, Barry
    3 Derwent Drive
    LU6 3PB Dunstable
    Bedfordshire
    Secrétaire
    3 Derwent Drive
    LU6 3PB Dunstable
    Bedfordshire
    BritishAccountant33208630001
    SMITH, Alan
    37 Pattison Road
    NW2 2HL London
    Secrétaire
    37 Pattison Road
    NW2 2HL London
    British32394380001
    BATTERSBY, Paul
    7 Botany Close
    BN16 2BH Rustington
    West Sussex
    Administrateur
    7 Botany Close
    BN16 2BH Rustington
    West Sussex
    BritishDirector32410170002
    BENNETT, Roisin
    WD24 4LG Watford
    Colonial Way
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    WD24 4LG Watford
    Colonial Way
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSecretary150353170001
    BROAD, Donald Andrew Robertson
    Floor
    Cardinal Place 80 Victoria Street
    SW1E 5JL London
    2nd
    Administrateur
    Floor
    Cardinal Place 80 Victoria Street
    SW1E 5JL London
    2nd
    United KingdomBritishChartered Accountant46824520004
    CARLISLE, Malcolm John Calder Glen
    1 Jessica Road
    SW18 2QL London
    Administrateur
    1 Jessica Road
    SW18 2QL London
    United KingdomBritishBarrister21835030001
    DAVEY-TURNER, Geoffrey Edward
    The Manor House
    OX17 2BB Culworth
    Northants
    Administrateur
    The Manor House
    OX17 2BB Culworth
    Northants
    BritishEngineer4836820001
    DUNSMORE, Alan David
    The Studio House 113 Bridge Street
    Wye
    TN25 5ED Ashford
    Kent
    Administrateur
    The Studio House 113 Bridge Street
    Wye
    TN25 5ED Ashford
    Kent
    BritishChartered Accountant57416420002
    EGGLESTON, Steven Andrew
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director150302530002
    FLACK, Paul Anthony
    4 Wellington House
    51 Seabrook Road
    CT21 5QB Hythe
    Kent
    Administrateur
    4 Wellington House
    51 Seabrook Road
    CT21 5QB Hythe
    Kent
    BritishDirector26551520002
    HARDY, Suzanne Ruth
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    United Kingdom
    Administrateur
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director171577960001
    IRELAND, Robert
    Waverley
    Southview Road
    GU35 8HX Headley Down
    Hampshire
    Administrateur
    Waverley
    Southview Road
    GU35 8HX Headley Down
    Hampshire
    EnglandBritishDirector88177570001
    JAMIESON, Martin Clive
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    Uk
    Administrateur
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    Uk
    BritishDirector42951230008
    JAYNE, Kimberley Anne
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    Administrateur
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United KingdomBritishSales Director228156580001
    JONES, Norman Stewart
    46 Station Road
    Ivinghoe
    LU7 9EB Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    46 Station Road
    Ivinghoe
    LU7 9EB Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishEngineer4836830001
    KENNEDY, George Macdonald
    Deepwell House
    Maidstone Road, Chilham
    CT4 8DB Canterbury
    Kent
    Administrateur
    Deepwell House
    Maidstone Road, Chilham
    CT4 8DB Canterbury
    Kent
    EnglandBritishDirector14451190006
    KOCKOTT, John Douglas
    Oaktree Barn Brookley Farm
    Sway Road
    SO42 7RX Brockenhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Oaktree Barn Brookley Farm
    Sway Road
    SO42 7RX Brockenhurst
    Hampshire
    South AfricanDirector29991160001
    O'BRIEN, Susan Lynn
    180 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AQ Waltham Cross
    Hertfordshire
    Administrateur
    180 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AQ Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant123851410001
    PENN, David Alfred
    2 Salmons Lane
    Middleton Cheney
    OX17 2NF Banbury
    Oxon
    Administrateur
    2 Salmons Lane
    Middleton Cheney
    OX17 2NF Banbury
    Oxon
    EnglandBritishChartered Secretary64115230001
    SASSONE, Matthew Giovanni
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director156019710001
    SIMPSON, Jeremy John Cobbett
    765 Finchley Road
    NW11 8DS London
    Administrateur
    765 Finchley Road
    NW11 8DS London
    BritishChartered Accountant83467360003
    SPEAKMAN, Michael James
    HP13
    Administrateur
    HP13
    United KingdomBritishAccountant88515760001
    SURCH, Christopher
    765 Finchley Road
    NW11 8DS London
    Administrateur
    765 Finchley Road
    NW11 8DS London
    BritishFinance Director97578250002
    WEISS, George
    40 New End Square
    NW3 1LS London
    Administrateur
    40 New End Square
    NW3 1LS London
    BritishEngineer4836810002
    WHITE, Robert
    Zircon Lane North
    55447 Plymouth
    3105
    Minnesota
    Administrateur
    Zircon Lane North
    55447 Plymouth
    3105
    Minnesota
    BritishVp Finance139191600001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PNEUPAC LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00362847
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PNEUPAC LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 21 mai 1996
    Livré le 29 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 avr. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed
    Créé le 24 août 1981
    Livré le 25 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Together with fixed parts machinery and fixtures incl trade fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Instruments & Movements Limited
    Transactions
    • 25 août 1981Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee & debenture
    Créé le 28 mars 1977
    Livré le 15 avr. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 avr. 1977Enregistrement d'une charge
    • 24 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 19 déc. 1974
    Livré le 02 janv. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first fixed and floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. Fixtures fixed plant and machinery. (See doc 8).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 janv. 1975Enregistrement d'une charge
    • 10 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 09 sept. 1974
    Livré le 16 sept. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of a floating charge tog with plant machinery fixtures implements and utensils. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 1974Enregistrement d'une charge
    • 24 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0