PNEUPAC LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PNEUPAC LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01148992 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PNEUPAC LIMITED ?
Adresse du siège social | 1500 Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford Kent |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PNEUPAC LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 juil. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour PNEUPAC LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
État du capital au 19 avr. 2023
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 4 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Deloitte Llp 2 New Street Square London EC4A 3BZ United Kingdom à Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2021 | 3 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Brian Bonnell en tant qu'administrateur le 25 janv. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ramon De Ridder en tant qu'administrateur le 25 janv. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Cornelis De Rooij en tant qu'administrateur le 25 janv. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Miss Jasmine Annabelle Cleaver en tant que secrétaire le 30 sept. 2021 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joanne Ede en tant que secrétaire le 30 sept. 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2020 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Eversheds Llp, Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES England à Deloitte Llp 2 New Street Square London EC4A 3BZ | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2019 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2018 | 3 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PNEUPAC LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEAVER, Jasmine Annabelle | Secrétaire | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent | 288430580001 | |||||||
BARK, Nigel John | Administrateur | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 United Kingdom | United Kingdom | British | Vice President Sales, Emea | 170963820001 | ||||
BONNELL, Brian | Administrateur | Calle Amanecer San Clemente 951 California United States | United States | American | Businessman | 291877250001 | ||||
DE RIDDER, Ramon | Administrateur | Hofspoor 3994 Vz Houten 3 Netherlands | Netherlands | Dutch | Business Executive | 291361500001 | ||||
DE ROOIJ, Cornelis | Administrateur | Hofspoor 3994 Vz Houten 3 Netherlands | Netherlands | Dutch | Business Executive | 291876980001 | ||||
JONES, Louis Philip | Administrateur | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 United Kingdom | England | British | Finance Director | 209239660001 | ||||
BENNETT, Roisin | Secrétaire | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent United Kingdom | Other | 137268090001 | ||||||
BURDETT, Neil Robert | Secrétaire | 765 Finchley Road NW11 8DS London | British | 188620003 | ||||||
CARTER, Brian Sydney | Secrétaire | 17 Exenden Park Drive CT6 8UB Herne Bay Kent | British | 4836800001 | ||||||
EDE, Joanne | Secrétaire | 1500 Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford Smiths Medical International Limited Kent United Kingdom | 203676310001 | |||||||
KENTISH, Barry | Secrétaire | 3 Derwent Drive LU6 3PB Dunstable Bedfordshire | British | Accountant | 33208630001 | |||||
SMITH, Alan | Secrétaire | 37 Pattison Road NW2 2HL London | British | 32394380001 | ||||||
BATTERSBY, Paul | Administrateur | 7 Botany Close BN16 2BH Rustington West Sussex | British | Director | 32410170002 | |||||
BENNETT, Roisin | Administrateur | WD24 4LG Watford Colonial Way Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Secretary | 150353170001 | ||||
BROAD, Donald Andrew Robertson | Administrateur | Floor Cardinal Place 80 Victoria Street SW1E 5JL London 2nd | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 46824520004 | ||||
CARLISLE, Malcolm John Calder Glen | Administrateur | 1 Jessica Road SW18 2QL London | United Kingdom | British | Barrister | 21835030001 | ||||
DAVEY-TURNER, Geoffrey Edward | Administrateur | The Manor House OX17 2BB Culworth Northants | British | Engineer | 4836820001 | |||||
DUNSMORE, Alan David | Administrateur | The Studio House 113 Bridge Street Wye TN25 5ED Ashford Kent | British | Chartered Accountant | 57416420002 | |||||
EGGLESTON, Steven Andrew | Administrateur | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 150302530002 | ||||
FLACK, Paul Anthony | Administrateur | 4 Wellington House 51 Seabrook Road CT21 5QB Hythe Kent | British | Director | 26551520002 | |||||
HARDY, Suzanne Ruth | Administrateur | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 United Kingdom | England | British | Finance Director | 171577960001 | ||||
IRELAND, Robert | Administrateur | Waverley Southview Road GU35 8HX Headley Down Hampshire | England | British | Director | 88177570001 | ||||
JAMIESON, Martin Clive | Administrateur | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent Uk | British | Director | 42951230008 | |||||
JAYNE, Kimberley Anne | Administrateur | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent | United Kingdom | British | Sales Director | 228156580001 | ||||
JONES, Norman Stewart | Administrateur | 46 Station Road Ivinghoe LU7 9EB Leighton Buzzard Bedfordshire | British | Engineer | 4836830001 | |||||
KENNEDY, George Macdonald | Administrateur | Deepwell House Maidstone Road, Chilham CT4 8DB Canterbury Kent | England | British | Director | 14451190006 | ||||
KOCKOTT, John Douglas | Administrateur | Oaktree Barn Brookley Farm Sway Road SO42 7RX Brockenhurst Hampshire | South African | Director | 29991160001 | |||||
O'BRIEN, Susan Lynn | Administrateur | 180 Longfield Lane Cheshunt EN7 6AQ Waltham Cross Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 123851410001 | |||||
PENN, David Alfred | Administrateur | 2 Salmons Lane Middleton Cheney OX17 2NF Banbury Oxon | England | British | Chartered Secretary | 64115230001 | ||||
SASSONE, Matthew Giovanni | Administrateur | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 156019710001 | ||||
SIMPSON, Jeremy John Cobbett | Administrateur | 765 Finchley Road NW11 8DS London | British | Chartered Accountant | 83467360003 | |||||
SPEAKMAN, Michael James | Administrateur | HP13 | United Kingdom | British | Accountant | 88515760001 | ||||
SURCH, Christopher | Administrateur | 765 Finchley Road NW11 8DS London | British | Finance Director | 97578250002 | |||||
WEISS, George | Administrateur | 40 New End Square NW3 1LS London | British | Engineer | 4836810002 | |||||
WHITE, Robert | Administrateur | Zircon Lane North 55447 Plymouth 3105 Minnesota | British | Vp Finance | 139191600001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PNEUPAC LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiths Medical International Limited | 06 avr. 2016 | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
PNEUPAC LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Créé le 21 mai 1996 Livré le 29 mai 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed | Créé le 24 août 1981 Livré le 25 août 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Together with fixed parts machinery and fixtures incl trade fixtures. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Further guarantee & debenture | Créé le 28 mars 1977 Livré le 15 avr. 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 19 déc. 1974 Livré le 02 janv. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of first fixed and floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. Fixtures fixed plant and machinery. (See doc 8). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 09 sept. 1974 Livré le 16 sept. 1974 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of a floating charge tog with plant machinery fixtures implements and utensils. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0