MOFFATT & CO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMOFFATT & CO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01151104
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MOFFATT & CO LIMITED ?

    • Assurance non-vie (65120) / Activités financières et d'assurance
    • Réassurance non-vie (65202) / Activités financières et d'assurance
    • Activités des agents et courtiers d'assurance (66220) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe MOFFATT & CO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MOFFATT & CO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MOFFATT & CO (LONDON) LIMITED13 déc. 197313 déc. 1973

    Quels sont les derniers comptes de MOFFATT & CO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour MOFFATT & CO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Dean Clarke en tant que secrétaire le 22 févr. 2022

    1 pagesTM02

    Nomination de Ardonagh Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire le 22 févr. 2022

    2 pagesAP04

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2020

    17 pagesAA

    legacy

    194 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 21 mars 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 16 déc. 2020

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    4 pagesAA

    Modification des détails de Cullum Capital Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 juil. 2020

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de 1 Minster Court London EC3R 7AA United Kingdom à 2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7PD le 14 juil. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 21 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Cullum Capital Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juil. 2019

    2 pagesPSC05

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Antonios Erotocritou en tant que directeur le 01 août 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Diane Cougill en tant qu'administrateur le 01 août 2019

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN à 1 Minster Court London EC3R 7AA le 30 juil. 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 21 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Dean Clarke en tant que secrétaire le 11 déc. 2018

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de MOFFATT & CO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ARDONAGH CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Secrétaire
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement03702575
    288842300001
    COUGILL, Diane
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Finance Officer158614590002
    ROSS, David Christopher
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    EnglandIrishDirector222326970001
    AMEY, Amanda Jane
    Manor Farm
    Shingay
    SG8 0HP Royston
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Manor Farm
    Shingay
    SG8 0HP Royston
    Hertfordshire
    BritishInsurance Broker69861950003
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Secrétaire
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    British117669700002
    CLARKE, Dean
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Secrétaire
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    253940330001
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    Secrétaire
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    249087450001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    Secrétaire
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    221970650001
    HUNTER, Andrew Stewart
    Cornwallis Road
    ME16 8BA Maidstone
    44
    Kent
    Secrétaire
    Cornwallis Road
    ME16 8BA Maidstone
    44
    Kent
    BritishSolicitor130726690001
    OWENS, Jennifer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Secrétaire
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    183282830001
    HILL STREET REGISTRARS LIMITED
    5th Floor
    7-10 Chandos Street
    W1G 9DQ London
    Secrétaire
    5th Floor
    7-10 Chandos Street
    W1G 9DQ London
    2417910005
    AMEY, Nicholas John
    Manor Farm
    Shingay
    SG8 0HP Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Manor Farm
    Shingay
    SG8 0HP Royston
    Hertfordshire
    United KingdomBritishInsurance Broker7642050006
    BARR, Graham Maxwell
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Administrateur
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector125097020001
    BROWN, Roger Michael
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Administrateur
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritishAccountant134140540001
    BRUCE, David James
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Administrateur
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector171398800001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Administrateur
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    EnglandBritishSolicitor149939610001
    CULLEN, Michael Edward
    3 The Meadway
    ENL 8AP Hoddesden
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 The Meadway
    ENL 8AP Hoddesden
    Hertfordshire
    BritishInsurance Broker56014190002
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Administrateur
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector59873490009
    DEDMAN, Eric John
    10 Thorley Park Road
    CM23 3NQ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    10 Thorley Park Road
    CM23 3NQ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishInsurance Broker19710560001
    EGAN, Scott
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Administrateur
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector170703910001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    United KingdomCypriotDeputy Cfo167795710001
    HODGES, Mark Steven
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Administrateur
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector58444370003
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    Administrateur
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritishDirector129538180001
    JOINER, Philip Robert
    1 Widbury Gardens
    SG12 7AT Ware
    Herts
    Administrateur
    1 Widbury Gardens
    SG12 7AT Ware
    Herts
    BritishInsurance Broker19710590004
    LYONS, Alastair David
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    Administrateur
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    United KingdomBritishExecutive Chairman193684010001
    MUGGE, Mark Stephen
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    Administrateur
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    EnglandBritishDirector162920630005
    PARK, Bryan
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Administrateur
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector113694470002
    REA, Michael Peter
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Administrateur
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector147194830001
    WRIGHT, John
    15 Chelsea Garden
    CM17 9RX Harlow
    Essex
    Administrateur
    15 Chelsea Garden
    CM17 9RX Harlow
    Essex
    BritishInsurance Broker29486730002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MOFFATT & CO LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Cullum Capital Ventures Limited
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Cardiff
    Numéro d'enregistrement05587424
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    MOFFATT & CO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 02 avr. 2015
    Livré le 22 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Bank of New York Mellon, London Branch
    Transactions
    • 22 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 juil. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 mai 2013
    Livré le 23 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Pursuant to the charge:. The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security accession deed
    Créé le 27 juin 2012
    Livré le 07 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Security Agent)
    Transactions
    • 07 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2012
    Livré le 06 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transactions
    • 06 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 sept. 2010
    Livré le 18 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 18 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession
    Créé le 26 juil. 2006
    Livré le 23 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 23 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over credit balance
    Créé le 09 janv. 1981
    Livré le 28 janv. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All moneys from time to time held to the credit of the company on any account with the bank.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 janv. 1981Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0