REMSDAQ (DEESIDE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREMSDAQ (DEESIDE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01152971
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REMSDAQ (DEESIDE) LIMITED ?

    • (3162) /

    Où se situe REMSDAQ (DEESIDE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Parkway
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NN Deeside Flintshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REMSDAQ (DEESIDE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REMSDAQ LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    QUINDAR ELECTRONICS LIMITED20 déc. 197320 déc. 1973

    Quels sont les derniers comptes de REMSDAQ (DEESIDE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour REMSDAQ (DEESIDE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    AUCWBM9I

    État du capital au 27 mai 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19
    ARGA9KCW

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    RTWV8KCF

    legacy

    1 pagesSH20
    ARGA7KCU

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Chae premuium/cap red reserve eliminated 26/05/2010
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes établis au 31 mai 2009

    6 pagesAA
    P36LVDJA

    legacy

    6 pages363a
    AGSC49W3

    legacy

    8 pages363s
    AUR5T496

    Comptes établis au 31 mai 2008

    6 pagesAA
    ACEDZ3DS

    Comptes établis au 31 mai 2007

    6 pagesAA
    AUVJXXLX

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 mai 2006

    6 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes établis au 31 mai 2005

    10 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes annuels établis au 31 mai 2004

    9 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    Comptes établis au 31 mai 2003

    9 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    Qui sont les dirigeants de REMSDAQ (DEESIDE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NAPIER, Paul William
    17 Thornfield Hey
    Spital
    CH63 9JT Wirral
    Merseyside
    Secrétaire
    17 Thornfield Hey
    Spital
    CH63 9JT Wirral
    Merseyside
    BritishFinancial Director27717230002
    BREEN, Terence James
    31 Green Meadows
    Hawarden
    CH5 3SL Deeside
    Clwyd
    Administrateur
    31 Green Meadows
    Hawarden
    CH5 3SL Deeside
    Clwyd
    United KingdomBritishEngineer24441000005
    COLSTON, Raymond John
    Thornbury House Hollins Lane
    Hawarden
    CH5 3JX Deeside
    Clwyd
    Administrateur
    Thornbury House Hollins Lane
    Hawarden
    CH5 3JX Deeside
    Clwyd
    United KingdomBritishDirector56666550002
    NAPIER, Paul William
    17 Thornfield Hey
    Spital
    CH63 9JT Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    17 Thornfield Hey
    Spital
    CH63 9JT Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritishFinancial Controller27717230002
    PRINGLE, John William
    147 Mold Road
    Mynydd Isa
    CH7 6TG Mold
    Clwyd
    Secrétaire
    147 Mold Road
    Mynydd Isa
    CH7 6TG Mold
    Clwyd
    British24440970001
    GREEN, Stanley Arthur
    91 Fairway Boulevard
    Jamesburgh
    FOREIGN New Jersey
    Usa
    Administrateur
    91 Fairway Boulevard
    Jamesburgh
    FOREIGN New Jersey
    Usa
    Us CitizenPresident - Daq Electronics24440990001
    LAING, Richard George
    Old Knowles Cottage Church Lane
    RH17 6UP Ardingly
    West Sussex
    Administrateur
    Old Knowles Cottage Church Lane
    RH17 6UP Ardingly
    West Sussex
    BritishAccountant1415680001
    PRINGLE, John William
    147 Mold Road
    Mynydd Isa
    CH7 6TG Mold
    Clwyd
    Administrateur
    147 Mold Road
    Mynydd Isa
    CH7 6TG Mold
    Clwyd
    BritishCommercial Manager24440970001
    ROSENFELD, Allen
    95 Asbury W. Portal Road
    Asbury
    CHANNEL Hunterdon
    New Jersey
    Usa
    Administrateur
    95 Asbury W. Portal Road
    Asbury
    CHANNEL Hunterdon
    New Jersey
    Usa
    AmericanVip Operations - Daq40978820001
    TAYLOR, Martyn James
    Wishing Well Cottage
    5 Ash Lane Ash
    SY13 4BP Whitchurch
    Shropshire
    Administrateur
    Wishing Well Cottage
    5 Ash Lane Ash
    SY13 4BP Whitchurch
    Shropshire
    BritishDirector56666540004
    WILLIAMS, Clifford James
    101 Fairway Boulevard
    Jamesburg
    FOREIGN New Jersey
    Usa
    Administrateur
    101 Fairway Boulevard
    Jamesburg
    FOREIGN New Jersey
    Usa
    BritishEngineer24440980001

    REMSDAQ (DEESIDE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over intellectual property
    Créé le 06 mars 1998
    Livré le 10 mars 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge all intellectual property rights as defined in schedule to form 395 relative to this charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 06 mars 1998
    Livré le 10 mars 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property charged being units 26 and 27 parkway deeside industrial park deeside flintshire t/no;-WA514602 all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 août 1993
    Livré le 24 août 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 22 avr. 1991
    Livré le 26 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3200000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the legal charge.
    Brèves mentions
    First legal charge on all the property being land and premises situate at plots 26 & 27 deeside industrial park, alyn and deeside clwyd. Title number wa 514602 together with the fitted carpets venetian blinds and the ethernet computer communications system installed in the buildings erected thereon.
    Personnes ayant droit
    • The De La Rue Company PLC.
    Transactions
    • 26 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 24 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 22 avr. 1991
    Livré le 26 avr. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the company's obligations under clause 9 of the agreement dated 22ND april 1991.
    Brèves mentions
    First fixed charge over any amounts over or becoming due to the company after the date of the fixed and comprised in the middle east debtors and/or any additional kfia payment. First fixed charge over all balances from time to time and for the time being standing to the credit of the receiving bank accounts. (For full details see form M395 reference M63).
    Personnes ayant droit
    • The De La Rue Company PLC.
    Transactions
    • 26 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    Secured loan agreement
    Créé le 22 avr. 1991
    Livré le 26 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £700,000
    Brèves mentions
    First floating charge over the company's machinery equipment vehicles furniture fixtures and other fixed assets and stock raw materials parts and work in progress whatsoever and wheresoever present & future.
    Personnes ayant droit
    • The De La Rue Company PLC.
    Transactions
    • 26 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 06 avr. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 04 mai 1983
    Livré le 13 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book debts present & future due or owing to the company. All other monetary debts and claims present & future due or owing to the company and all rights relating thereto. (See doc. M23).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 13 mai 1983Enregistrement d'une charge
    Supplemental legal charge
    Créé le 04 mai 1983
    Livré le 06 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 11/3/80, agreement dated 11/3/80 and a supplemental loan agreement dated 11/8/81
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book debts & other debts due or owing to the company present & future. Floating charge over all those book or other debts not charged by the fixed charge.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 06 mai 1983Enregistrement d'une charge
    Supplemental legal charge
    Créé le 11 août 1981
    Livré le 14 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture and an agreement both dated 11-3-80.
    Brèves mentions
    Fixed charge over all that piece or parcel of land situate at deeside in the county of clwyd containing approx 3.081 acres. Tog. With all fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery. (Please see doc M21).
    Personnes ayant droit
    • Industrial & Commercial Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 14 août 1981Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 11 mars 1980
    Livré le 17 mars 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over: building 52 deeside industrial estate, deeside, clwyd. Comprised in a lease dated 12/9/74 undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts investment in cash uncalled capital. Together with all buildings & fixtures including (trade fixtures) plant & machinery (see doc M20) except plot 3 deeside industrial park, deeside.
    Personnes ayant droit
    • Industrial & Commercial Finance Corporation LTD.
    Transactions
    • 17 mars 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0