NEW CENTURY DEBT COLLECTION LIMITED

NEW CENTURY DEBT COLLECTION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEW CENTURY DEBT COLLECTION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01157981
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEW CENTURY DEBT COLLECTION LIMITED ?

    • (7499) /
    • (9999) /

    Où se situe NEW CENTURY DEBT COLLECTION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    PO BOX 53
    New Century House
    M60 4ES Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEW CENTURY DEBT COLLECTION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WEST KENT FUNERAL SERVICES LIMITED23 janv. 197423 janv. 1974

    Quels sont les derniers comptes de NEW CENTURY DEBT COLLECTION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au11 janv. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour NEW CENTURY DEBT COLLECTION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2012

    3 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Andrew Oldale en tant qu'administrateur le 01 janv. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neil James Walker en tant que directeur le 31 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Buchan Hendry en tant que directeur le 15 déc. 2010

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 sept. 2011

    État du capital au 02 sept. 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2011

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2010

    3 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 10 janv. 2009

    3 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 12 janv. 2008

    3 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 13 janv. 2007

    3 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de NEW CENTURY DEBT COLLECTION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    British45801060004
    CLOSE, Alison
    11 Pennington Drive
    Newton-Le-Willows
    Nr Warrington
    Administrateur
    11 Pennington Drive
    Newton-Le-Willows
    Nr Warrington
    United KingdomBritish118977740001
    OLDALE, Andrew
    Brantingham Road
    Chorlton
    M21 0TS Manchester
    15
    United Kingdom
    Administrateur
    Brantingham Road
    Chorlton
    M21 0TS Manchester
    15
    United Kingdom
    EnglandBritish167083200001
    TINNING, George Murray
    17 Briar Road
    Kirkintilloch
    G66 3SA Glasgow
    Administrateur
    17 Briar Road
    Kirkintilloch
    G66 3SA Glasgow
    United KingdomBritish126913730001
    LEES, Moira Ann
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    British34646780001
    SKILLING, Derek John
    C/O Kent Co-Operative Society Limited
    Maidstone Road
    ME4 6DE Chatham
    Kent
    Secrétaire
    C/O Kent Co-Operative Society Limited
    Maidstone Road
    ME4 6DE Chatham
    Kent
    British10096400001
    WHITTAKER, Katherine Alison
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    British29899300001
    BLAND, Andrew
    49 Chester Road
    CW7 2NG Winsford
    Cheshire
    Administrateur
    49 Chester Road
    CW7 2NG Winsford
    Cheshire
    British33676570001
    CARPENTER, Paul Kenneth Christopher
    Grasmere
    36 Chester Road
    SK12 1EU Poyton
    Cheshire
    Administrateur
    Grasmere
    36 Chester Road
    SK12 1EU Poyton
    Cheshire
    British119893930001
    DUNLOP, Walter
    17 Ashcombe Drive
    Radcliffe
    M26 3NL Manchester
    Administrateur
    17 Ashcombe Drive
    Radcliffe
    M26 3NL Manchester
    British62604410001
    GOMERSALL, Richard
    9 Claremont Road
    Culcheth
    WA3 4NT Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    9 Claremont Road
    Culcheth
    WA3 4NT Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish84786020001
    HENDRY, David Buchan
    Cardney Estate
    Butterstone
    PH8 0EY By Dunkeld
    Over Cardney Farmhouse
    Perthshire
    Administrateur
    Cardney Estate
    Butterstone
    PH8 0EY By Dunkeld
    Over Cardney Farmhouse
    Perthshire
    ScotlandBritish128555100001
    HEWITT, Paul William
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish163759450001
    HOLLINGS, Terence Ernest
    10 Fenton Close
    Hightown
    CW12 3TH Congleton
    Cheshire
    Administrateur
    10 Fenton Close
    Hightown
    CW12 3TH Congleton
    Cheshire
    British680040002
    MACDONALD, Alexander Sutherland
    25 Auchinloch Road
    G66 5ES Glasgow
    Administrateur
    25 Auchinloch Road
    G66 5ES Glasgow
    ScotlandBritish43085270001
    PERRIN, Nicholas John
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    British80173660001
    POPE, James Albert
    29 Moreland Avenue
    Dartford
    Kent
    Administrateur
    29 Moreland Avenue
    Dartford
    Kent
    British10096420001
    TINNING, George Murray
    17 Briar Road
    Kirkintilloch
    G66 3SA Glasgow
    Administrateur
    17 Briar Road
    Kirkintilloch
    G66 3SA Glasgow
    United KingdomBritish126913730001
    WALKER, Neil James
    224a Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 3AA Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    224a Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 3AA Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish126913860001
    CWS (NO 1) LIMITED
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Administrateur
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    36139970001
    KENT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED
    Maidstone Road
    ME4 6DE Chatham
    Kent
    Administrateur
    Maidstone Road
    ME4 6DE Chatham
    Kent
    10096430001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0