NOBO (UK) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | NOBO (UK) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01161038 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NOBO (UK) LIMITED ?
Adresse du siège social | Oxford House Oxford Road HP21 8SZ Aylesbury Buckinghamshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NOBO (UK) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour NOBO (UK) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Munk en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Emma Davies en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 11 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 4 pages | AA | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2006 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2005 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 225 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
Comptes établis au 30 nov. 2004 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 5 pages | 363a |
Qui sont les dirigeants de NOBO (UK) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEDDIE, Richard Mark | Secrétaire | 15 Pine Grove Bricket Wood AL2 3ST St. Albans Hertfordshire | British | 80783870001 | ||||||
DAVIES, Emma Susan | Administrateur | OX17 1ET Claydon Lawn Hill Cottage Oxfordshire | United Kingdom | British | Vp Finance Europe | 126575640001 | ||||
GEDDIE, Richard Mark | Administrateur | 15 Pine Grove Bricket Wood AL2 3ST St. Albans Hertfordshire | England | British | Accountant | 80783870001 | ||||
BUCKINGHAM, Norman James | Secrétaire | 19 Rugosa Road West End GU24 9PA Woking Surrey | British | 10762580002 | ||||||
COLVIN, Roger Graham | Secrétaire | Gilridge Lodge Magham Down Hailsham BN27 1QB Eastbourne East Sussex | British | 16555880001 | ||||||
MOLINEUX, Keith Leslie | Secrétaire | 12 Beuzeville Avenue BN27 3PB Hailsham East Sussex | British | 17547290001 | ||||||
O REILLY, Patrick John | Secrétaire | 15 Delisle Road Gallions Reach SE28 0JD Thamesmead London | British | 66078790002 | ||||||
WILSON, Kenneth Young | Secrétaire | 71 Fyne Drive LU7 2YG Leighton Buzzard Bedfordshire | British | Company Secretary | 110645860001 | |||||
ANDERSON, David | Administrateur | Burleigh 269 Kings Drive BN21 2UR Eastbourne East Sussex | British | Company Director | 16573160001 | |||||
BARR, Reginald Kenneth Sidney | Administrateur | Claremont House Milton Street Polegate BN26 5RP Eastbourne East Sussex | British | Company Director | 16562040001 | |||||
CHAPMAN, Paul Guy | Administrateur | 51 Tempest Mead North Weald CM16 6DY Epping Essex | England | British | Accountant | 159719730001 | ||||
COLVIN, Roger Graham | Administrateur | Gilridge Lodge Magham Down Hailsham BN27 1QB Eastbourne East Sussex | British | Chartered Accountant | 16555880001 | |||||
FENWICK, Neal Vernon | Administrateur | 29 Meare Close KT20 5RZ Tadworth Surrey | British | Director | 39156650001 | |||||
GUEST, Richard Hamilton | Administrateur | 7 Townshend Road TW9 1XH Richmond | England | British | Vp European Finance | 122869580001 | ||||
KENT, Peter Frederick | Administrateur | Riseholme Tylers Green Cuckfield RH17 5EA Haywards Heath West Sussex | British | Company Director | 16555890001 | |||||
MOODIE, Gordon Murray | Administrateur | 1 Forest Lodge Epsom Road KT21 1JX Ashtead Surrey | British | Company Director | 66078560001 | |||||
MUNK, Peter | Administrateur | 58 Geffers Ride SL5 7JZ Ascot Berkshire | United Kingdom | Danish | Director | 112581070001 | ||||
PAGE, Andrew Stephen | Administrateur | 29 Russell Avenue MK40 3TD Bedford Bedfordshire | England | British | Director | 86557080001 | ||||
PAGE, Andrew Stephen | Administrateur | 29 Russell Avenue MK40 3TD Bedford Bedfordshire | England | British | Director | 86557080001 | ||||
PETTICAN, Charles William | Administrateur | 136 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 4JA Wokingham Berkshire | British | Director | 52934940001 | |||||
SMITH, Colin Eric | Administrateur | Friston Down Old Willingdon Road Friston BN20 0AT Eastbourne East Sussex | British | Company Director | 16555900001 | |||||
TRUSSLER, Gary John | Administrateur | 5 Pilgrims Lakes Church Road Harrietsham ME17 1BY Maidstone Kent | United Kingdom | British | Director | 13973300002 |
NOBO (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Créé le 27 mai 1997 Livré le 10 juin 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 6 park view eastbourne east sussex t/no;-ESX153953. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 15 oct. 1991 Livré le 04 nov. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from theco. To the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and juture including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. (See form 395 doc M477C for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 11 sept. 1989 Livré le 18 sept. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land lying to the south west of ander close, eastbourne, east sussex. T/n:- esx 116094. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 21 avr. 1983 Livré le 03 mai 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold land on the north side of bell lane, uckfield, east sussex. Title no. Esx 65952. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Equitable charge | Créé le 26 avr. 1982 Livré le 28 avr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti £59,000 under the terms of a loan agreement dated 26TH april 1982 | |
Brèves mentions (1) rolls royce car- registration number huc 60W. (2) rolls royce car- registration number huc 70W. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0