ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED

ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01164317
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED ?

    • Assurance-vie (65110) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Kathryn Louise Bateman en tant que directeur le 29 avr. 2022

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 07 sept. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de Canada Life (U.K.) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 sept. 2021

    1 pagesPSC07

    Notification de Clfis (U.K.) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 sept. 2021

    2 pagesPSC02

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Douglas Allan Brown en tant que directeur le 18 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Ashleigh Martin Kewney en tant qu'administrateur le 05 févr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Harold Charles Snow en tant que directeur le 01 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    9 pagesAA

    Notification de Canada Life (U.K.) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mrs Kathryn Louise Bateman en tant qu'administrateur le 26 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    9 pagesAA

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KEWNEY, Ashleigh Martin
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    Administrateur
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    EnglandBritish110858490001
    CRANSTON, Kareen
    2 Mount Pleasant
    AL3 4QJ St. Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    2 Mount Pleasant
    AL3 4QJ St. Albans
    Hertfordshire
    British69895760003
    ELLIS, Lindsay
    35b Piggottshill Lane
    AL5 1LR Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    35b Piggottshill Lane
    AL5 1LR Harpenden
    Hertfordshire
    British57723320001
    GEIRINGER, Bruno Marcel David
    83 Westbury Road
    KT3 5AL New Malden
    Surrey
    Secrétaire
    83 Westbury Road
    KT3 5AL New Malden
    Surrey
    British35563990001
    GEIRINGER, Bruno Marcel David
    83 Westbury Road
    KT3 5AL New Malden
    Surrey
    Secrétaire
    83 Westbury Road
    KT3 5AL New Malden
    Surrey
    British35563990001
    MUIR, Christopher William
    150 De Beauvoir Road
    N1 4DJ London
    Secrétaire
    150 De Beauvoir Road
    N1 4DJ London
    British89033740001
    REEVE, Andrew Howard
    7 Greenhills
    SG12 0XG Ware
    Hertfordshire
    Secrétaire
    7 Greenhills
    SG12 0XG Ware
    Hertfordshire
    British10571570001
    TEMPLE, John Nicholas
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    Secrétaire
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    British84493950001
    WISEMAN, Robin Harold
    Carlton Cottage
    Fulling Mill Lane
    AL6 9NS Welwyn
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Carlton Cottage
    Fulling Mill Lane
    AL6 9NS Welwyn
    Hertfordshire
    British12789370001
    ABERDARE, Morys George Lyndhurst, The Rt Hon Lord
    32 Elthiron Road
    SW6 4BN London
    Administrateur
    32 Elthiron Road
    SW6 4BN London
    British45953780001
    ATHANASSIADES, Theodossios
    4436 Province Line Road
    FOREIGN Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Administrateur
    4436 Province Line Road
    FOREIGN Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    American4378020001
    BATEMAN, Kathryn Louise
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    Administrateur
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    United KingdomBritish211153360001
    BELLRINGER, Charles Albert John
    Itchingwood Common
    RS8 0RL Limpsfield
    Tenchleys Manor
    Surrey
    Administrateur
    Itchingwood Common
    RS8 0RL Limpsfield
    Tenchleys Manor
    Surrey
    United KingdomBritish132720300001
    BLACKWELL, Richard Manning
    267 Holly Hill
    07092 Mountainside
    New Jersey
    Usa
    Administrateur
    267 Holly Hill
    07092 Mountainside
    New Jersey
    Usa
    Usa33587810001
    BROWN, Douglas Allan
    High Street
    EN6 5BA Potters Bar
    Canada Life Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    EN6 5BA Potters Bar
    Canada Life Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish172793780002
    BRUNINI, Alexander Deene
    126 East 16th Street
    NY10003 New York
    Usa
    Administrateur
    126 East 16th Street
    NY10003 New York
    Usa
    Usa26371140003
    CHAPPEL JNR, Robert Earl
    70 Glen Ridge Parkway
    Glen Ridge
    New Jersey 07028
    Usa
    Administrateur
    70 Glen Ridge Parkway
    Glen Ridge
    New Jersey 07028
    Usa
    American30869380001
    CLARK, Gerald
    2 Harwood Drive
    Madison New Jersey 07940
    United States Of America
    Administrateur
    2 Harwood Drive
    Madison New Jersey 07940
    United States Of America
    American44616590001
    DEAN, Derek James
    Gable House Stock Road
    Stock
    CM4 9PH Ingatestone
    Essex
    Administrateur
    Gable House Stock Road
    Stock
    CM4 9PH Ingatestone
    Essex
    British14651800001
    FLEMING, Richard Stephen
    40 Broadwalk
    Winchmore Hill
    N21 3BY London
    Administrateur
    40 Broadwalk
    Winchmore Hill
    N21 3BY London
    American45207950001
    GILLESPIE, John Francis
    12 Westcott
    AL7 2PP Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    12 Westcott
    AL7 2PP Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Irish26253320001
    GILMOUR, Ian
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    Administrateur
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    United KingdomBritish55683610001
    GLOVER, Neil Jonathan
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    Administrateur
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    United KingdomBritish180441810001
    HARWOOD, Judith Margaret
    40 Kidbrooke Gardens
    Blackheath
    SE3 0PD London
    Administrateur
    40 Kidbrooke Gardens
    Blackheath
    SE3 0PD London
    British73873830002
    KERR, Malcolm James Bowes
    15 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Administrateur
    15 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    United KingdomBritish3574930001
    MCEGAN, Michael Paul
    Woodlands East Common
    AL5 1DG Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Woodlands East Common
    AL5 1DG Harpenden
    Hertfordshire
    British50082050002
    MCLEOD, Charles
    Flat B 17 Crescent East
    Hadley Wood
    EN4 0EY Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    Flat B 17 Crescent East
    Hadley Wood
    EN4 0EY Barnet
    Hertfordshire
    British53804380001
    MERRY, Ernest George Thomas
    Greyfield Farm
    High Littleton
    BS18 5YQ Bristol
    Avon
    Administrateur
    Greyfield Farm
    High Littleton
    BS18 5YQ Bristol
    Avon
    British14651820001
    MEYERS, Steven Donald
    3 Goodyers Gardens
    Hendon
    NW4 2HD London
    Administrateur
    3 Goodyers Gardens
    Hendon
    NW4 2HD London
    Usa57361080001
    MYNOTT, David
    22 Shephall Green
    SG2 9XS Stevenage
    Hertfordshire
    Administrateur
    22 Shephall Green
    SG2 9XS Stevenage
    Hertfordshire
    British30749350001
    POORTVILET, William George
    420 East 23rd Street
    FOREIGN New York Ny 10010
    Usa
    Administrateur
    420 East 23rd Street
    FOREIGN New York Ny 10010
    Usa
    American14651830001
    PRUETER, William Robert
    17 Norrice Lea
    Hampstead Garden Suburb
    N2 0RD London
    Administrateur
    17 Norrice Lea
    Hampstead Garden Suburb
    N2 0RD London
    Canadian37536850002
    RICHARDS, William Jeffrey
    2 Sacombe Mews
    SG2 8SB Stevenage
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Sacombe Mews
    SG2 8SB Stevenage
    Hertfordshire
    British4929350002
    RITCHIE, Robert John
    Lombard Street
    EC3V 9JU London
    1-6
    United Kingdom
    Administrateur
    Lombard Street
    EC3V 9JU London
    1-6
    United Kingdom
    United KingdomCanadian131881720002
    RYAN, Mark Hopkins
    4 Queensmead
    St Johns Wood Park St Johns Wood
    NW8 6RE London
    Administrateur
    4 Queensmead
    St Johns Wood Park St Johns Wood
    NW8 6RE London
    American50062370001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    High Street
    EN6 5BA Potters Bar
    Canada Life Place
    England
    03 sept. 2021
    High Street
    EN6 5BA Potters Bar
    Canada Life Place
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04356028
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Canada Life (U.K.) Limited
    High Street
    EN6 5BA Potters Bar
    Canada Life Place
    Hertfordshire
    England
    06 avr. 2016
    High Street
    EN6 5BA Potters Bar
    Canada Life Place
    Hertfordshire
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Register (England & Wales)
    Numéro d'enregistrement01165737
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent free period security deed
    Créé le 16 août 1996
    Livré le 04 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £49,669.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposited sum of £49,669.00.
    Personnes ayant droit
    • Hammond & Champness Limited
    Transactions
    • 04 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent free period security deed
    Créé le 16 août 1996
    Livré le 04 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £43,647.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposited sum of £43,647.00.
    Personnes ayant droit
    • Hammond & Champness Limited
    Transactions
    • 04 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 12 août 1991
    Livré le 19 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5 victoria road gorleston gt yarmouth norfolk tn:- nk 63888 assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 1991Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 09 avr. 1991
    Livré le 18 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 30/9/87
    Brèves mentions
    All right, title & interest under any optson, lease agreement for tenanly or licence to occupy the property.
    Personnes ayant droit
    • Amsterdam Rottbrdam Bank N.V.
    Transactions
    • 18 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 05 avr. 1991
    Livré le 11 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The mortgage dated 6/9/90 over all that f/h land at nidd hall ripley nr harrogate nth yorks and all principal interest & other money now and on the future secured by the mortgage.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 mars 1991
    Livré le 14 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All that l/hold ground floor shop k/a unit 3 110 hutton road sherfield brentwood essex t/no:- ex 394153 fixed charge over all plant machnery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 mars 1991
    Livré le 14 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All that l/hold ground floor shop k/a unit 1 106 hutton road, shenfield brentwood essex t/no ex 319580 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 mars 1991
    Livré le 14 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All those l/hold first floor offices of teh property k/a 104-110 (even nos only) hutton road sherfield brentwood essex t/no:- ex 277562 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 14 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 mars 1991
    Livré le 14 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All that l/hold ground floor shop k/a unit 2 108 hutton road sherfield brentwood essex t/no ex O63057 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and euipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 mars 1991
    Livré le 14 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All those l/hold second floor offices of the property k/a 104-110 (even nos only) hutton road suerfield brentwood essex t/no ex 294270. fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Stardard security
    Créé le 04 févr. 1991
    Livré le 08 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under th terms of a personal bond dated 10/12/90
    Brèves mentions
    Those office premises consisting of ten rooms on the 6TH floor 14 mitchell lane glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 08 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 09 janv. 1991
    Livré le 16 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The mortgage dated 16-11-90 over all that f/hold land & buildings k/a unit j dunkeswell airfield dunkeswell honiton east devon devon & all fixtures fittings plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 13 déc. 1990
    Livré le 19 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A mortgage dated 7/11/90 over f/h gomersal park hotel gormersal cleckheaton kirklees t/n wyk 459019.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 10 déc. 1990
    Livré le 18 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A mortgage dated 20/9/90 over f/h the feathers public house feathers lane hythe and wooysbury buckinghamshire t/n bm 41485.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 10 déc. 1990
    Livré le 18 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A mortgage dated 9/11/90 over l/h land & buildings on north east side of west bawtry road rotherham t/n syk 270398.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 25 oct. 1990
    Livré le 31 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    L/H roseberry avenue tottenham. L/b maringey and 17 wadsworth road perivale l/b ealing. T/no mx 87593.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 17 oct. 1990
    Livré le 23 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The mortgage dated 19/9/90 over all that f/n land & buildings lying to the north west of cowlersley lane lintnwaite huddesfield kirkless west yorks k/a grove garage hazel grove linthwaite t/no wyk 151961.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 23 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 15 oct. 1990
    Livré le 23 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The mortgage dated 31/8/90 over all that f/hold lane & buildigns k/a unit 4 metro centre tolpits lane watford three rivers herts & all fixtures fittings plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 11 oct. 1990
    Livré le 13 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a mortgage of even date
    Brèves mentions
    Teh gatwick wana hotel (formerly russ hill hotel, the lodge laurel wreatn and land on the south side of russ hill) charlwood surrey.
    Personnes ayant droit
    • Charlerhouse Bank Limited.
    Transactions
    • 13 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 14 sept. 1990
    Livré le 20 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Mortgage dated 18 july 1990 granted by mackerzie tools and productions LTD to the co. Over all f/h land and buildings on the north side of anthony road, saltley, birmingham, W. midlands t/no. Wk 15959. see form 395 ref. 174C for further details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 août 1990
    Livré le 05 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The mortgage dated 10/8/90 granted by berwick limited to the company over all that f/h land & buildings 16-18 anne road smithwick sandwell west midlands t/no wm 95557 & all fixtures fittings plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 23 août 1990
    Livré le 31 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The mortgage dated 15/8/90 granted by farcrown properties limited to the company over firstly all that f/h land & property at caroline street birmingham west midlands secondly all that l/n land & property at caroline street aforesaid.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 10 août 1990
    Livré le 17 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The mortgage dated 26/7/90 granted by relcy properties limited to the company over all that f/h land and buildigns k/a 12 greenwich street and 9 turnpin lane, greenwich london and 14 and 23 and 25 greenwich church street t/no's ln 143130 266572, sgl 212118 and sgl 205191 (please see doc 395/ m/ 54/c/ 20/8 for complete details).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 31 juil. 1990
    Livré le 09 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee
    Brèves mentions
    Mortgage dated, 12.7.90 granted by elite up holstery manufacturing company over all f/h land and buildings an the W. side of rothwell road desborough kettering northants t/no:- nn 109365. (please see odc 395/m/89/C0 10/8 for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 09 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 12 juil. 1990
    Livré le 18 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The mortgage dated 12/7/90 granted by cute upholstery manufacturing company limited over all that f/h land & buildings on the west side of rothwell road desborough kettring northamptonshire t/no nn 109365.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0