IMPACT MARCOM LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | IMPACT MARCOM LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01166286 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe IMPACT MARCOM LTD ?
| Adresse du siège social | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de IMPACT MARCOM LTD ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour IMPACT MARCOM LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 mai 2019 | 11 pages | LIQ03 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 11 pages | LIQ13 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Europe House 170 Windmill Road West Sunbury on Thames Middlesex TW16 7HB à 55 Baker Street London W1U 7EU le 22 août 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 25 juin 2018
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 7 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 011662860009 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2017 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 sept. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2016 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2015 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Inscription de la charge 011662860009, créée le 24 mars 2015 | 55 pages | MR01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 8 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2014 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de IMPACT MARCOM LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEN, John | Administrateur | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | 182527790001 | |||||
| COOK, Edward Charles Peregrine Phelps | Administrateur | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | 52906920005 | |||||
| KENNEDY, Ewan Campbell | Secrétaire | Flat 11 Crawley Rise 18 Portsmouth Road GU15 1JX Camberley Surrey | British | 33639840003 | ||||||
| PORTER, Simon Neil | Secrétaire | Europe House 170 Windmill Road West TW16 7HB Sunbury On Thames Middlesex | British | 174403180001 | ||||||
| SEYMOUR, Barry James | Secrétaire | 9 Fort Street GU1 3TB Guildford Surrey | British | 1306660001 | ||||||
| STEWARD, Charles David | Secrétaire | 17 Windrush Close Bramley GU5 0BB Guildford Surrey | British | 103109350002 | ||||||
| ALLIN, John Leslie | Administrateur | 5 Elmbrook Vale RG11 Wokingham Berkshire | British | 16272300001 | ||||||
| AZAM, Mohammed | Administrateur | Jenner Way KT19 7LJ Epsom 3 Surrey United Kingdom | England | British | 135689290001 | |||||
| BRAY, Myles Edward James | Administrateur | Woodmancott SO21 3BN Winchester Woodmancott House Hampshire United Kingdom | England | British | 135690640001 | |||||
| CAUSEVIC, Fredd | Administrateur | Bekkestua 9a Bekkestua N-1357 Norway | Norway | Norwegian | 75177110001 | |||||
| DEMPSTER, Brian Leigh Harding | Administrateur | 14 Nutfield Gardens UB5 6LT Northolt Middlesex | British | 16272310001 | ||||||
| ELLIS, Kenneth Leonard | Administrateur | Europe House 170 Windmill Road West TW16 7HB Sunbury On Thames Middlesex | England | British | 149204440001 | |||||
| GORTON, Robert David | Administrateur | 55 Redhill Wood New Ash Green DA3 8QP Longfield Kent | England | British | 28341780002 | |||||
| HUDSON, Mark Alan | Administrateur | Crawshay Drive Emmer Green RG4 8SY Reading 58 England | England | British | 180576890001 | |||||
| JEWITT, Anthony John | Administrateur | 13 Pelling Hill Old Windsor SL4 2LL Windsor Berkshire | British | 785310001 | ||||||
| KENNEDY, Ewan Campbell | Administrateur | Braybourne House Crawley Ridge GU15 2AD Camberley Surrey | British | 33639840004 | ||||||
| MORAN, Michael Owen | Administrateur | Australind The Street West Clandon GU4 7TE Guildford Surrey | British | 1306650001 | ||||||
| PHILLIPS, Julian Brian | Administrateur | Oakwood 15 Oxted Green, Milford GU8 5D Godalming Surrey | England | British | 122795570002 | |||||
| PORTER, Simon Neil | Administrateur | Europe House 170 Windmill Road West TW16 7HB Sunbury On Thames Middlesex | England | United Kingdom | 55262300006 | |||||
| RAWLINGS, Timothy Paul | Administrateur | 11 Lulworth Road DA16 3LQ Welling Kent | British | 20665210002 | ||||||
| ROBINSON, Mark Laurence | Administrateur | 43 Worminghall Road Ickford HP18 9JB Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 43184090002 | |||||
| SEYMOUR, Barry James | Administrateur | 9 Fort Street GU1 3TB Guildford Surrey | England | British | 1306660001 | |||||
| SMITH, John | Administrateur | Allenwood 161 London Road CM7 8PT Braintree Essex | British | 66391760001 | ||||||
| STEWARD, Charles David | Administrateur | 17 Windrush Close Bramley GU5 0BB Guildford Surrey | United Kingdom | British | 103109350002 | |||||
| TITLER, Alec | Administrateur | 11 Greenways Malt Hill TW20 9PA Egham Surrey | England | British | 48506930001 | |||||
| TITLER, Alec | Administrateur | 11 Greenways Malt Hill TW20 9PA Egham Surrey | England | British | 48506930001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IMPACT MARCOM LTD ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avm Impact Ltd | 06 avr. 2016 | 170 Windmill Road West TW16 7HB Sunbury-On-Thames Europe House Middlesex England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
IMPACT MARCOM LTD a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 24 mars 2015 Livré le 28 mars 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A supplemental deed to a debenture | Créé le 03 déc. 2012 Livré le 10 déc. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 03 déc. 2012 Livré le 08 déc. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 22 avr. 2010 Livré le 11 mai 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed & floating charge | Créé le 03 mars 2008 Livré le 08 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 août 2007 Livré le 24 août 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage pursuant to an order of court dated 16/7/91 | Créé le 26 sept. 1990 Livré le 18 juil. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Unit 12 capitol park pearce way gloucester. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 06 oct. 1981 Livré le 12 oct. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book detbs uncalled captial, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 02 juin 1980 Livré le 09 juin 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
IMPACT MARCOM LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0