CROWNFLIGHT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCROWNFLIGHT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01169725
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CROWNFLIGHT LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CROWNFLIGHT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o WELL
    Merchants Warehouse
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CROWNFLIGHT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    E.R. PEAR LIMITED10 mai 197410 mai 1974

    Quels sont les derniers comptes de CROWNFLIGHT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au11 janv. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CROWNFLIGHT LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CROWNFLIGHT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Changement d'adresse du siège social de 1 Angel Square Manchester M60 0AG à C/O Well Merchants Warehouse Castle Street Manchester M3 4LZ le 14 sept. 2015

    1 pagesAD01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 août 2015

    État du capital au 05 août 2015

    • Capital: GBP 298
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 pagesAD02

    Période comptable actuelle prolongée du 11 janv. 2015 au 30 juin 2015

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Caroline Jane Sellers en tant que secrétaire le 30 sept. 2014

    1 pagesTM02

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business 11/08/2014
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 août 2014

    État du capital au 04 août 2014

    • Capital: GBP 298
    SH01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes modifiés jusqu'au 11 janv. 2014

    5 pagesAAMD

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony John Smith le 31 juil. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Branson Nuttall le 31 juil. 2013

    3 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2013

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES le 03 déc. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2011

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony John Smith le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de CROWNFLIGHT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NUTTALL, John Branson
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    EnglandBritish44967060003
    SMITH, Anthony John
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    EnglandBritish137558680002
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secrétaire
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Secrétaire
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    MOULT, Stephen Phillip
    Clearview 5 Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    Secrétaire
    Clearview 5 Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    British45585030001
    PEAR, Doria
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    Secrétaire
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    British24996800001
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150071860001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    110375350001
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140380300001
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    CROFT, Kenneth Michael
    152 Melton Road
    Stanton On The Wolds Keyworth
    NG12 5BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    152 Melton Road
    Stanton On The Wolds Keyworth
    NG12 5BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    British5859440001
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Administrateur
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritish125645380001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglish43686960001
    MARKS, Peter Vincent
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish87486470001
    MOULT, Stephen Phillip
    Clearview 5 Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    Clearview 5 Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    British45585030001
    NUTTALL, John Branson
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    British44967060001
    PEAR, Aubrey Edmund
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    Administrateur
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    British25080400001
    PEAR, Doria
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    Administrateur
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    British24996800001
    SILVER, Steven Russell
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    Administrateur
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    EnglandBritish182256460001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    110375270001

    CROWNFLIGHT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 12 juil. 1994
    Livré le 13 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    414 broxtowe lane aspley nottingham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 11 janv. 1991
    Livré le 22 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 02 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 02 juin 1987
    Livré le 10 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1987Enregistrement d'une charge
    • 29 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 05 nov. 1980
    Livré le 26 nov. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 414 broxtowe lane, nottingham, nottinghamshire nt 114158.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 nov. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0