ANGLO-AUSTRIAN PATISSERIE LIMITED

ANGLO-AUSTRIAN PATISSERIE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéANGLO-AUSTRIAN PATISSERIE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01187124
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ANGLO-AUSTRIAN PATISSERIE LIMITED ?

    • Fabrication de pain; fabrication de pâtisseries fraîches et de gâteaux (10710) / Industries manufacturières

    Où se situe ANGLO-AUSTRIAN PATISSERIE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Office D Beresford House
    Town Quay
    SO14 2AQ Southampton
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ANGLO-AUSTRIAN PATISSERIE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour ANGLO-AUSTRIAN PATISSERIE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    23 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 sept. 2022

    28 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Oliver Charles Tonkin en tant que directeur le 05 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 sept. 2021

    18 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 sept. 2020

    20 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 sept. 2019

    19 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 sept. 2018

    22 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 sept. 2017

    24 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 14th Floor Dukes Keep Marsh Lane Southampton Hampshire SO14 3EX à Office D Beresford House Town Quay Southampton SO14 2AQ le 05 juin 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    9 pages4.20

    Changement d'adresse du siège social de 5th Floor 207 Regent Street London W1B 4nd England à 14th Floor Dukes Keep Marsh Lane Southampton Hampshire SO14 3EX le 08 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 21 sept. 2016

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de 66 Prescot Street London E1 8NN à 5th Floor 207 Regent Street London W1B 4nd le 11 janv. 2016

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Susanne Isabelle Edler en tant que directeur le 23 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Anthony Edler en tant que directeur le 23 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Edler en tant que secrétaire le 23 déc. 2015

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Nicholas Paul Wills en tant qu'administrateur le 23 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Edler en tant que secrétaire le 23 déc. 2015

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Oliver Charles Tonkin en tant qu'administrateur le 23 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de ANGLO-AUSTRIAN PATISSERIE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLS, Nicholas Paul
    Beresford House
    Town Quay
    SO14 2AQ Southampton
    Office D
    Administrateur
    Beresford House
    Town Quay
    SO14 2AQ Southampton
    Office D
    ScotlandBritish204094210001
    EDLER, Elizabeth
    White Friars
    45 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    Secrétaire
    White Friars
    45 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    British104202280001
    EDLER, Eva
    Sunnyhill The Clump
    Chorleywood
    WD3 4BD Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Sunnyhill The Clump
    Chorleywood
    WD3 4BD Rickmansworth
    Hertfordshire
    Austrian20494030001
    EDLER, Susanne Isabelle
    The Garden Flat 21 Lauderdale
    Mansions Lauderdale Road
    W9 1LX London
    Secrétaire
    The Garden Flat 21 Lauderdale
    Mansions Lauderdale Road
    W9 1LX London
    British42285550002
    EDLER, Eva
    Sunnyhill The Clump
    Chorleywood
    WD3 4BD Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Sunnyhill The Clump
    Chorleywood
    WD3 4BD Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandAustrian20494030001
    EDLER, Stephen Anthony
    White Friars
    45 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    White Friars
    45 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    British31600280003
    EDLER, Susanne Isabelle
    The Garden Flat 21 Lauderdale
    Mansions Lauderdale Road
    W9 1LX London
    Administrateur
    The Garden Flat 21 Lauderdale
    Mansions Lauderdale Road
    W9 1LX London
    United KingdomBritish42285550002
    TONKIN, Oliver Charles
    Beresford House
    Town Quay
    SO14 2AQ Southampton
    Office D
    Administrateur
    Beresford House
    Town Quay
    SO14 2AQ Southampton
    Office D
    United KingdomBritish132929440001

    ANGLO-AUSTRIAN PATISSERIE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    All assets debenture
    Créé le 22 déc. 2010
    Livré le 05 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over all property including buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 05 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 17 nov. 2008
    Livré le 19 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property k/a unit 3 haslemere industrial estate, wimbledon and car parking spaces 14 and 27 to 46 t/no. SGL411968.
    Personnes ayant droit
    • Nss Trustees Limited, Eva Edler, Susanne Isabelle Edler and Steven Anthony Edler
    Transactions
    • 19 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 17 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 nov. 2008
    Livré le 28 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 28 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 16 oct. 2006
    Livré le 18 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 3 haslemere industrial estate wimbledon t/n SGL411968. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 06 oct. 2006
    Livré le 11 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 oct. 1999
    Livré le 21 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee including monies referred to in a loan agreement dated 18TH october 1999
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nigel Spencer Sloam,Eva Edler,Susanne Isabelle Edler,Stephen Anthony Edler,Thomas Alfred Backer
    Transactions
    • 21 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 29 oct. 1992
    Livré le 11 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 2 and car parking spaces 47 to 56 and 76 to 95 haslemere avenue wimbledon l/b of merton t/no sgl 194463.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 1984
    Livré le 03 juil. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold unit 3 and car parking spaces 14 and 27 to 46, hazelmere avenue wimbledon merton london.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1984Enregistrement d'une charge
    • 19 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 nov. 1983
    Livré le 25 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold unit 3 and car parking spaces 14 & 27 to 46 haslemere avenue, merton, london. Title no. Sgl 185012.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    • 19 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 22 déc. 1980
    Livré le 06 janv. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    2 vtm machines machine numbers 700109 and 700110 type Y00FFS.
    Personnes ayant droit
    • North West Securities Limited.
    Transactions
    • 06 janv. 1981Enregistrement d'une charge
    • 19 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee and debenture
    Créé le 25 oct. 1976
    Livré le 12 nov. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and or all or other of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All that property charged by principal deed and further deeds together with undertakings and assets.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 1976Enregistrement d'une charge
    • 19 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 16 juil. 1975
    Livré le 22 juil. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future goodwill including uncalled capital. Fixed and floating charges ( see doc M10).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 juil. 1975Enregistrement d'une charge
    • 19 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ANGLO-AUSTRIAN PATISSERIE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 sept. 2016Commencement of winding up
    08 févr. 2024Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Campbell
    14th Floor Dukes Keep Marsh Lane
    SO14 3EX Southampton
    Hampshire
    practitioner
    14th Floor Dukes Keep Marsh Lane
    SO14 3EX Southampton
    Hampshire
    Carl Stuart Jackson
    14th Floor Dukes Keep
    1 Marsh Lane
    SO14 3EX Southampton
    Hampshire
    practitioner
    14th Floor Dukes Keep
    1 Marsh Lane
    SO14 3EX Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0