WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED

WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01190454
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED ?

    • (3162) /
    • (3614) /

    Où se situe WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BDO STOY HAYWARD LLP
    Prospect Place
    85 Great North Road
    AL9 5BS Hatfield
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BILLETBRIDGE LIMITED13 nov. 197413 nov. 1974

    Quels sont les derniers comptes de WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 mars 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 sept. 2011

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 avr. 2011

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 oct. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 avr. 2010

    5 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 21 févr. 2009

    3 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    4 pages2.34B

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 30 mars 2008

    15 pagesAA

    Résultat de la réunion des créanciers

    46 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    43 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages395

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JARDINE, Frank Stuart
    Thaxted Road
    CB11 3AG Saffron Walden
    78
    Essex
    Secrétaire
    Thaxted Road
    CB11 3AG Saffron Walden
    78
    Essex
    British116077680002
    JARDINE, Frank Stuart
    Thaxted Road
    CB11 3AG Saffron Walden
    78
    Essex
    Administrateur
    Thaxted Road
    CB11 3AG Saffron Walden
    78
    Essex
    BritishDirector116077680002
    KITCHING, Robert
    149 The Drive
    DA5 3BU Bexley
    Kent
    Administrateur
    149 The Drive
    DA5 3BU Bexley
    Kent
    EnglandBritishSales Director126751100001
    RUDD, Anthony
    1 Macers Court
    EN10 6DZ Broxbourne
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Macers Court
    EN10 6DZ Broxbourne
    Hertfordshire
    BritishOperations Director126751070001
    BAMFORD, Lorraine Elizabeth
    63 Rosedale
    AL7 1DP Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secrétaire
    63 Rosedale
    AL7 1DP Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British33608960001
    BARKER, James Edward
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Secrétaire
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    BritishCompany Director42890001
    BATES, Mark Richard
    46 St Michaels Avenue
    Bramhall
    SK7 2PL Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    46 St Michaels Avenue
    Bramhall
    SK7 2PL Stockport
    Cheshire
    BritishDirector11869700002
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant40164810001
    SAMOLS, Leonard Cecil
    6 Mornington
    Digswell
    AL6 0AY Welwyn
    Hertfordshire
    Secrétaire
    6 Mornington
    Digswell
    AL6 0AY Welwyn
    Hertfordshire
    British39387650001
    BESSEMER ENTERPRISES LIMITED
    Crossley House
    Hopwood Lane
    HX1 5EB Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Crossley House
    Hopwood Lane
    HX1 5EB Halifax
    West Yorkshire
    74446740001
    GWB SECRETARY LIMITED
    West House
    Kings Cross Road
    HX1 1EB Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    West House
    Kings Cross Road
    HX1 1EB Halifax
    West Yorkshire
    83825250002
    BATES, Mark Richard
    46 St Michaels Avenue
    Bramhall
    SK7 2PL Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    46 St Michaels Avenue
    Bramhall
    SK7 2PL Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector11869700002
    BUCHANAN, Mary
    5 Beehive Lane
    AL7 4BB Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Beehive Lane
    AL7 4BB Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishDesign Director74257030002
    CAMSELL, Simon Robert
    2 Jackson Street
    SG7 5AQ Baldock
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Jackson Street
    SG7 5AQ Baldock
    Hertfordshire
    BritishCompany Director73723000001
    CURWEN, John William
    First Floor Flat 4 Alma Square
    NW8 9QD London
    Administrateur
    First Floor Flat 4 Alma Square
    NW8 9QD London
    BritishCompany Director52099870001
    DIAMOND, Andrew Carl
    1 Valley Green
    AL8 7OQ Welwyn Garden City
    Herts
    Administrateur
    1 Valley Green
    AL8 7OQ Welwyn Garden City
    Herts
    BritishEngineer22203000001
    GILHAM, Clive Martin
    No 3 Birch House, The Alders
    Allerton Park Chapel
    LS1 4ND Allerton
    Leeds, West Yorkshire
    Administrateur
    No 3 Birch House, The Alders
    Allerton Park Chapel
    LS1 4ND Allerton
    Leeds, West Yorkshire
    BritishDirector97163670001
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant40164810001
    HUGGINS, Martin
    4 Roxley Manor
    Willian
    SG6 2DP Letchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Roxley Manor
    Willian
    SG6 2DP Letchworth
    Hertfordshire
    BritishManaging Director73209240002
    LUDDINGTON, Stephen John
    Frodsham The Drive
    CM21 9EP Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Frodsham The Drive
    CM21 9EP Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    BritishChief Executive60256340001
    MC DONALD, Fintan Patrick
    87 Heronswood Road
    AL7 3EW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    87 Heronswood Road
    AL7 3EW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    IrishFinancial Director69613030002
    MYOTT, Dominic John
    Thatched Cottage Walkern Road
    Watton At Stone
    SG14 3RN Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Thatched Cottage Walkern Road
    Watton At Stone
    SG14 3RN Hertford
    Hertfordshire
    BritishDirector12790090002
    NICHOLSON, Christopher
    57 Highfield
    SG6 3PY Letchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    57 Highfield
    SG6 3PY Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector26306070002
    POWERS, Glenn Patrick
    23 Sefton Drive
    M28 2NG Worsley
    Manchester
    Administrateur
    23 Sefton Drive
    M28 2NG Worsley
    Manchester
    BritishDirector72486520001
    PREWER, John Leonard
    Broadmead The Rye
    Eaton Bray
    LU6 2BQ Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    Broadmead The Rye
    Eaton Bray
    LU6 2BQ Dunstable
    Bedfordshire
    BritishCompany Director22203010003
    SAMOLS, Leonard Cecil
    44 New Road
    AL6 0AH Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    44 New Road
    AL6 0AH Welwyn
    Hertfordshire
    BritishCompany Director39387650002
    SMITH, Graham
    98 St James Road
    YO15 3NJ Bridlington
    East Yorkshire
    Administrateur
    98 St James Road
    YO15 3NJ Bridlington
    East Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director12510200001
    SNEDDON, John
    2 St Johns Close
    AL6 9RB Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 St Johns Close
    AL6 9RB Welwyn
    Hertfordshire
    BritishCompany Director17419260001
    WHEATLEY, Jeremy David
    35 Marshals Drive
    AL1 4RB St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    35 Marshals Drive
    AL1 4RB St Albans
    Hertfordshire
    BritishCompany Director17419280001
    BESSEMER SERVICES LIMITED
    Crossley House
    Hopwood Lane
    HX1 5EB Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Crossley House
    Hopwood Lane
    HX1 5EB Halifax
    West Yorkshire
    73569630002
    GWB DIRECTOR LIMITED
    West House
    Kings Cross Road
    HX1 1EB Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    West House
    Kings Cross Road
    HX1 1EB Halifax
    West Yorkshire
    83835430002

    WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 juin 2008
    Livré le 04 juil. 2008
    En cours
    Montant garanti
    £300,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Legal mortgage over lease dated 16 july 1999 relating to land at bessemer road welwyn garden city hertfordshire, fixed charge over all properties acquired, all present or future policies of insurance or assurance and floating charge on all undertaking property assets and rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Welwyn Holdings Limited
    Transactions
    • 04 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 17 août 2006
    Livré le 25 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over cash deposit
    Créé le 13 juin 2003
    Livré le 28 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit and all rights titles and benefit of the company whatsoever in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and other debts and floating charge on banked proceeds of other debts
    Créé le 06 nov. 2001
    Livré le 09 nov. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under the agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all purchased debts (as defined) and the proceeds thereof and the other debts (as defined) together with their related rights and by way of floating charge such moneys which the company may receive in respect of the other debts as shall for the time being stand released (pursuant to clause 8 of the charge) from the fixed charge created under the charge.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 09 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 27 juil. 2001
    Livré le 04 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 28 août 1998
    Livré le 02 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £161,718 together with all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Uniform case taper 152473 ring forming machine 117114 butt welder LT4279. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 02 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 19 déc. 1996
    Livré le 03 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 28 oct. 1994
    Livré le 09 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and either of farabay investments limited and welwyn properties limited to the chargee on any account whatsoever under the facility documents (all as defined or referred to in the guarantee and debenture)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment
    Créé le 28 oct. 1994
    Livré le 09 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility documents (all as referred to in the assignment)
    Brèves mentions
    All rights title & interest in & to the insurance policies and the full benefit thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 oct. 1987
    Livré le 05 nov. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    41 broadwater road welwyn garden city herts.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 nov. 1987Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juin 1982
    Livré le 08 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    41 broadwater road welwyn garden city hertfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 juil. 1980
    Livré le 22 juil. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    41 broadwater road welwyn garden city herefordshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 juil. 1980Enregistrement d'une charge
    • 16 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 févr. 1978
    Livré le 02 févr. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital (see doc M21).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 févr. 1978Enregistrement d'une charge
    • 16 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 août 2008Administration started
    16 avr. 2009Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    William John Turner
    Bdo Stoy Hayward Llp
    Prospect Place
    AL9 5BS 85 Great North Road
    Hatfield Hertfordshire
    practitioner
    Bdo Stoy Hayward Llp
    Prospect Place
    AL9 5BS 85 Great North Road
    Hatfield Hertfordshire
    2
    DateType
    16 avr. 2009Commencement of winding up
    02 févr. 2012Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    William John Turner
    Bdo Stoy Hayward Llp
    Prospect Place
    AL9 5BS 85 Great North Road
    Hatfield Hertfordshire
    practitioner
    Bdo Stoy Hayward Llp
    Prospect Place
    AL9 5BS 85 Great North Road
    Hatfield Hertfordshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0