PEGLER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPEGLER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01194543
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PEGLER LIMITED ?

    • forgeage, estampage, emboutissage et profilage de métaux ; métallurgie des poudres (25500) / Industries manufacturières

    Où se situe PEGLER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PEGLER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STEEL NUT AND JOSEPH HAMPTON LIMITED(THE)31 déc. 198031 déc. 1980
    WODEN STEEL & FASTENERS LIMITED 31 déc. 197631 déc. 1976
    HEXAGON FASTENINGS LIMITED20 déc. 197420 déc. 1974

    Quels sont les derniers comptes de PEGLER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour PEGLER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 avr. 2023

    7 pagesLIQ03

    Nomination de Jeroen Praas en tant qu'administrateur le 02 nov. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Guy Walker Robinson en tant que directeur le 02 nov. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Craig Malloy en tant que directeur le 02 nov. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 22 avr. 2022

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2020

    19 pagesAA

    legacy

    128 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 01 déc. 2019

    3 pagesRP04CS01

    Nomination de Mr Guy Walker Robinson en tant qu'administrateur le 14 déc. 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2019

    19 pagesAA

    legacy

    157 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Qui sont les dirigeants de PEGLER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOUSLEY, Claire Anne
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    271574930001
    PRAAS, Jeroen
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    Belmont Works
    United Kingdom
    Administrateur
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    Belmont Works
    United Kingdom
    United KingdomDutch302847600001
    ABLETT, Roger Colin
    4 Drewry Lane
    Westwoodside
    DN9 2RE Doncaster
    South Yorkshire
    Secrétaire
    4 Drewry Lane
    Westwoodside
    DN9 2RE Doncaster
    South Yorkshire
    British111377550001
    BROOKS, Malcolm Rodney
    Church View
    St Nicholas Way, Bawtry
    DN10 6HB Doncaster
    Secrétaire
    Church View
    St Nicholas Way, Bawtry
    DN10 6HB Doncaster
    British116420280001
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    PARKER, Kevin Michael
    16 Pinders Grove
    WF1 4AH Wakefield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    16 Pinders Grove
    WF1 4AH Wakefield
    West Yorkshire
    British42755700001
    ABLETT, Roger Colin
    High Street
    Misterton
    DN10 4BU Doncaster
    9a
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    Misterton
    DN10 4BU Doncaster
    9a
    South Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish111377550002
    ADAMS, David Mcdonald
    55 Ley Hill Road
    Four Oaks
    B75 6TE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    55 Ley Hill Road
    Four Oaks
    B75 6TE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British86150100001
    ANDERSON, Stuart John
    Rickstones Farmhouse
    300 Rickstones Road Rivenhall
    CM8 3HQ Witham
    Essex
    Administrateur
    Rickstones Farmhouse
    300 Rickstones Road Rivenhall
    CM8 3HQ Witham
    Essex
    British95628750001
    BEARDALL, Malcolm Derek
    Glenshirra Lodge Main Street
    Alne
    YO61 1TD York
    Administrateur
    Glenshirra Lodge Main Street
    Alne
    YO61 1TD York
    British25053140003
    BLACKWOOD, Kenneth John
    33 Hunters Ride
    Appleton Wiske
    DL6 2BD Northallerton
    North Yorkshire
    Administrateur
    33 Hunters Ride
    Appleton Wiske
    DL6 2BD Northallerton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish183082590001
    BROOKS, Malcolm Rodney
    Church View
    St Nicholas Way, Bawtry
    DN10 6HB Doncaster
    Administrateur
    Church View
    St Nicholas Way, Bawtry
    DN10 6HB Doncaster
    British116420280001
    CLARKSON, Antoni Raymond
    2 York Gardens Main Street
    Willerby
    HU10 6AQ Hull
    North Humberside
    Administrateur
    2 York Gardens Main Street
    Willerby
    HU10 6AQ Hull
    North Humberside
    British95628860001
    DOWLING, Martin John
    33 Rossett Drive
    HG2 9NS Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    33 Rossett Drive
    HG2 9NS Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish85410210001
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Administrateur
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    FLANAGAN, Paul Edward
    First Floor Flat
    138 Shepherds Bush Road
    W6 7PB London
    Administrateur
    First Floor Flat
    138 Shepherds Bush Road
    W6 7PB London
    British69281780001
    HALL, Alan David
    169 Healey Wood Road
    HD6 3RW Brighouse
    West Yorkshire
    Administrateur
    169 Healey Wood Road
    HD6 3RW Brighouse
    West Yorkshire
    EnglandBritish33149710001
    HAYCOCK, Patrick John
    Grove House Norton Gardens
    Pebworth
    CV37 8YA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Grove House Norton Gardens
    Pebworth
    CV37 8YA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British33062310001
    HOUGHTON, Paul David
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    British95097460001
    HOWARTH, Ian Martin
    Fenay Lane
    Almondbury
    HD5 8UJ Huddersfield
    80
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Fenay Lane
    Almondbury
    HD5 8UJ Huddersfield
    80
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish88051000002
    LASSETER, Ronald Sydney
    Rest Harrow
    Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Rest Harrow
    Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British44202370001
    LEWIS, David James
    51 Kingsley Crescent
    Birkenshaw
    BD11 2NJ Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    51 Kingsley Crescent
    Birkenshaw
    BD11 2NJ Bradford
    West Yorkshire
    United KingdomBritish33062330001
    LIDDLE, Bryan
    47 Lesbury Close
    Waldridge Park
    DH2 3SS Chester Le Street
    County Durham
    Administrateur
    47 Lesbury Close
    Waldridge Park
    DH2 3SS Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish74328530002
    MALLOY, Craig
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish191150650001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MCCARROLL, Neil Robert
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish183381810001
    NELSON, Nigel David
    40 Tong Lane
    Tong Village
    BD4 0RP Bradford
    Pinfold Cottage
    Administrateur
    40 Tong Lane
    Tong Village
    BD4 0RP Bradford
    Pinfold Cottage
    British117580540003
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    READING, Anthony John
    16 Heatherside Gardens
    Farnham Common
    SL2 3RR Slough
    Berkshire
    Administrateur
    16 Heatherside Gardens
    Farnham Common
    SL2 3RR Slough
    Berkshire
    United KingdomBritish17110410001
    ROBINSON, Guy Walker
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish195362020001
    SAUNDERS, Michael John
    The Beeches
    Grimley
    WR2 6LU Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    The Beeches
    Grimley
    WR2 6LU Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish87395770001
    SHIRLEY, Nigel Graham
    26 Windmill Hill
    HP27 0EP Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    26 Windmill Hill
    HP27 0EP Princes Risborough
    Buckinghamshire
    EnglandBritish99898590001
    STARK, John David Sinclair
    Tara 15 Copsem Drive
    KT10 9HD Esher
    Surrey
    Administrateur
    Tara 15 Copsem Drive
    KT10 9HD Esher
    Surrey
    British27350001
    WATSON, Brian
    The Oaks Castle Rising Road
    PE30 3JD South Wootton
    Norfolk
    Administrateur
    The Oaks Castle Rising Road
    PE30 3JD South Wootton
    Norfolk
    British74326200001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PEGLER LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    St. Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    Belmont Works
    England
    06 avr. 2016
    St. Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    Belmont Works
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleEnglish
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04928300
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    PEGLER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 14 juil. 2011
    Livré le 16 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 mai 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 03 nov. 2010
    Livré le 04 nov. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Note: by cla use 14.7 of the agreement the company agreed that it would not without the prior written consent of the bank assign mortgage charge or otherwise confer upon any third party any right title or interest in or to all or any of the accounts for the time being of the company with the bank or any sum or sums standing to the credit of any one or more of such accounts or agree to do any such thing or allow any such third pary right title or interest to subsist except in each case in favour of or upon the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 mai 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 30 august 2004 and
    Créé le 06 févr. 2007
    Livré le 12 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-of agreement dated 30/08/04 (the agreement)
    Créé le 28 déc. 2005
    Livré le 04 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture made between the company, ever 2214 limited (now known as pegler holdings limited) and gmac commercial finance PLC and
    Créé le 31 janv. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor or any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge all the present and future property, undertaking and assets of the company including, without limitation, by way of first legal mortgage the f/h land and buildings owned by the company at st catherine's avenue, balby, doncaster t/nos. SYK286454, SYK438339, SYK286296, SYK446965, SYK438315 and SYK438336.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of credit insurance policy
    Créé le 31 janv. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy being the policy of credit insurance with gerling ncm, policy number 140719 dated 14 october 2003 for the sum assured of £2,500,000.00, all sums assured by it and all benefits which may arise under it; and the company's whole right, title, benefit and interest present and future in the policy, and all sums arising thereunder.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 31 janv. 2004
    Livré le 09 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Tomkins PLC
    Transactions
    • 09 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PEGLER LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 avr. 2022Commencement of winding up
    07 mars 2024Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Pricewaterhousecoo0pers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoo0pers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0