UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01195031 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?
| Adresse du siège social | The Observatory Western Road RG12 1TL Bracknell United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Deborah Ann Saunders en tant que secrétaire le 01 sept. 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Gavin Raymond White en tant que secrétaire le 01 sept. 2021 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
État du capital au 07 sept. 2021
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 mai 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Tilney Smith & Williamson Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 sept. 2020 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Modification des détails de Towry Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 août 2019 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nicola Claire Mitford-Slade en tant que directeur le 18 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Woodhouse en tant que directeur le 18 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Nicola Claire Mitford-Slade en tant qu'administrateur le 22 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Donald William Sherret Reid en tant que directeur le 22 oct. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Rehana Hasan en tant que secrétaire le 22 oct. 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Nomination de Deborah Ann Saunders en tant que secrétaire le 22 oct. 2020 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ England à 25 Moorgate London EC2R 6AY | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 9 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 mai 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 15 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 mai 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England à The Observatory Western Road Bracknell RG12 1TL le 28 janv. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Andrew Martin Baddeley en tant qu'administrateur le 01 oct. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE, Gavin Raymond | Secrétaire | Moorgate EC2R 6AY London 25 England | 287112200001 | |||||||
| BADDELEY, Andrew Martin | Administrateur | Chesterfield Gardens W1J 5BQ London 6 England England | United Kingdom | British | 82469460001 | |||||
| BELLAMY, Martin William | Secrétaire | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | 173971990001 | |||||||
| GREGORY, Jacqueline Anne | Secrétaire | c/o C/O Jacqui Gregory Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | 197490510001 | |||||||
| HASAN, Rehana | Secrétaire | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | 217672230001 | |||||||
| KAY, Kevin Joseph | Secrétaire | 15 Melbourne Road Bramhall SK7 1LR Stockport Cheshire | British | 9290220001 | ||||||
| NICHOLS, Sarah | Secrétaire | Lisbon Square LS1 4LY Leeds 8 West Yorkshire | British | 157133330001 | ||||||
| OWEN, Michael Sibberin | Secrétaire | 19 Amersham Close SK10 2LF Macclesfield Cheshire | British | 37087430001 | ||||||
| PEACOCK, Natasha Valerie | Secrétaire | Pear Tree Drive SK15 2PY Stalybridge 7 Cheshire | British | 129803720001 | ||||||
| SAUNDERS, Deborah Ann | Secrétaire | Moorgate EC2R 6AY London 25 England | 276008280001 | |||||||
| BRADSHAW, Phillip Gordon | Administrateur | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 26428400002 | |||||
| BRIGHT, Kevin Robert | Administrateur | 32 Amberley Road SK11 8LX Macclesfield Cheshire | England | British | 9569040001 | |||||
| BUSSEY, Michael Adrian | Administrateur | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 52554700003 | |||||
| COLEMAN, Lynn Rose | Administrateur | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 149721950001 | |||||
| CRESWELL-TURNER, Miles Marius | Administrateur | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | England | British | 160087860001 | |||||
| DEVEY, Robert Alan | Administrateur | c/o C/O Jacqui Gregory Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | United Kingdom | British | 146956760001 | |||||
| DOWNING, Wadham St. John | Administrateur | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 203301710001 | |||||
| FITZPATRICK, James Bernard | Administrateur | 57 Hilbre Road West Kirby L48 3HB Wirral Merseyside | British | 67167690001 | ||||||
| FLOWER, Gordon Mark | Administrateur | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | England | British | 133025980001 | |||||
| FOX, Chay Munro | Administrateur | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 172112550001 | |||||
| HAINES, Stephen Paul | Administrateur | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | England | British | 185462290001 | |||||
| HALL, Peter Lindop | Administrateur | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 212005290001 | |||||
| HAYES, Peter Richard Downham | Administrateur | Herons Brook Chelford Road Prestbury SK10 4AW Macclesfield Cheshire | British | 9290230001 | ||||||
| JACOBS, Andrew Stephen | Administrateur | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 183659460001 | |||||
| JONES, Gaius Trefor Griffith | Administrateur | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | England | British | 57884740001 | |||||
| JONES, Peter Francis | Administrateur | 15 Wigton Park Close LS17 8UH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 33965180002 | |||||
| KAY, Kevin Joseph | Administrateur | 15 Melbourne Road Bramhall SK7 1LR Stockport Cheshire | British | 9290220001 | ||||||
| LAWSON, Frank Sydney | Administrateur | 79 Ack Lane East Bramhall SK7 2BH Stockport Cheshire | British | 9569030001 | ||||||
| MIDGLEY, Steven Richard | Administrateur | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | England | British | 186658380001 | |||||
| MITCHELL, Malcolm Jeremy | Administrateur | Yacht House Broad Lane Lower Heswall CH60 9JY Wirral | United Kingdom | British | 9639890004 | |||||
| MITFORD-SLADE, Nicola Claire | Administrateur | Moorgate EC2R 6AY London 25 England | United Kingdom | British | 276051890001 | |||||
| MULLORD, Kathleen Francis | Administrateur | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | United Kingdom | South African | 160087800001 | |||||
| NICHOLS, Sarah Elizabeth | Administrateur | 1 Home Farm Square Birstwith HG3 2WA Harrogate North Yorkshire | England | British | 93464600001 | |||||
| OWEN, Michael Sibberin | Administrateur | 19 Amersham Close SK10 2LF Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 37087430001 | |||||
| PEACOCK, Natasha Valerie | Administrateur | Pear Tree Drive SK15 2PY Stalybridge 7 Cheshire | England | British | 129803720001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilney Group Limited | 06 avr. 2016 | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Second legal charge | Créé le 16 oct. 2000 Livré le 19 oct. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti £240105 and all moneys due or to become due from the company or by plan invest limited to the chargee | |
Brèves mentions By way of second legal charge the f/h property k/a 9 king edward street macclesfield cheshire t/no CH180289. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 17 août 1992 Livré le 24 août 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 9 king edward street, macclesfield, cheshire, title number CH180289, and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 22 sept. 1981 Livré le 28 sept. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land formerly site of 9 king edward street. Macclesfield cheshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0