C & P PAPER WASTE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéC & P PAPER WASTE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01198312
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de C & P PAPER WASTE LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe C & P PAPER WASTE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de C & P PAPER WASTE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour C & P PAPER WASTE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christophe Andre Bernard Chapron le 26 juin 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 juil. 2012

    État du capital au 02 juil. 2012

    • Capital: GBP 60
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Nomination de Mr David Courtenay Palmer-Jones en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Joan Knight le 02 juil. 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christophe Andre Bernard Chapron le 02 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de C & P PAPER WASTE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KNIGHT, Joan
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    British80543820001
    CHAPRON, Christophe Andre Bernard
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    EnglandFrench122645500003
    PALMER-JONES, David Courtenay
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish125070620001
    COOKSON, Elaine Lewis
    21 Nuffield Drive
    WR9 0DJ Droitwich
    Worcestershire
    Secrétaire
    21 Nuffield Drive
    WR9 0DJ Droitwich
    Worcestershire
    British13011370002
    COOPER, Elizabeth Jayne Clare
    39 Church Road
    LU5 6LE Harlington
    Bedfordshire
    Secrétaire
    39 Church Road
    LU5 6LE Harlington
    Bedfordshire
    British3540250005
    LEWIS, Jack Malcolm
    Saddlers Croft Road
    TN6 1DS Crowborough
    East Sussex
    Secrétaire
    Saddlers Croft Road
    TN6 1DS Crowborough
    East Sussex
    British14038510001
    ST JOHNS SQUARE SECRETARIES LIMITED
    78 Hatton Garden
    EC1N 8JA London
    Secrétaire
    78 Hatton Garden
    EC1N 8JA London
    2469520001
    BOSHER, Trevor John
    Glebe Farm Church Lane
    Mixbury
    NN13 5RP Brackley
    Northamptonshire
    Administrateur
    Glebe Farm Church Lane
    Mixbury
    NN13 5RP Brackley
    Northamptonshire
    EnglandBritish52748340001
    COOKSON, David Jonathan
    21 Nuffield Drive
    WR9 0DJ Droitwich
    Worcestershire
    Administrateur
    21 Nuffield Drive
    WR9 0DJ Droitwich
    Worcestershire
    British13011360002
    COOKSON, Elaine Lewis
    21 Nuffield Drive
    WR9 0DJ Droitwich
    Worcestershire
    Administrateur
    21 Nuffield Drive
    WR9 0DJ Droitwich
    Worcestershire
    British13011370002
    GOODFELLOW, Ian Frederick
    Highlands Harewood Drive
    Cold Ash
    RG18 9PF Thatcham
    Berkshire
    Administrateur
    Highlands Harewood Drive
    Cold Ash
    RG18 9PF Thatcham
    Berkshire
    EnglandBritish28725450004
    GORDON, Marek Robert
    7 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    7 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20420300002
    MILLS, Stephen Terence
    Bonnibur Copthill Lane
    Kingswood
    KT20 6HL Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    Bonnibur Copthill Lane
    Kingswood
    KT20 6HL Tadworth
    Surrey
    EnglandBritish14038520001
    MILLS, Terrence George
    Headley Hill House Lorretta Lodge
    Tilley Lane, Headley
    KT18 6EP Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Headley Hill House Lorretta Lodge
    Tilley Lane, Headley
    KT18 6EP Epsom
    Surrey
    British71438230001
    SCARBOROUGH, Philip John
    Galedon House
    Hogs Back, Seale
    GU10 1JX Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Galedon House
    Hogs Back, Seale
    GU10 1JX Farnham
    Surrey
    EnglandBritish71437540001
    SCHLEISS, Gernot
    20 Brook Street
    Folly Bridge
    OX1 4LQ Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    20 Brook Street
    Folly Bridge
    OX1 4LQ Oxford
    Oxfordshire
    Austrian Director41098550001
    SEXTON, Ian Anthony
    31 Dedmere Road
    SL7 1PE Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    31 Dedmere Road
    SL7 1PE Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish33971310004
    SHERWIN, David Andrew
    212 Ferrymead Avenue
    Greenford
    UB6 9TP Middlesex
    Administrateur
    212 Ferrymead Avenue
    Greenford
    UB6 9TP Middlesex
    British10025660001
    STEVENSON, Michael Thomas
    Cornhill Hall
    Southampton Road
    SO32 1EF Bishops Waltham
    Hampshire
    Administrateur
    Cornhill Hall
    Southampton Road
    SO32 1EF Bishops Waltham
    Hampshire
    British11463330001
    ST JOHNS SQUARE SECRETARIES LIMITED
    78 Hatton Garden
    EC1N 8JA London
    Administrateur
    78 Hatton Garden
    EC1N 8JA London
    2469520001

    C & P PAPER WASTE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 14 juil. 1988
    Livré le 19 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 34 coneygre industrial estate, tipton, west midlands.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 13 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 14 juil. 1988
    Livré le 19 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over all the undertaking and all property and assets present and future book debts including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 13 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0