DAYSHAW LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDAYSHAW LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01203014
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DAYSHAW LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe DAYSHAW LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Cyrus Way Cygnet Park
    Hampton
    PE7 8HP Peterborough
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DAYSHAW LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour DAYSHAW LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Flat F, 29 Arundel Square London N7 8AS England à 4 Cyrus Way Cygnet Park Hampton Peterborough PE7 8HP le 16 avr. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 mars 2019

    LRESSP

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2018

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Peter Albert Lowery en tant que directeur le 20 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Falt F, 29 Arundel Square London N7 8AS England à Flat F, 29 Arundel Square London N7 8AS le 12 sept. 2018

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 6 Bullers Avenue Herne Bay Kent CT6 8UH à Falt F, 29 Arundel Square London N7 8AS le 12 sept. 2018

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sheila Joan Lowery le 22 août 2018

    2 pagesCH01

    Nomination de Sheila Joan Lowery en tant qu'administrateur le 20 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2017

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Evelyn Lowery en tant que secrétaire le 13 mars 2018

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Peter Albert Lowery en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2016

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 juin 2016

    État du capital au 27 juin 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juin 2015

    État du capital au 25 juin 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2014

    4 pagesAA

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de DAYSHAW LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LOWERY, Richard Martin John
    Grimston Road
    NG7 5QX Nottingham
    53
    England
    Administrateur
    Grimston Road
    NG7 5QX Nottingham
    53
    England
    United KingdomBritish117861460001
    LOWERY, Sheila Joan
    Arundel Square
    N7 8AS London
    Flat F 29
    England
    Administrateur
    Arundel Square
    N7 8AS London
    Flat F 29
    England
    EnglandBritish248660350002
    LOWERY, Evelyn
    Bullers Avenue
    CT6 8UH Herne Bay
    6
    Kent
    England
    Secrétaire
    Bullers Avenue
    CT6 8UH Herne Bay
    6
    Kent
    England
    Other131277980002
    LOWERY, Josephine Anne
    43 Bulcote Drive
    Burton Joyce
    NG14 5AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    43 Bulcote Drive
    Burton Joyce
    NG14 5AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    British23749280001
    LOWERY, Andrew Peter
    12 Newgate Close
    Carlton
    NG4 1BA Nottingham
    Administrateur
    12 Newgate Close
    Carlton
    NG4 1BA Nottingham
    EnglandBritish63439030002
    LOWERY, Josephine Anne
    43 Bulcote Drive
    Burton Joyce
    NG14 5AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    43 Bulcote Drive
    Burton Joyce
    NG14 5AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    British23749280001
    LOWERY, Peter Albert
    Bullers Avenue
    CT6 8UH Herne Bay
    6
    Kent
    England
    Administrateur
    Bullers Avenue
    CT6 8UH Herne Bay
    6
    Kent
    England
    EnglandBritish23749270004

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DAYSHAW LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Peter Albert Lowery
    Cygnet Park
    Hampton
    PE7 8HP Peterborough
    4 Cyrus Way
    06 avr. 2016
    Cygnet Park
    Hampton
    PE7 8HP Peterborough
    4 Cyrus Way
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.

    DAYSHAW LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 19 juil. 2006
    Livré le 22 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    111 alfreton road nottingham t/no NT27045. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 14 déc. 2001
    Livré le 18 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings k/a 99-109 (odd number only) alfreton road nottingham t/no: NT151534. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 03 oct. 2001
    Livré le 04 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 09 août 2001
    Livré le 18 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage 75-93 (odd nos. Only) alfreton road, nottingham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 25 janv. 1990
    Livré le 01 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All l/h land together with premises erected thereon and known as 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91 and 93 alfreton road, nottingham, nottinghamshire fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 08 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 11 août 1988
    Livré le 22 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H - 232 and 234 ilkeston road, nottingham, nottinghamshire. Title no. Nt 44810 fixed charge over plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 08 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 17 juin 1985
    Livré le 26 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    232 and 234 ilkeston road nottingham nottinghamshire title number nt 44810 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 juin 1985Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 25 juin 1984
    Livré le 07 juil. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 20 juin 1984
    Livré le 23 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold 232 & 234 ilkestone road, nottingham. Title no nt 44810 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transactions
    • 23 juin 1984Enregistrement d'une charge

    DAYSHAW LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 mars 2019Commencement of winding up
    08 juil. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Michael James Gregson
    Bulley Davey
    4 Cyrus Way
    PE7 8HP Cygnet Park
    Hampton Peterborough
    practitioner
    Bulley Davey
    4 Cyrus Way
    PE7 8HP Cygnet Park
    Hampton Peterborough

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0