ABALOID PLASTICS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéABALOID PLASTICS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01207928
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ABALOID PLASTICS LIMITED ?

    • (3663) /

    Où se situe ABALOID PLASTICS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BDO LLP
    Two
    Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ABALOID PLASTICS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ABALOID PLASTICS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    21 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 avr. 2019

    21 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 avr. 2018

    23 pagesLIQ03

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    4 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    18 pagesLIQ10

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 avr. 2017

    23 pagesLIQ03

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 avr. 2016

    21 pages4.68

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    pages2.34B

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:replacement liquidators
    12 pagesLIQ MISC OC

    Changement d'adresse du siège social de 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD à C/O Bdo Llp Two Snowhill Birmingham B4 6GA le 03 janv. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 avr. 2015

    20 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 avr. 2014

    13 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 avr. 2013

    10 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 20 avr. 2012

    13 pages2.24B

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 14 janv. 2012

    12 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B/2.15B

    8 pages2.16B

    Qui sont les dirigeants de ABALOID PLASTICS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURMAN, Paul Robert James
    c/o Bdo Llp
    Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two
    Administrateur
    c/o Bdo Llp
    Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two
    United KingdomBritish5664750002
    ELLIS, Christopher
    c/o Bdo Llp
    Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two
    Administrateur
    c/o Bdo Llp
    Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two
    United KingdomBritish110436820003
    HAMMOND, Philip Stuart
    c/o Bdo Llp
    Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two
    Administrateur
    c/o Bdo Llp
    Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Two
    United KingdomBritish107079110002
    MATTEY, Richard Kenneth
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    Secrétaire
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    British80594170001
    WHELDON, Lynda Carol
    5 Mill Drive
    Ratby
    LE6 0JH Leicester
    Leicestershire
    Secrétaire
    5 Mill Drive
    Ratby
    LE6 0JH Leicester
    Leicestershire
    British30540630001
    COWLEY, Andrew Frank
    15 Penny Close
    Longlevens
    GL2 0NP Gloucester
    Administrateur
    15 Penny Close
    Longlevens
    GL2 0NP Gloucester
    British40679600001
    ELLIS, Christopher
    34 Jubilee Avenue Asfordby
    LE14 3RY Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    34 Jubilee Avenue Asfordby
    LE14 3RY Melton Mowbray
    Leicestershire
    British110436820002
    MATTEY, Richard Kenneth
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    Administrateur
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    United KingdomBritish80594170001
    WHELDON, Lynda Carol
    5 Mill Drive
    Ratby
    LE6 0JH Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    5 Mill Drive
    Ratby
    LE6 0JH Leicester
    Leicestershire
    British30540630001
    WHELDON, Peter Alan
    5 Mill Drive
    Ratby
    LE6 0JH Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    5 Mill Drive
    Ratby
    LE6 0JH Leicester
    Leicestershire
    British30540640001

    ABALOID PLASTICS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 21 juin 2011
    Livré le 02 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 02 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 2009
    Livré le 01 oct. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 23 sept. 2009
    Livré le 25 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligor or any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Centric Spv 1 Limited
    Transactions
    • 25 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 14 juil. 2009
    Livré le 18 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Boy 30M 30 tonne horizontal hydraulic plastic injection moulding machine s/no 60764 (1990) boy 80M 80 tonne horizontal hydraulic plastic injection moulding machine s/no 87049 boy 50M 50 tonne horizontal hydraulic plastic injection moulding machine s/no 53740 for details of further plant and machinery charged please refer to form 395 the benefits arising under the policies any contracts relating to the plant and machinery floating charge all undertaking property rights and assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 18 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Créé le 14 juil. 2009
    Livré le 18 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 18 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 5TH september 1994
    Créé le 05 juin 2006
    Livré le 09 juin 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed charge over chattels
    Créé le 05 déc. 2005
    Livré le 07 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its present and future right title and interest in and to the following assets being cta 220 1973 negri bossi V218FA 1973 sandretto 2GV50 1979 for details of further assets charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Heller Limited
    Transactions
    • 07 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Créé le 16 mai 2005
    Livré le 18 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 18 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 5TH september 1994 and
    Créé le 22 juin 2004
    Livré le 29 juin 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum of sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge over all assets
    Créé le 05 mars 2004
    Livré le 10 mars 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Ge Heller Limited
    Transactions
    • 10 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 18 oct. 1989
    Livré le 25 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 1983
    Livré le 03 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See doc M24). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 janv. 1984Enregistrement d'une charge

    ABALOID PLASTICS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 avr. 2012Administration ended
    15 juil. 2011Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Harry Gilbert
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    practitioner
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    practitioner
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    2
    DateType
    01 oct. 2020Dissolved on
    20 avr. 2012Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Harry Gilbert
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    practitioner
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    practitioner
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    practitioner
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Martha Hanora Thompson
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    practitioner
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Ian James Gould
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    practitioner
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0