COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED

COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01208652
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Composites House
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Derbyshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 21 déc. 2016

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Authority to have minimum number of directors as one 12/12/2016
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prm a/c 12/12/2016
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Roy Douglas Smith en tant que directeur le 30 août 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Daniel George Darazsdi en tant que directeur le 30 août 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Alison Murphy en tant que secrétaire le 30 août 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Roy Douglas Smith en tant que secrétaire le 30 août 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Adrianus Laurentius Schiebroek en tant qu'administrateur le 30 août 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juin 2016

    État du capital au 07 juin 2016

    • Capital: GBP 640,100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 juin 2015

    État du capital au 03 juin 2015

    • Capital: GBP 640,100
    SH01

    Nomination de Mr Daniel George Darazsdi en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Daniel George Darazsdi en tant qu'administrateur le 01 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David M Drillock en tant que directeur le 31 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2013

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 juin 2014

    État du capital au 10 juin 2014

    • Capital: GBP 640,100
    SH01

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2012

    9 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MURPHY, Alison
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Secrétaire
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    214334930001
    SCHIEBROEK, Adrianus Laurentius
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Administrateur
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    NetherlandsDutch214317980001
    BOWERS, Steven John
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    British61929330004
    LEE, Maurice Milson
    90 Giffords Cross Road
    SS17 7QQ Corringham
    Essex
    Secrétaire
    90 Giffords Cross Road
    SS17 7QQ Corringham
    Essex
    British115467610001
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Secrétaire
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    171432740001
    BEAUMONT, Richard John Kirby
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    British98953190001
    BOWERS, Steven John
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Administrateur
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    United KingdomBritish176189250001
    CULNANE, Paul Alexander
    21 Oxhouse Court
    Shenley Brook End
    MK5 7GL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    21 Oxhouse Court
    Shenley Brook End
    MK5 7GL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    UkBritish107502650001
    DARAZSDI, Daniel George
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Administrateur
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    UsaAmerican195049720001
    DRILLOCK, David M
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    United StatesAmerican170878740001
    GREEN, Paul Andrew
    2 Jubilee Villas
    Dassels
    SG11 2RW Braughing
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Jubilee Villas
    Dassels
    SG11 2RW Braughing
    Hertfordshire
    United KingdomBritish109248560001
    HART, David John
    18 Farrow Gardens
    RM16 2EU Grays
    Essex
    Administrateur
    18 Farrow Gardens
    RM16 2EU Grays
    Essex
    British68384420001
    HASLEHURST, Peter Joseph Kinder
    Old Crowholt Farm
    Cowbrook Lane Gawsworth
    SK11 0JH Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Old Crowholt Farm
    Cowbrook Lane Gawsworth
    SK11 0JH Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish39820040001
    HAWKINS, Ian Roger
    The Old Colley Farm
    Coppice Lane
    RH2 9JE Reigate
    Surrey
    Administrateur
    The Old Colley Farm
    Coppice Lane
    RH2 9JE Reigate
    Surrey
    British15991450002
    HOBBS, Jeffrey Jacques
    1 Cedar Copse
    BR1 2NY Bromley
    Kent
    Administrateur
    1 Cedar Copse
    BR1 2NY Bromley
    Kent
    British3252730001
    LEE, Maurice Milson
    90 Giffords Cross Road
    SS17 7QQ Corringham
    Essex
    Administrateur
    90 Giffords Cross Road
    SS17 7QQ Corringham
    Essex
    British115467610001
    LIDDLE, Matthew
    54 High Street
    MK45 5DY Flitton
    Bedfordshire
    Administrateur
    54 High Street
    MK45 5DY Flitton
    Bedfordshire
    United KingdomBritish35090550001
    LONG, Peter Terence
    43 Kelso Close
    Worth
    RH10 7XH Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    43 Kelso Close
    Worth
    RH10 7XH Crawley
    West Sussex
    British68384400001
    MARTIN, David Barrington
    6 Copse Lane The Copse
    Hamble
    SO31 4QH Southampton
    Administrateur
    6 Copse Lane The Copse
    Hamble
    SO31 4QH Southampton
    British44386840006
    MCKNIGHT, William John
    75 Ashley Road
    KT18 5BN Epsom
    Surrey
    Administrateur
    75 Ashley Road
    KT18 5BN Epsom
    Surrey
    British6788940001
    MOSS, Andrew Brian
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Administrateur
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    PARKINSON, John
    7 Stourton Mews
    Stourton Road
    LS29 9BQ Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    7 Stourton Mews
    Stourton Road
    LS29 9BQ Ilkley
    West Yorkshire
    British10307790001
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Administrateur
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritish123487130001
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    UsaUsa170877010001
    SNOWDON, Clive John
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritish32242700001
    WALKER, Joan Elizabeth
    3 Meadow View
    Bicknacre
    CM3 4HR Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    3 Meadow View
    Bicknacre
    CM3 4HR Chelmsford
    Essex
    British28418730001
    WALKER, John Siddall
    The Thatched Barn Eye Road
    IP21 5BA Hoxne
    Suffolk
    Administrateur
    The Thatched Barn Eye Road
    IP21 5BA Hoxne
    Suffolk
    English10306840004
    WHYTE, James Stevenson
    9 Palmers Croft
    CM2 6SR Chelmsford
    Administrateur
    9 Palmers Croft
    CM2 6SR Chelmsford
    British97922850002

    COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 11 déc. 2009
    Livré le 30 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement 27TH october 1997,
    Créé le 23 nov. 2006
    Livré le 29 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/10/1997
    Créé le 16 juil. 2004
    Livré le 22 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 13 févr. 1996
    Livré le 01 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Compstock house, london road, stanford le hope by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 17 juin 1994
    Livré le 23 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 mai 1994
    Livré le 06 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 06 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further charge and mortgage
    Créé le 22 déc. 1989
    Livré le 05 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £20,000 and all other monies due or to become due from the company and/or ian robert hawkins to the chargee
    Brèves mentions
    F/H compstock house, london road stanford le hope essex. Title no ex 226930.
    Personnes ayant droit
    • Sun Alliance and London Assurance Company Limited
    Transactions
    • 05 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 15 nov. 1988
    Livré le 17 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £200,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H compstock house london road stanford le hope essex title no. Ex 226930.
    Personnes ayant droit
    • Sun Alliance and London Assurance Co. LTD.
    Transactions
    • 17 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 sept. 1988
    Livré le 04 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings k/a compstock house, lying on the north side of london road, stanford le-hope, essex title no: ex 226930.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 07 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 juin 1987
    Livré le 09 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 juin 1987Enregistrement d'une charge
    Further charge and mortgage and deed of variation
    Créé le 05 oct. 1984
    Livré le 10 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Varies the amount secured by the mortgage dated 14TH december 1979 to £150,000
    Brèves mentions
    All that land & office building k/a compstock house london road stanford-le-hope in the county of essex with freehold title absolute under title no. EX226930 (nb: formerly k/a steadeal house).
    Personnes ayant droit
    • Phoenix Assurance Public Limited Company
    Transactions
    • 10 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 06 avr. 1984
    Livré le 16 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over book & other debts floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts (exc those mentioned aove) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    Deed of variation
    Créé le 08 août 1980
    Livré le 09 août 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Varies the amount secured by the mortgage d/d 14/12/78 to £50,000 regd 9/8/80.
    Brèves mentions
    Varying terms of a mortgage d/d 14/12/78 so as to limit the sum of money charged by the mortgage to £50,000.
    Personnes ayant droit
    • Brown Shipley & Co LTD
    Transactions
    • 09 août 1980Enregistrement d'une charge
    • 20 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0