STEAMHAMMER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTEAMHAMMER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01211110
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STEAMHAMMER LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe STEAMHAMMER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STEAMHAMMER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KETLON (U.K.) LIMITED06 mai 197506 mai 1975

    Quels sont les derniers comptes de STEAMHAMMER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour STEAMHAMMER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 04 sept. 2012

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    5 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share prem a/c cancelled 24/08/2012
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Nomination de Graham Philip Brisley Veal en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kevin Blades en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Thomas Doerr en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Adrian David Gray en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de STEAMHAMMER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Administrateur
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Administrateur
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Administrateur
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Administrateur
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Secrétaire
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SHAW, Roger
    182 Ramsgate Road
    CT10 2EW Broadstairs
    Kent
    Secrétaire
    182 Ramsgate Road
    CT10 2EW Broadstairs
    Kent
    British62309470001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Secrétaire
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    BENSLEY, Brian
    The Coppice
    20 Neville Park
    TN4 8NN Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    The Coppice
    20 Neville Park
    TN4 8NN Tunbridge Wells
    Kent
    British41841490002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Administrateur
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BOWKETT, Alan John
    Croxton Park
    Croxton
    PE19 6SY St Neots
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Croxton Park
    Croxton
    PE19 6SY St Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish33301630002
    BRAY, Kenneth Ivor
    Garden Cottage Church Street
    Denton
    NG32 1LE Grantham
    Lincolnshire
    Administrateur
    Garden Cottage Church Street
    Denton
    NG32 1LE Grantham
    Lincolnshire
    British45153770001
    BUTLER, Peter Robert
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    British34707070001
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DIXON, Peter John Bellett, Sir
    34 Canonbury Park North
    N1 2JJ London
    Administrateur
    34 Canonbury Park North
    N1 2JJ London
    United KingdomBritish4902740001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Administrateur
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    GILL, Martin John
    24 Parkwood Road
    Wimbledon
    SW19 7AQ London
    Administrateur
    24 Parkwood Road
    Wimbledon
    SW19 7AQ London
    EnglandBritish58291030001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    MULHALL, Denis Joseph
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    Administrateur
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    EnglandBritish,Irish32235150003
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    Administrateur désigné
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    SIMON, Avram Ben
    11 Cenacle Close
    West Heath Road
    NW3 7UE London
    Administrateur
    11 Cenacle Close
    West Heath Road
    NW3 7UE London
    EnglandBritish10668930001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    STEAMHAMMER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Créé le 11 avr. 2002
    Livré le 25 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transactions
    • 25 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Créé le 20 févr. 2002
    Livré le 08 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transactions
    • 08 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Créé le 20 nov. 2001
    Livré le 30 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of gurantee & debenture
    Créé le 08 mai 1989
    Livré le 23 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany and/or wichman bennett machine tool company limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The several properties specified or form M395, together with (see form M395, ref M520C per full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Berisford International PLC
    Transactions
    • 23 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 22 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Gurantee & debenture
    Créé le 24 mai 1985
    Livré le 13 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from transmake limited to the chargee under the terms of the loan facility dated 24 may'85
    Brèves mentions
    Land & buildings at paddock wood kent title no. 528918 and adjacent industrial units title no's K.347491,K.407742,K.343687K.354594 And K.493938. also l/h land at paddock wood title no.K33621 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinerty including stock in trade.
    Personnes ayant droit
    • S & W Berisford PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    • 22 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 04 déc. 1984
    Livré le 05 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 3/4/84
    Brèves mentions
    One okuma latle LC20-r-2SC nc lathe (ncmt no 1527 serial no 0912 together with swarf conveyor system, cutting tools transfer conveyor system and central processing unit including display and interface.
    Personnes ayant droit
    • Security Pacific International Leasing (Europe) Inc.
    Transactions
    • 05 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 03 avr. 1984
    Livré le 05 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 3RD april 1984 and/or this deed.
    Brèves mentions
    One ohuma LC20R-25C N.C. lathe (nomt number 1489 serial number 0884) together with swarf conveyer systems, aitting tool, transfer conveyer system and central processing unit including display and intenface.
    Personnes ayant droit
    • Security Pacific International Leasing (Europe) Inc.
    Transactions
    • 05 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 19 juil. 1983
    Livré le 25 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £250,000 and other monies due under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Build no goods serial no 2024 churchill 5815 rigid hobber - 2036 chirchill 5815 rigid hobber - 2026 chirchill 5815 rigid hobber - 2035 churchill 5815 rigid hobber H966 1028 wickman 71/4 x 6" chucker 620806 1029 wickman 71/4 x 6" chucker 550206.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 07 janv. 1983
    Livré le 27 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific aquitable charge over all f/hold & l/hold properties. Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill licenses together with the machinery and equipment specified in the debenture. Legal mortgage over l/hold land on the north and south sides of lucknow road, paddock wood, tunbridge wells, kent. Title no. K528918.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Trust Company of Canada.
    Transactions
    • 27 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 07 janv. 1983
    Livré le 27 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges over undertaking and all property including l/hold land on the north and south sides of lucknow road, paddock wood, tunbridge wells kent. Title no. K528918.
    Personnes ayant droit
    • The Govenor & Company of the Bank of Ireland.
    Transactions
    • 27 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 03 nov. 1982
    Livré le 08 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £2,500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    L/H lying on the north & south sides of lucknow road padolock wood dunbridge wells title no. K528918.
    Personnes ayant droit
    • Norwich General Trust Limited
    Transactions
    • 08 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    Supplemental charge
    Créé le 21 juin 1982
    Livré le 23 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Further securing the monies secured by the principal deed dated 16 dec'81.
    Brèves mentions
    Specific charge all bookdebts & other debts at present or in future owing to the company for full details please see doc M21.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Investment Bank
    Transactions
    • 23 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 25 mai 1982
    Livré le 27 mai 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £4808,000.
    Brèves mentions
    Various spindle bar automotic with tooling and accesseries. For full details please see document M20.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Finance Company Limited
    Transactions
    • 27 mai 1982Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 16 déc. 1981
    Livré le 30 déc. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific fixed charge over all plant & machinery present & future undertaking and all assets present and future and specfically including the leasehold land with buildings now or hereafter situate thereon bying on the north side of hucksnow road paddocks wood, tunbridge well kent.
    Personnes ayant droit
    • N. V. Tlavenburg's Banks.
    Transactions
    • 30 déc. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 16 déc. 1981
    Livré le 30 déc. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    8 eldon way paddocks wood, kent (leasehold) title no. K347491 44 eldon way paddocks wood, kent (leasehold) title no. K354594.
    Personnes ayant droit
    • N. V Tlavenburg's Banks
    Transactions
    • 30 déc. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 16 déc. 1981
    Livré le 30 déc. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    22 to 36 (even numbers) eldon way paddocls wood, tunbridge wells, kent (leasehold). Title no. K493938.
    Personnes ayant droit
    • N.V Tlavenburg's Banks.
    Transactions
    • 30 déc. 1981Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 16 déc. 1981
    Livré le 24 déc. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All estates or interests many f/hold and l/hold property. All stocks, shares and other securities or other interests, goodwill, all its other property, assets and rights and all undertaking & other property, assets & rights.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Investment Banks Limited
    Transactions
    • 24 déc. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 16 déc. 1981
    Livré le 24 déc. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold property, land & buildings at hucknow road, paddocls wood, tunbridge wells, kent.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Investment Bank Limited
    Transactions
    • 24 déc. 1981Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 14 oct. 1980
    Livré le 15 oct. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £207,000
    Brèves mentions
    One wickman 1 3/8" six spindle bar automatic no 590071. one cone aut omotic machine company conomatic 4" six spindle bar automatic no.833652. One wickman 2 1/4" six spindle automotic no. 601327. threewickman 1" six spindle bar automatics nos. 610122,560243 & 551040 (see doc M14).
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Finance Company Limited.
    Transactions
    • 15 oct. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0