FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED

FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01222422
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits en plastique (22290) / Industries manufacturières

    Où se situe FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    County Durham
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 21 mars 2019

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de Stuart Clive Ward en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 déc. 2017

    1 pagesPSC07

    Cessation de la nomination de Stuart Clive Ward en tant que directeur le 13 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    26 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2017 avec mises à jour

    7 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    26 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 avr. 2016

    État du capital au 01 avr. 2016

    • Capital: GBP 1,275
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin David Parker le 01 avr. 2016

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Louis-Marie Allain le 01 avr. 2016

    1 pagesCH03

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Changement d'adresse du siège social de Fearby Road Masham Ripon North Yorkshire HG4 4ES à 1 Greencroft Industrial Park Stanley County Durham DH9 7YA le 19 nov. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    25 pagesAA

    Nomination de Mr Kevin David Parker en tant qu'administrateur le 15 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 avr. 2015

    État du capital au 08 avr. 2015

    • Capital: GBP 1,275
    SH01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    26 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 mars 2014

    État du capital au 31 mars 2014

    • Capital: GBP 1,275
    SH01

    Qui sont les dirigeants de FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALLAIN, Louis-Marie
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    Secrétaire
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    British173519410001
    PARKER, Kevin David
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    Administrateur
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    EnglandBritishFinance Director176767670001
    HALL, Stephen
    Whitcliffe Lane
    HG4 2JL Ripon
    14
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Whitcliffe Lane
    HG4 2JL Ripon
    14
    North Yorkshire
    BritishAccountant8374520006
    HATTERSLEY, Jane Margaret
    The Bell House
    Southtown
    TQ6 9BU Dartmouth
    Devon
    Secrétaire
    The Bell House
    Southtown
    TQ6 9BU Dartmouth
    Devon
    British25206800002
    TOBIN, John
    High Hoyland Lane
    High Hoyland
    S75 4AY Barnsley
    Friezland House
    South Yorkshire
    Secrétaire
    High Hoyland Lane
    High Hoyland
    S75 4AY Barnsley
    Friezland House
    South Yorkshire
    146592720001
    TOBIN, John
    High Hoyland Lane
    High Hoyland
    S75 4AY Barnsley
    Friezland House
    South Yorkshire
    Secrétaire
    High Hoyland Lane
    High Hoyland
    S75 4AY Barnsley
    Friezland House
    South Yorkshire
    146638930001
    ALLEN, Alice Caroline
    Spring Croft
    Sibbertoft
    LE16 9UA Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    Spring Croft
    Sibbertoft
    LE16 9UA Market Harborough
    Leicestershire
    BritishScientist5617810002
    COWAN, Andrew Thomas Douglas
    17 Thatchmeadow Drive
    LE16 7XH Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    17 Thatchmeadow Drive
    LE16 7XH Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritishCo Director119734740001
    HADWIN, Ian Rex
    Fearby Road
    Masham
    HG4 4ES Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    Fearby Road
    Masham
    HG4 4ES Ripon
    North Yorkshire
    New ZealandNew ZealanderDirector200837880001
    HALL, Stephen
    Whitcliffe Lane
    HG4 2JL Ripon
    14
    North Yorkshire
    Administrateur
    Whitcliffe Lane
    HG4 2JL Ripon
    14
    North Yorkshire
    EnglandBritishAccountant8374520006
    HATTERSLEY, Bruce Sean, Dr
    3 Golf Lane
    Church Brampton
    NN6 8AY Northampton
    Administrateur
    3 Golf Lane
    Church Brampton
    NN6 8AY Northampton
    BritishScientist84370340001
    HATTERSLEY, Robert Merlin
    The Bell House
    Southtown
    TQ6 9BU Dartmouth
    Devon
    Administrateur
    The Bell House
    Southtown
    TQ6 9BU Dartmouth
    Devon
    BritishGeneral Manager34435280002
    MAXWELL-SCOTT, Ian
    Pondtail House
    West Hill Bank
    RH8 9JD Oxted
    Surrey
    Administrateur
    Pondtail House
    West Hill Bank
    RH8 9JD Oxted
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director34876790001
    MUIR, Gregory John
    Fearby Road
    Masham
    HG4 4ES Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    Fearby Road
    Masham
    HG4 4ES Ripon
    North Yorkshire
    New ZealandNew ZealanderDirector153595780002
    TOBIN, John
    High Hoyland Lane
    High Hoyland
    S75 4AY Barnsley
    Friezland House
    South Yorkshire
    Administrateur
    High Hoyland Lane
    High Hoyland
    S75 4AY Barnsley
    Friezland House
    South Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant2317870002
    WARD, Stuart Clive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    Administrateur
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    United KingdomBritishManaging Director176383190001
    WILDRIDGE, Stephen Michael
    Fearby Road
    Masham
    HG4 4ES Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    Fearby Road
    Masham
    HG4 4ES Ripon
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director64854610001
    WILLS HILL MARQUESS OF DOWNSHIRE, Arthur Francis Nicholas, Lord
    Clifton Castle
    Clifton
    HG4 4AB Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    Clifton Castle
    Clifton
    HG4 4AB Ripon
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector60546920001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Stuart Clive Ward
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    06 avr. 2016
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Kevin David Parker
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    06 avr. 2016
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Louis-Marie Allain
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    06 avr. 2016
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    Non
    Nationalité: French
    Pays de résidence: France
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 17 sept. 2010
    Livré le 29 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Asb Bank Limited
    Transactions
    • 29 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 14 janv. 2008
    Livré le 18 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 juin 2006
    Livré le 20 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 juin 2001
    Livré le 06 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monie due or to become due from the company and or ritchey tagg limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 juil. 1993
    Livré le 03 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0