FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01222422 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ?
Adresse du siège social | 1 Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley County Durham England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 21 mars 2019
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de Stuart Clive Ward en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 déc. 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stuart Clive Ward en tant que directeur le 13 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 26 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2017 avec mises à jour | 7 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 26 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin David Parker le 01 avr. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Louis-Marie Allain le 01 avr. 2016 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Fearby Road Masham Ripon North Yorkshire HG4 4ES à 1 Greencroft Industrial Park Stanley County Durham DH9 7YA le 19 nov. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 25 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Kevin David Parker en tant qu'administrateur le 15 avr. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 26 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLAIN, Louis-Marie | Secrétaire | Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley 1 County Durham England | British | 173519410001 | ||||||
PARKER, Kevin David | Administrateur | Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley 1 County Durham England | England | British | Finance Director | 176767670001 | ||||
HALL, Stephen | Secrétaire | Whitcliffe Lane HG4 2JL Ripon 14 North Yorkshire | British | Accountant | 8374520006 | |||||
HATTERSLEY, Jane Margaret | Secrétaire | The Bell House Southtown TQ6 9BU Dartmouth Devon | British | 25206800002 | ||||||
TOBIN, John | Secrétaire | High Hoyland Lane High Hoyland S75 4AY Barnsley Friezland House South Yorkshire | 146592720001 | |||||||
TOBIN, John | Secrétaire | High Hoyland Lane High Hoyland S75 4AY Barnsley Friezland House South Yorkshire | 146638930001 | |||||||
ALLEN, Alice Caroline | Administrateur | Spring Croft Sibbertoft LE16 9UA Market Harborough Leicestershire | British | Scientist | 5617810002 | |||||
COWAN, Andrew Thomas Douglas | Administrateur | 17 Thatchmeadow Drive LE16 7XH Market Harborough Leicestershire | England | British | Co Director | 119734740001 | ||||
HADWIN, Ian Rex | Administrateur | Fearby Road Masham HG4 4ES Ripon North Yorkshire | New Zealand | New Zealander | Director | 200837880001 | ||||
HALL, Stephen | Administrateur | Whitcliffe Lane HG4 2JL Ripon 14 North Yorkshire | England | British | Accountant | 8374520006 | ||||
HATTERSLEY, Bruce Sean, Dr | Administrateur | 3 Golf Lane Church Brampton NN6 8AY Northampton | British | Scientist | 84370340001 | |||||
HATTERSLEY, Robert Merlin | Administrateur | The Bell House Southtown TQ6 9BU Dartmouth Devon | British | General Manager | 34435280002 | |||||
MAXWELL-SCOTT, Ian | Administrateur | Pondtail House West Hill Bank RH8 9JD Oxted Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 34876790001 | ||||
MUIR, Gregory John | Administrateur | Fearby Road Masham HG4 4ES Ripon North Yorkshire | New Zealand | New Zealander | Director | 153595780002 | ||||
TOBIN, John | Administrateur | High Hoyland Lane High Hoyland S75 4AY Barnsley Friezland House South Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 2317870002 | ||||
WARD, Stuart Clive | Administrateur | Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley 1 County Durham England | United Kingdom | British | Managing Director | 176383190001 | ||||
WILDRIDGE, Stephen Michael | Administrateur | Fearby Road Masham HG4 4ES Ripon North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 64854610001 | ||||
WILLS HILL MARQUESS OF DOWNSHIRE, Arthur Francis Nicholas, Lord | Administrateur | Clifton Castle Clifton HG4 4AB Ripon North Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 60546920001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr Stuart Clive Ward | 06 avr. 2016 | Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley 1 County Durham England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Kevin David Parker | 06 avr. 2016 | Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley 1 County Durham England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Louis-Marie Allain | 06 avr. 2016 | Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley 1 County Durham England | Non |
Nationalité: French Pays de résidence: France | |||
Nature du contrôle
|
FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 17 sept. 2010 Livré le 29 sept. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 14 janv. 2008 Livré le 18 janv. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 01 juin 2006 Livré le 20 juin 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 28 juin 2001 Livré le 06 juil. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monie due or to become due from the company and or ritchey tagg limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 22 juil. 1993 Livré le 03 août 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0