SIG MANUFACTURING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SIG MANUFACTURING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01223374 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SIG MANUFACTURING LIMITED ?
| Adresse du siège social | Adsetts House 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SIG MANUFACTURING LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SIG MANUFACTURING LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 sept. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 20 sept. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 sept. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SIG MANUFACTURING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 14 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2024 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 14 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 août 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 31 déc. 2022 | 13 pages | AAMD | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 15 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 août 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 14 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 août 2022 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 20 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Kulbinder Kaur Dosanjh en tant que directeur le 31 mars 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Andrew Watkins en tant qu'administrateur le 31 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Kulbinder Kaur Dosanjh en tant que secrétaire le 31 mars 2021 | 1 pages | TM02 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Kulbinder Kaur Dosanjh le 22 déc. 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 21 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 août 2020 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Ms Kulbinder Kaur Dosanjh en tant que secrétaire le 18 oct. 2019 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Ms Kulbinder Kaur Dosanjh en tant qu'administrateur le 18 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Charles Monro en tant que secrétaire le 18 oct. 2019 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Richard Charles Monro en tant que directeur le 18 oct. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 oct. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 oct. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de SIG MANUFACTURING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON, Ian | Administrateur | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | 186473820002 | |||||
| WATKINS, Andrew | Administrateur | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | England | British | 281612300001 | |||||
| COLEY, James Robert Ewen | Secrétaire | Herongate 39 Meadow Drive SK10 4EY Prestbury Cheshire | British | 68949300004 | ||||||
| DE ROZARIEUX, Mark Ian | Secrétaire | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | British | 258862460001 | ||||||
| DOSANJH, Kulbinder Kaur | Secrétaire | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | 263822920001 | |||||||
| DUNKLEY, Robert Trevor | Secrétaire | 48 Sagars Road SK9 3EE Handforth Cheshire | British | 74295260001 | ||||||
| ELLIS, Martyn Anthony | Secrétaire | 415 Caraway Apartments 2 Cayenne Court SE1 2PP Shad Thames London | British | 95749550001 | ||||||
| JAMES, Nigel Rodney | Secrétaire | 24 Rose Vale SK8 3RN Cheadle Cheshire | British | 31370880003 | ||||||
| MONRO, Richard Charles | Secrétaire | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | British | 59480370001 | ||||||
| RIPPON, Anthony William | Secrétaire | Medway Burrow Bridge TA7 0RM Bridgwater Somerset | British | 764170001 | ||||||
| ALTMAN, Roderick Craig | Administrateur | 228 Graham Road Ranmoor S10 3GS Sheffield | England | British | 27373030003 | |||||
| BURRAGE, Michael James | Administrateur | 1 Coniston Road Beeston NG9 3AD Nottingham | British | 31370860003 | ||||||
| CLEMENT, Craig Darren | Administrateur | Oaklands Avenue Adel LS16 8NR Leeds 34 United Kingdom | England | British | 102403040003 | |||||
| DAVIES, Gareth Wyn | Administrateur | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | England | British | 109674760001 | |||||
| DE ROZARIEUX, Mark Ian | Administrateur | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British | 258862460001 | |||||
| DERBYSHIRE, Michael Joseph Christian | Administrateur | The Hill Whitmore ST5 5HU Newcastle Under Lyme Staffordshire | England | British | 11458180003 | |||||
| DOSANJH, Kulbinder Kaur | Administrateur | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 231199720003 | |||||
| EATON, Kevin Raymond | Administrateur | 66 High La West West Hallam DE7 6HQ Ilkeston Derbyshire | United Kingdom | British | 65885140001 | |||||
| ELLIS, Martyn Anthony | Administrateur | 415 Caraway Apartments 2 Cayenne Court SE1 2PP Shad Thames London | British | 95749550001 | ||||||
| GOODING, Ian Roy | Administrateur | Westforde Oatlands Avenue, Bishops Tawton EX32 0AZ Barnstaple Devon | British | 57357290002 | ||||||
| GOOLD, Peter Anthony | Administrateur | Oxenber Cottage Graystonber Lane Austwick LA2 8BJ Lancaster | British | 38778930001 | ||||||
| HARDY, John Donald | Administrateur | 9 Stratton Park Tranby Lane HU14 3NN Swanland North Humberside | British | 100779000001 | ||||||
| JAMES, Nigel Rodney | Administrateur | 24 Rose Vale SK8 3RN Cheadle Cheshire | British | 31370880003 | ||||||
| LEAHY, Jeffrey Michael | Administrateur | Willow Tree Grove Heron Cross ST4 3BF Stoke On Trent 47 Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 166683030001 | |||||
| MCARDELL, Robert Graham | Administrateur | 12 Gorse Bank Road Halebarns WA15 0AL Altrincham Cheshire | British | 3191770001 | ||||||
| MCDOUGALL, Bryan Garner | Administrateur | 1 Hoggs Field Eastwood NG16 3HN Nottingham Nottinghamshire | British | 65884670001 | ||||||
| MONRO, Richard Charles | Administrateur | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | 59480370001 | |||||
| O'CALLAGHAN, Michael John | Administrateur | West End Rise Horsforth LS18 5JL Leeds 48 United Kingdom | United Kingdom | British | 54122260002 | |||||
| ROE, Darren | Administrateur | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | England | British | 106708580001 | |||||
| SMITH, Simon David | Administrateur | Bashley Cross Road BH25 5SY New Milton Oakmead Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 81813260002 | |||||
| SWINGLER, Michael | Administrateur | 32 Manor Road SK7 3LY Bramhall Cheshire | British | 97335940001 | ||||||
| WAKEMAN, Timothy Roy | Administrateur | 35a High Street CB10 1AT Saffron Walden Essex | British | 42178650002 | ||||||
| WILLIAMS, David | Administrateur | 48 Wood Lane Wickersley S66 1JX Rotherham "Merrymede" South Yorkshire | England | English | 127986830001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SIG MANUFACTURING LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leaderflush + Shapland Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0