NORTH SHOE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORTH SHOE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01223702
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORTH SHOE LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe NORTH SHOE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Trident Business Park
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NORTH SHOE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BROWN & JACKSON (RETAIL) LIMITED08 oct. 198708 oct. 1987
    BROWN & JACKSON (DEVELOPMENTS) LIMITED21 août 197521 août 1975

    Quels sont les derniers comptes de NORTH SHOE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour NORTH SHOE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 oct. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 08 août 2017

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Hemant Patel en tant qu'administrateur le 27 nov. 2015

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian York en tant que directeur le 27 nov. 2015

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 nov. 2015

    État du capital au 19 nov. 2015

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Nomination de Ian York en tant qu'administrateur le 25 mars 2015

    AP01

    Cessation de la nomination de Roy George Ellis en tant que directeur le 25 mars 2015

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 oct. 2014

    État du capital au 13 oct. 2014

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 nov. 2013

    État du capital au 19 nov. 2013

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Abdul Aziz Tayub le 23 mai 2013

    3 pagesCH01

    Nomination de Mr Roy George Ellis en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ebrahim Suleman en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de NORTH SHOE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COLLINSON, Martin Donald
    1 Badger Gate
    Meltham
    HD9 5LB Holmfirth
    Secrétaire
    1 Badger Gate
    Meltham
    HD9 5LB Holmfirth
    British98796330005
    PATEL, Hemant
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Administrateur
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish104124100001
    TAYUB, Abdul Aziz
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Administrateur
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish16280660001
    KEMP, Helen Anne
    5 Birch Mews Oaklands Manor
    Long Causeway Adel
    LS16 8NX Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    5 Birch Mews Oaklands Manor
    Long Causeway Adel
    LS16 8NX Leeds
    West Yorkshire
    British48922660002
    KERRISON, Michael Arthur
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    British1452630001
    LETHAM, Ian Ritchie
    45 Palin Wood Road
    Delph
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    Secrétaire
    45 Palin Wood Road
    Delph
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    British9252900001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South African40527920003
    SISSON, Hamish Paul
    20 Park View Court
    29 Street Lane
    LS8 1BS Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    20 Park View Court
    29 Street Lane
    LS8 1BS Leeds
    West Yorkshire
    British43874820001
    BROWN, Gary James
    3 Dewberry Fields
    Upholland
    WN8 0BQ Skelmersdale
    Lancashire
    Administrateur
    3 Dewberry Fields
    Upholland
    WN8 0BQ Skelmersdale
    Lancashire
    EnglandBritish125196870001
    BURDON, Peter
    40 Firs Road
    Edwalton
    NG12 4BX Nottingham
    Administrateur
    40 Firs Road
    Edwalton
    NG12 4BX Nottingham
    British70178470002
    CLARKE, Paul
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    British103719400001
    ELLIS, Robert Keith
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    Administrateur
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish45171010001
    ELLIS, Roy George
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Administrateur
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    WalesBritish161784490001
    GRAY, Ian
    Flat 48 Langtons Wharf
    LS2 7EN Leeds
    Yorkshire
    Administrateur
    Flat 48 Langtons Wharf
    LS2 7EN Leeds
    Yorkshire
    British50246030002
    HAUGHTON, Townsend Andrew
    Staddlestones
    11 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Staddlestones
    11 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    South Africa39356840002
    KERRISON, Michael Arthur
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    British1452630001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South African40527920003
    SMITH, Martin Freeman
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    Administrateur
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    British44140230002
    SULEMAN, Ebrahim
    8 St Marys Avenue
    WF17 7PT Batley
    West Yorkshire
    Administrateur
    8 St Marys Avenue
    WF17 7PT Batley
    West Yorkshire
    EnglandBritish52733940001
    VISSER, Johan Jacobus
    22 Mackenzie Gardens
    East Kilbride
    G74 4SA Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    22 Mackenzie Gardens
    East Kilbride
    G74 4SA Glasgow
    Lanarkshire
    South African51820380002
    YORK, Ian
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Administrateur
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish197002910001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NORTH SHOE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Instore Limited
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement00347453
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    NORTH SHOE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 mars 1996
    Livré le 17 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the beneficiaries (as therein defined) under or pursuant to the guarantee (as therein defined) and the expenses (as therein defined) (provided that any expenses incurred prior to an enforcement event (as therein defined) shall be consented to by poundstretcher limited and interest (as therein defined)
    Brèves mentions
    The property as described on the form 395 and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nedcor Bank Limited
    Transactions
    • 17 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 08 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 juin 1994
    Livré le 15 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • B & J Holdings
    Transactions
    • 15 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 10 janv. 1992
    Livré le 24 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of each or any of the finance documents (as defined) or otherwise
    Brèves mentions
    See form 395 ref M26C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcthe "Security Agent" and the "Banks"
    Transactions
    • 24 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 27 juin 1991
    Livré le 03 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital and all patents patent applications, inventions, trade marks trade names, registered designs and copyrights see for details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 22 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 08 mars 1989
    Livré le 14 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on all undertaking and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 22 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 17 juin 1982
    Livré le 24 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a debenture dated 14.1.77
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transactions
    • 24 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Deposit charge & set-off agreement
    Créé le 28 janv. 1982
    Livré le 29 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter held or received by the said bank on behalf of the mortgagor or to its order (see doc M13).
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Merchant Bank LTD
    Transactions
    • 29 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 14 oct. 1981
    Livré le 15 oct. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 41/43 standishgate, wigan in the county of greater manchester (see doc M12 for further details.).
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Merchant Bank LTD
    Transactions
    • 15 oct. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 21 août 1981
    Livré le 28 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 516 sq. Yds together with the building erected thereon & k/a howard house broadway bradford W. yorkshire. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank LTD
    Transactions
    • 28 août 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 1981
    Livré le 05 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 50/56 deansgate and 37/47 market street, bolton, lancs.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Merchant Bank LTD
    Transactions
    • 05 août 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 06 févr. 1981
    Livré le 19 févr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at junction of queen's rd & dugdale street, nuneaton, warwicks.
    Personnes ayant droit
    • Trade Development Bank
    Transactions
    • 19 févr. 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0