JOSEPH ASH CHESTERFIELD LIMITED

JOSEPH ASH CHESTERFIELD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJOSEPH ASH CHESTERFIELD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01229116
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JOSEPH ASH CHESTERFIELD LIMITED ?

    • production d'autres métaux non ferreux (24450) / Industries manufacturières

    Où se situe JOSEPH ASH CHESTERFIELD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Westhaven House, Arleston Way
    Shirley
    B90 4LH Solihull
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JOSEPH ASH CHESTERFIELD LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    METNOR GALVANIZING LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    METNOR GALVANISING LIMITED31 déc. 197631 déc. 1976
    METNOR SCAFFOLDING LIMITED08 oct. 197508 oct. 1975

    Quels sont les derniers comptes de JOSEPH ASH CHESTERFIELD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour JOSEPH ASH CHESTERFIELD LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour JOSEPH ASH CHESTERFIELD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mars 2016

    État du capital au 07 mars 2016

    • Capital: GBP 300
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 févr. 2015

    État du capital au 17 févr. 2015

    • Capital: GBP 300
    SH01

    Nomination de Mr Charles Alex Henderson en tant que secrétaire le 01 janv. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de John Christopher Humphreys en tant que secrétaire le 01 janv. 2015

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 févr. 2014

    État du capital au 26 févr. 2014

    • Capital: GBP 300
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Pegler le 07 févr. 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Pegler le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de JOSEPH ASH CHESTERFIELD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HENDERSON, Charles Alex
    Merrington Close
    Solihull
    B91 3XF West Midlands
    5
    England
    England
    Secrétaire
    Merrington Close
    Solihull
    B91 3XF West Midlands
    5
    England
    England
    193836350001
    MUIR, Derek William
    2 West Fergus Place
    KY1 1UR Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    2 West Fergus Place
    KY1 1UR Kirkcaldy
    Fife
    United KingdomBritishDirector120442470001
    PEGLER, Mark
    Westhaven House, Arleston Way
    Shirley
    B90 4LH Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Westhaven House, Arleston Way
    Shirley
    B90 4LH Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector82454580021
    ATKINSON, Keith Andrew
    10 Easby Close
    NE3 5LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    10 Easby Close
    NE3 5LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishAccountant36184740003
    HAYHURST, Fred
    High Paddox
    Main Street
    CV35 8JA Norton Lindsey
    Warks
    Secrétaire
    High Paddox
    Main Street
    CV35 8JA Norton Lindsey
    Warks
    British48880500001
    HUMPHREYS, John Christopher
    46 Cheswick Way
    Cheswick Green
    B90 4HE Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    46 Cheswick Way
    Cheswick Green
    B90 4HE Solihull
    West Midlands
    British116764360001
    LOGIE, Gordon James
    104 Kennersdene
    Tynemouth
    NE30 2NW North Shields
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    104 Kennersdene
    Tynemouth
    NE30 2NW North Shields
    Tyne & Wear
    British3614500001
    MCLUCKIE, Jan
    5 Pinewood Avenue
    Northburn Chase
    NE23 3TX Cramlington
    Northumberland
    Secrétaire
    5 Pinewood Avenue
    Northburn Chase
    NE23 3TX Cramlington
    Northumberland
    BritishAccountant73260940001
    BURR, Christopher John
    Ashmore House
    Norton
    WR11 4YL Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    Ashmore House
    Norton
    WR11 4YL Evesham
    Worcestershire
    BritishDirector11620570002
    CARLING, David
    21 Gresham Avenue
    Brinsworth
    S60 5HA Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    21 Gresham Avenue
    Brinsworth
    S60 5HA Rotherham
    South Yorkshire
    BritishGalvanizing Manager68208870001
    CUNNINGHAM, Anthony William
    59 Salcombe Avenue
    NE32 3SN Jarrow
    Tyne & Wear
    Administrateur
    59 Salcombe Avenue
    NE32 3SN Jarrow
    Tyne & Wear
    BritishGalvanizer4081670001
    FINCH, Brian Jonathan
    The Grove
    Cold Hatton
    TF6 6QJ Wellington
    Shropshire
    Administrateur
    The Grove
    Cold Hatton
    TF6 6QJ Wellington
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector187464870001
    GREEN, Gerald Anthony
    48 Cavendish Road
    B62 0DD Halesowen
    West Midlands
    Administrateur
    48 Cavendish Road
    B62 0DD Halesowen
    West Midlands
    United KingdomBritishGeneral Manager98603840002
    GROVE, David Leslie
    Badgers Holt, Rookery Lane
    Lowsonford
    B95 5EP Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Badgers Holt, Rookery Lane
    Lowsonford
    B95 5EP Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector4174280001
    GUY, Robert George
    2 Holme Gardens
    SR3 1YE Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    2 Holme Gardens
    SR3 1YE Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishAccountant3425070001
    HOPKINS, Steven John
    Kington Court Farm
    Kington
    WR7 4DQ Flyford Flavel
    Worcestershire
    England
    Administrateur
    Kington Court Farm
    Kington
    WR7 4DQ Flyford Flavel
    Worcestershire
    England
    United KingdomBritishManaging Director19243320002
    LINACRE, Terence George Henry
    11 Monks Way
    Gateford Park
    S81 8NE Shireoaks
    Nottinghamshire
    Administrateur
    11 Monks Way
    Gateford Park
    S81 8NE Shireoaks
    Nottinghamshire
    BritishSales Director85111610001
    LINACRE, Terence George Henry
    11 Monks Way
    Gateford Park
    S81 8NE Shireoaks
    Nottinghamshire
    Administrateur
    11 Monks Way
    Gateford Park
    S81 8NE Shireoaks
    Nottinghamshire
    BritishSales Director85111610001
    LOGIE, Gordon James
    104 Kennersdene
    Tynemouth
    NE30 2NW North Shields
    Tyne & Wear
    Administrateur
    104 Kennersdene
    Tynemouth
    NE30 2NW North Shields
    Tyne & Wear
    BritishAccountant3614500001
    PINKERTON, David
    20 Nottingham Close
    Wingerworth
    S42 6NY Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    20 Nottingham Close
    Wingerworth
    S42 6NY Chesterfield
    Derbyshire
    BritishProduction Manager38103430002
    RANKIN, Allan
    Cote Hill Farm Cote Hill Drive
    Darras Hall Ponteland
    NE20 9HP Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    Cote Hill Farm Cote Hill Drive
    Darras Hall Ponteland
    NE20 9HP Newcastle Upon Tyne
    GibraltarBritishDirector64575000004
    RANKIN, John Robert
    The Willows
    Hepscott
    NE6 6LH Morpeth
    Northumberland
    Administrateur
    The Willows
    Hepscott
    NE6 6LH Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritishEngineer3614510002
    RANKIN, Stephen
    74 Runnymede Road
    Darras Hall Ponteland
    NE20 9HH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    74 Runnymede Road
    Darras Hall Ponteland
    NE20 9HH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritishMarketing Manager59400760003
    RICHARDS, Robin
    31 Chalfont Close
    CV12 8PB Bedworth
    Warwickshire
    Administrateur
    31 Chalfont Close
    CV12 8PB Bedworth
    Warwickshire
    BritishDirector29541530003

    JOSEPH ASH CHESTERFIELD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 15-05-2006
    Créé le 15 mai 2006
    Livré le 20 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums standing for the time being to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 nov. 2005
    Livré le 19 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 18/1/1999
    Créé le 03 mai 2005
    Livré le 05 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH january 1999
    Créé le 17 juin 2002
    Livré le 26 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 180199
    Créé le 26 juil. 1999
    Livré le 05 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities then due or which might therafter become due to the chargee from either the company or any one or more of the other parties (as defined) to the agreement
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0