TECHNOGRAPHICS UK
Vue d'ensemble
Nom de la société | TECHNOGRAPHICS UK |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
Numéro de société | 01232352 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TECHNOGRAPHICS UK ?
Adresse du siège social | 99 Gresham Street London EC2V 7NG |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TECHNOGRAPHICS UK ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 nov. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour TECHNOGRAPHICS UK ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2010 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2009 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Philip Matthew Deakin le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ola Tricia Aramita Barreto-Morley le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Edward Ufland le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Giles Hudson le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire S & J Registrars Limited le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gavin Udall en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Philip Matthew Deakin en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 30 nov. 2008 | 3 pages | AA | ||||||||||
Comptes établis au 30 nov. 2007 | 3 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 30 nov. 2006 | 3 pages | AA |
Qui sont les dirigeants de TECHNOGRAPHICS UK ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S & J REGISTRARS LIMITED | Secrétaire | Gresham Street EC2V 7NG London 99 United Kingdom |
| 43122090005 | ||||||||||
BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Administrateur | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | Tax Manager | 140644240001 | ||||||||
DEAKIN, Philip Matthew | Administrateur | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 146225080002 | ||||||||
HUDSON, Giles Matthew | Administrateur | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 161583790001 | ||||||||
UFLAND, Edward | Administrateur | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 87558180001 | ||||||||
BOYLE, Kyle G | Secrétaire | 72 Quail Run Glastonbury Ct 06033 FOREIGN Usa | Usa | Management | 60569860001 | |||||||||
ESSEL, Edwin | Secrétaire | 12 Chichester Way TW14 0DF Feltham Middlesex | British | Accountant | 42046510001 | |||||||||
HOGG, Stephen Thomas | Secrétaire | 28 Beechwood Court West St Lane SM5 2PZ Carshalton Surrey | British | 53590400001 | ||||||||||
JAMES, Guy Michael | Secrétaire | 45 Hornsey Lane Gardens N6 5NY London | British | 55654870001 | ||||||||||
PROBERT, Clive Michael Douglas | Secrétaire | Cefn Bryn Cottage Penmaen SA3 2HQ Swansea West Glamorgan | British | Company Director | 10804410001 | |||||||||
SMITH, Andrew John | Secrétaire | 20 Thornton Road Wimbledon Village SW19 4NG London | British | 65907810001 | ||||||||||
WEATHERITT, Philip John | Secrétaire | 19 Aston Way KT18 5LZ Epsom Surrey | British | 6118530001 | ||||||||||
BEJA, Albert | Administrateur | 54 Boulevard Flandrin Paris 75116 France | Portuguese | Director | 47157730001 | |||||||||
BOYLE, Kyle G | Administrateur | 72 Quail Run Glastonbury Ct 06033 FOREIGN Usa | Usa | Management | 60569860001 | |||||||||
BOYLE, Richard Guy | Administrateur | 259 Robin Drive Sarasota Florida 34236 Usa | American | Management | 58158220001 | |||||||||
BRUNTON-REED, Nigel Douglas | Administrateur | Deershadow 43 Higher Drive SM7 1PL Banstead Surrey | United Kingdom | British | Managing Director | 3179140002 | ||||||||
ELLIOTT, Ian | Administrateur | 13 Avenue Charles De Gaulle Boulogne Billancourt 92100 France | France | British | Chartered Accountant | 29232750008 | ||||||||
GRAEBER, George | Administrateur | 74 Sawmill Brook Lane Rfd 3 Mansfield Connecticut 06250 Usa | American | Management | 58385160001 | |||||||||
HAYNES, John Christopher Charles | Administrateur | 4 Walpole Avenue TW9 2DJ Richmond Surrey | British | Chartered Accountant | 35574080001 | |||||||||
HYDE, Legrand Putnam | Administrateur | 9219 Double Eagle Lane Knoxville Tennessee 37992 Usa | American | Management | 58385110001 | |||||||||
LEWIS, Thomas Arwyn | Administrateur | 35 Clos Glanlliw Pontlliw SA4 9DW Swansea West Glamorgan | British | Accountant | 65122490001 | |||||||||
PHILLIPSON, Christopher John Nicholas | Administrateur | Langwith Draycote CV23 9RB Rugby Warwickshire | England | British | Chartered Accountant | 37598900001 | ||||||||
PROBERT, Clive Michael Douglas | Administrateur | Cefn Bryn Cottage Penmaen SA3 2HQ Swansea West Glamorgan | British | Company Director | 10804410001 | |||||||||
SAVIDENT, Daniel John | Administrateur | 50 Bullens Green Lane Colney Heath AL4 0QS St Albans Hertfordshire | British | Managing Director | 79079280001 | |||||||||
SCHOLES, David | Administrateur | 244 Dunstable Road Studham LU6 2QJ Dunstable Bedfordshire | British | Company Director | 37495820001 | |||||||||
THOMAS, David Fenton | Administrateur | 345 Purchase Street Rye New York 10580 Usa | American | Banker | 58374940001 | |||||||||
UDALL, Gavin | Administrateur | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Accountant | 83889580001 | ||||||||
WEATHERITT, Philip John | Administrateur | 19 Aston Way KT18 5LZ Epsom Surrey | British | Chartered Accountant | 6118530001 | |||||||||
WEBER, John David | Administrateur | 440 East 79th Street Apartment 5e New York 10021 Usa | American | Banker | 58158240001 |
TECHNOGRAPHICS UK a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Créé le 26 mars 1993 Livré le 07 avr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Sunnybank mill kirkham preston fylde lancashire t/n la 505522 and/or the proceeds of sale thereof and an assignment of the goodwill and connection of any business, together with the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 25 févr. 1993 Livré le 03 mars 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 11 juil. 1984 Livré le 26 juil. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Legal mortgage over f/h land to the west of station road, kirkham, lancashire k/a sunnybank mill with the factory and buildings thereon and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 08 mai 1984 Livré le 11 mai 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property known as land to the west of station road, kirkham, lancashire k/a sunnybank mill, together with the factory & buildings & other erections thereon and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 11 janv. 1982 Livré le 12 janv. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all f/h & l/h properties a fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0