TECHNOGRAPHICS UK

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTECHNOGRAPHICS UK
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 01232352
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TECHNOGRAPHICS UK ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TECHNOGRAPHICS UK ?

    Adresse du siège social
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TECHNOGRAPHICS UK ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    POLYMARK (U.K.)18 avr. 198418 avr. 1984
    POLYMARK TECHNOGRAPHICS LIMITED 22 févr. 198322 févr. 1983
    POLYMARK TRANSTAT LIMITED04 nov. 197504 nov. 1975

    Quels sont les derniers comptes de TECHNOGRAPHICS UK ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour TECHNOGRAPHICS UK ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 nov. 2011

    État du capital au 23 nov. 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2010

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré

    1 pagesAD04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2009

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Philip Matthew Deakin le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ola Tricia Aramita Barreto-Morley le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Edward Ufland le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Giles Hudson le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire S & J Registrars Limited le 01 oct. 2009

    2 pagesCH04

    Cessation de la nomination de Gavin Udall en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Philip Matthew Deakin en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 30 nov. 2008

    3 pagesAA

    Comptes établis au 30 nov. 2007

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 nov. 2006

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TECHNOGRAPHICS UK ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement01740543
    43122090005
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Administrateur
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritishTax Manager140644240001
    DEAKIN, Philip Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Administrateur
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritishChartered Accountant146225080002
    HUDSON, Giles Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Administrateur
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritishChartered Accountant161583790001
    UFLAND, Edward
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Administrateur
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritishChartered Accountant87558180001
    BOYLE, Kyle G
    72 Quail Run
    Glastonbury Ct 06033
    FOREIGN Usa
    Secrétaire
    72 Quail Run
    Glastonbury Ct 06033
    FOREIGN Usa
    UsaManagement60569860001
    ESSEL, Edwin
    12 Chichester Way
    TW14 0DF Feltham
    Middlesex
    Secrétaire
    12 Chichester Way
    TW14 0DF Feltham
    Middlesex
    BritishAccountant42046510001
    HOGG, Stephen Thomas
    28 Beechwood Court
    West St Lane
    SM5 2PZ Carshalton
    Surrey
    Secrétaire
    28 Beechwood Court
    West St Lane
    SM5 2PZ Carshalton
    Surrey
    British53590400001
    JAMES, Guy Michael
    45 Hornsey Lane Gardens
    N6 5NY London
    Secrétaire
    45 Hornsey Lane Gardens
    N6 5NY London
    British55654870001
    PROBERT, Clive Michael Douglas
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    Secrétaire
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    BritishCompany Director10804410001
    SMITH, Andrew John
    20 Thornton Road
    Wimbledon Village
    SW19 4NG London
    Secrétaire
    20 Thornton Road
    Wimbledon Village
    SW19 4NG London
    British65907810001
    WEATHERITT, Philip John
    19 Aston Way
    KT18 5LZ Epsom
    Surrey
    Secrétaire
    19 Aston Way
    KT18 5LZ Epsom
    Surrey
    British6118530001
    BEJA, Albert
    54 Boulevard Flandrin
    Paris
    75116
    France
    Administrateur
    54 Boulevard Flandrin
    Paris
    75116
    France
    PortugueseDirector47157730001
    BOYLE, Kyle G
    72 Quail Run
    Glastonbury Ct 06033
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    72 Quail Run
    Glastonbury Ct 06033
    FOREIGN Usa
    UsaManagement60569860001
    BOYLE, Richard Guy
    259 Robin Drive
    Sarasota
    Florida
    34236
    Usa
    Administrateur
    259 Robin Drive
    Sarasota
    Florida
    34236
    Usa
    AmericanManagement58158220001
    BRUNTON-REED, Nigel Douglas
    Deershadow
    43 Higher Drive
    SM7 1PL Banstead
    Surrey
    Administrateur
    Deershadow
    43 Higher Drive
    SM7 1PL Banstead
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director3179140002
    ELLIOTT, Ian
    13 Avenue Charles De Gaulle
    Boulogne Billancourt
    92100
    France
    Administrateur
    13 Avenue Charles De Gaulle
    Boulogne Billancourt
    92100
    France
    FranceBritishChartered Accountant29232750008
    GRAEBER, George
    74 Sawmill Brook Lane Rfd 3
    Mansfield
    Connecticut
    06250
    Usa
    Administrateur
    74 Sawmill Brook Lane Rfd 3
    Mansfield
    Connecticut
    06250
    Usa
    AmericanManagement58385160001
    HAYNES, John Christopher Charles
    4 Walpole Avenue
    TW9 2DJ Richmond
    Surrey
    Administrateur
    4 Walpole Avenue
    TW9 2DJ Richmond
    Surrey
    BritishChartered Accountant35574080001
    HYDE, Legrand Putnam
    9219 Double Eagle Lane
    Knoxville
    Tennessee
    37992
    Usa
    Administrateur
    9219 Double Eagle Lane
    Knoxville
    Tennessee
    37992
    Usa
    AmericanManagement58385110001
    LEWIS, Thomas Arwyn
    35 Clos Glanlliw
    Pontlliw
    SA4 9DW Swansea
    West Glamorgan
    Administrateur
    35 Clos Glanlliw
    Pontlliw
    SA4 9DW Swansea
    West Glamorgan
    BritishAccountant65122490001
    PHILLIPSON, Christopher John Nicholas
    Langwith
    Draycote
    CV23 9RB Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    Langwith
    Draycote
    CV23 9RB Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritishChartered Accountant37598900001
    PROBERT, Clive Michael Douglas
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    Administrateur
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    BritishCompany Director10804410001
    SAVIDENT, Daniel John
    50 Bullens Green Lane
    Colney Heath
    AL4 0QS St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    50 Bullens Green Lane
    Colney Heath
    AL4 0QS St Albans
    Hertfordshire
    BritishManaging Director79079280001
    SCHOLES, David
    244 Dunstable Road
    Studham
    LU6 2QJ Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    244 Dunstable Road
    Studham
    LU6 2QJ Dunstable
    Bedfordshire
    BritishCompany Director37495820001
    THOMAS, David Fenton
    345 Purchase Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    Administrateur
    345 Purchase Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    AmericanBanker58374940001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishAccountant83889580001
    WEATHERITT, Philip John
    19 Aston Way
    KT18 5LZ Epsom
    Surrey
    Administrateur
    19 Aston Way
    KT18 5LZ Epsom
    Surrey
    BritishChartered Accountant6118530001
    WEBER, John David
    440 East 79th Street
    Apartment 5e
    New York
    10021
    Usa
    Administrateur
    440 East 79th Street
    Apartment 5e
    New York
    10021
    Usa
    AmericanBanker58158240001

    TECHNOGRAPHICS UK a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 26 mars 1993
    Livré le 07 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Sunnybank mill kirkham preston fylde lancashire t/n la 505522 and/or the proceeds of sale thereof and an assignment of the goodwill and connection of any business, together with the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 25 févr. 1993
    Livré le 03 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 11 juil. 1984
    Livré le 26 juil. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Legal mortgage over f/h land to the west of station road, kirkham, lancashire k/a sunnybank mill with the factory and buildings thereon and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 juil. 1984Enregistrement d'une charge
    • 12 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 mai 1984
    Livré le 11 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property known as land to the west of station road, kirkham, lancashire k/a sunnybank mill, together with the factory & buildings & other erections thereon and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 mai 1984Enregistrement d'une charge
    • 12 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 11 janv. 1982
    Livré le 12 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties a fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0