CAPE OVERSEAS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAPE OVERSEAS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01233631
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAPE OVERSEAS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CAPE OVERSEAS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Building 2, Fields End Business Park Davey Road
    Thurnscoe
    S63 0JF Goldthorpe
    Rotherham
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAPE OVERSEAS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAPE INDUSTRIES OVERSEAS LIMITED14 nov. 197514 nov. 1975

    Quels sont les derniers comptes de CAPE OVERSEAS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour CAPE OVERSEAS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    État du capital au 04 nov. 2021

    • Capital: GBP 3,872,999
    2 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2020

    12 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2019

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Padraig Somers en tant qu'administrateur le 28 juin 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Cape Admin 1 Limited en tant que directeur le 28 juin 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2018

    12 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Cape Admin 1 Limited le 04 févr. 2019

    1 pagesCH02

    Changement d'adresse du siège social de Drayton Hall Church Road West Drayton Middlesex England UB7 7PS à Building 2, Fields End Business Park Davey Road Thurnscoe Goldthorpe Rotherham S63 0JF le 30 janv. 2019

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2018 au 31 août 2018

    1 pagesAA01

    Nomination de Cape Admin 1 Limited en tant qu'administrateur le 25 mai 2018

    3 pagesAP02

    Cessation de la nomination de Mark Hooper en tant que directeur le 25 mai 2018

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Anthony Meade Walsh le 08 févr. 2018

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr John Anthony Meade Walsh en tant qu'administrateur le 31 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Victoria Anne George en tant que directeur le 15 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CAPE OVERSEAS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SOMERS, Padraig
    Island Ganniv
    Greenville
    Listowel
    3
    Co. Kerry
    Ireland
    Administrateur
    Island Ganniv
    Greenville
    Listowel
    3
    Co. Kerry
    Ireland
    IrelandIrish259818620001
    WALSH, John Anthony Meade
    Davey Road
    Thurnscoe
    S63 0JF Goldthorpe
    Building 2, Fields End Business Park
    Rotherham
    England
    Administrateur
    Davey Road
    Thurnscoe
    S63 0JF Goldthorpe
    Building 2, Fields End Business Park
    Rotherham
    England
    United KingdomBritish238138720001
    ALLAN, Richard Friend
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    181730640001
    CRAIGIE, Claire Louise
    4 Hill Top
    LS29 9RS Ilkley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    4 Hill Top
    LS29 9RS Ilkley
    West Yorkshire
    British82905830002
    GORMAN, Jeremy Philip
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    160675310001
    JUDD, Christopher Francis
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    Singapore
    #09-03
    039192
    Singapore
    Secrétaire
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    Singapore
    #09-03
    039192
    Singapore
    169531010001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British829660002
    RHODES, Jeremy
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    British129206660001
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Secrétaire
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    British64449570001
    TURNER, Lucy Finch
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    British133976740001
    AINLEY, Paul Raymond
    Manasseh
    Darrington Road
    WF8 3RY Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    Manasseh
    Darrington Road
    WF8 3RY Pontefract
    West Yorkshire
    British36049300001
    ALLAN, Richard Friend
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritish183409640001
    AMEY, Rachel Nancye
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritish133976650005
    BINGHAM, Richard Keith
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    Administrateur
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    British131046090001
    CARTWRIGHT, Paul Ian
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    Administrateur
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    British40873830002
    CRAIGIE, Claire Louise
    4 Hill Top
    LS29 9RS Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    4 Hill Top
    LS29 9RS Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish82905830002
    DOWLING, Christopher Bruce
    20 Bramcote Road
    Putney
    SW15 6UG London
    Administrateur
    20 Bramcote Road
    Putney
    SW15 6UG London
    Australian28868820002
    FAREBROTHER, Michael John
    The Old Cottage
    Pednor
    HP5 2SX Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Old Cottage
    Pednor
    HP5 2SX Chesham
    Buckinghamshire
    British15332520001
    GARTSIDE, Jeremy Peter
    The Grange
    Kelshall
    SG8 9SE Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Grange
    Kelshall
    SG8 9SE Royston
    Hertfordshire
    British28782670001
    GEORGE, Victoria Anne
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritish134024500001
    GIBSON, Andrew Christopher
    Lingerfield Barn
    Market Flat Lane Scotton
    HG5 9JA Knaresborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Lingerfield Barn
    Market Flat Lane Scotton
    HG5 9JA Knaresborough
    North Yorkshire
    British101703790001
    GILLESPIE, Andrew James
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish89560440001
    GRATTON, Gordon Cameron Paul
    1 Beckside Gardens
    LS16 5QZ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Beckside Gardens
    LS16 5QZ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish121813940001
    HOOPER, Mark
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    Administrateur
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    United KingdomBritish183414240001
    JACKSON, Francis Keith John
    The Artists House
    Station Road Goring On Thames
    RG8 9HA Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Artists House
    Station Road Goring On Thames
    RG8 9HA Reading
    Berkshire
    EnglandBritish15469790001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish829660002
    REYNOLDS, Michael Thomas
    185 Adel Lane
    LS16 8BY Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    185 Adel Lane
    LS16 8BY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4978610002
    SKIPP, Richard John
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    Administrateur
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    EnglandBritish164010970001
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Administrateur
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    British64449570001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Administrateur
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    EnglandBritish99402260002
    WIDDOWSON, Ian Richard
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British16941000001
    CAPE ADMIN 1 LIMITED
    Fields End Business Park
    Davey Road
    S63 0JF Goldthorpe
    Building 2
    Rotherham
    United Kingdom
    Administrateur
    Fields End Business Park
    Davey Road
    S63 0JF Goldthorpe
    Building 2
    Rotherham
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement09277026
    194285370001
    CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    131421100001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CAPE OVERSEAS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    06 avr. 2016
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3299544
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CAPE OVERSEAS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating security document
    Créé le 03 sept. 2007
    Livré le 13 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee and Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 13 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document
    Créé le 16 oct. 2006
    Livré le 26 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee and Security Agent for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transactions
    • 26 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document
    Créé le 29 août 2003
    Livré le 01 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank as Security Trustee for the Lender (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 01 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document
    Créé le 20 juil. 2001
    Livré le 26 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any creditor (as defined)
    Brèves mentions
    Freehold properties,(i) palmers moor and woodlands park,iver lane,iver,bucks;SGL49469;(ii)botleybrickworks,leyhill,chesham,bucks; (iii) cowley bridge works,iver lane,uxbridge UB8 2JQ; agl 60617 and ag 60620 plus various other properties listed;and all real property,as defined, listed in schedule 6 of the security document and by way of first fixed charge over all its book debts,bank accounts,investments and dividends,uncalled capital and goodwill,intellectual property,plant,machinery,insurances and all related proceeds; floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC,as Security Trustee for the Creditors
    Transactions
    • 26 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0