THE TRIANGLE GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE TRIANGLE GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01239031
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE TRIANGLE GROUP LIMITED ?

    • (7440) /

    Où se situe THE TRIANGLE GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pembroke Building
    Kensington Village
    W14 8DG Avonmore Road
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE TRIANGLE GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRIANGLE COMMUNICATIONS LIMITED 30 juin 199430 juin 1994
    MARKETING TRIANGLE LIMITED(THE) 31 déc. 197931 déc. 1979
    T.H.H. SALES PROMOTION TRIANGLE LIMITED31 déc. 197531 déc. 1975

    Quels sont les derniers comptes de THE TRIANGLE GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour THE TRIANGLE GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    19 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    17 pagesAA

    legacy

    7 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    17 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    7 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de THE TRIANGLE GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EWING, Susanna
    72f Sinclair Road
    W14 0NJ London
    Secrétaire
    72f Sinclair Road
    W14 0NJ London
    British122102410001
    GONZALEZ-GOMEZ, Minna Katariina
    64 Elmhurst Mansions Edgeley Road
    SW4 6EU London
    Secrétaire
    64 Elmhurst Mansions Edgeley Road
    SW4 6EU London
    Finnish119965730001
    CAWLEY, Diana Pamela
    8 Huntingdon Street
    N1 1BU London
    Administrateur
    8 Huntingdon Street
    N1 1BU London
    British66621150004
    EDWARDS, Andrew Gwyn
    Prince Consort Drive
    SL5 8AW Ascot
    5
    Berkshire
    Administrateur
    Prince Consort Drive
    SL5 8AW Ascot
    5
    Berkshire
    United KingdomBritish121808440001
    FROST, Kevin Peter
    177 Broomwood Road
    Clapham Common
    SW11 6JX London
    Administrateur
    177 Broomwood Road
    Clapham Common
    SW11 6JX London
    British89075360001
    COLLINS, Andrew John
    84 Stanlake Road
    W12 7HJ London
    Secrétaire
    84 Stanlake Road
    W12 7HJ London
    British4006390001
    EARL, Elizabeth Louise Kiernan
    9 Helena Road
    SL4 1JN Windsor
    Berkshire
    Secrétaire
    9 Helena Road
    SL4 1JN Windsor
    Berkshire
    British105197540001
    HYSLOP, Roger Geoffrey
    Mermaid Cottage
    Hawridge Common
    HP5 2UH Chesham
    Bucks
    Secrétaire
    Mermaid Cottage
    Hawridge Common
    HP5 2UH Chesham
    Bucks
    British9340850001
    KURTZ, Catherine Elizabeth Strathmore
    6 Berkeley Road
    TN1 1YR Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    6 Berkeley Road
    TN1 1YR Tunbridge Wells
    Kent
    British54236170003
    LAWRENCE, Michael James
    50 Woodberry Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3LD London
    Secrétaire
    50 Woodberry Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3LD London
    British88140060001
    TOMSETT, Mark Anthony
    7 Avalon Road
    Earley
    RG6 7NS Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    7 Avalon Road
    Earley
    RG6 7NS Reading
    Berkshire
    British51265530003
    TOPPIN, John Eric
    The Old Rectory
    Sutton Road
    ME17 3LY Langley
    Kent
    Secrétaire
    The Old Rectory
    Sutton Road
    ME17 3LY Langley
    Kent
    British62203080003
    WYLLIE, Alison
    Flat 2
    186 Ladbroke Grove
    W10 5LZ London
    Secrétaire
    Flat 2
    186 Ladbroke Grove
    W10 5LZ London
    British107811220001
    AXFORD, Christina
    Taverners
    Rush Green Hollybush Lane
    UB9 4HF Denham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Taverners
    Rush Green Hollybush Lane
    UB9 4HF Denham
    Buckinghamshire
    British75182500002
    BAKER, Elizabeth
    Fair Oak Bulstrode Way
    SL9 7QT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Fair Oak Bulstrode Way
    SL9 7QT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British21923390002
    BELTON, Patrick Lort
    40 Silvester Road
    SE22 9PB London
    Administrateur
    40 Silvester Road
    SE22 9PB London
    British89075270001
    BEVAN, Cerys
    50b Rossiter Road
    SW12 9RU London
    Administrateur
    50b Rossiter Road
    SW12 9RU London
    British71116450001
    CARLING, Thomas Wykeham
    6 The Rocks Road
    ME19 6AN East Malling
    Kent
    Administrateur
    6 The Rocks Road
    ME19 6AN East Malling
    Kent
    British98084860001
    CLARIDGE, Danny Arthur
    12 Carlina Gardens
    IG8 0BP Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    12 Carlina Gardens
    IG8 0BP Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish159527590001
    COLLINS, Andrew John
    84 Stanlake Road
    W12 7HJ London
    Administrateur
    84 Stanlake Road
    W12 7HJ London
    EnglandBritish4006390001
    DAVIES, Shelley Alexandra
    The Strand
    Quainton
    HP22 4AS Aylesbury
    2
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Strand
    Quainton
    HP22 4AS Aylesbury
    2
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish137205190001
    DUNN, Diana Pamela
    26 Thirlemere Road
    N10 2DN London
    Administrateur
    26 Thirlemere Road
    N10 2DN London
    British66621150001
    GRIFFITHS, Graham Mark Dilsmore
    Rowans 2 Marley Rise
    Ridgeway Road
    RH4 3BP Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Rowans 2 Marley Rise
    Ridgeway Road
    RH4 3BP Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish20173090002
    HEATH, Matthew Alexander
    The Old Forge
    South Stoke Road, Woodcote
    RG8 0PL Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Old Forge
    South Stoke Road, Woodcote
    RG8 0PL Reading
    Berkshire
    EnglandBritish93531810001
    HEBDON, Simon
    34 Telford Place
    CM1 7QZ Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    34 Telford Place
    CM1 7QZ Chelmsford
    Essex
    British72795050003
    HICKS, David Charles Francis
    6 Ernest Gardens
    W4 3QU London
    Administrateur
    6 Ernest Gardens
    W4 3QU London
    British68634660001
    HOADLEY, Nicholas Peter
    Primrose Cottage
    Wendover Road
    HP17 0TU Butlers Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Primrose Cottage
    Wendover Road
    HP17 0TU Butlers Cross
    Buckinghamshire
    British75180880002
    HOLGATE, Barbara
    4 The Chase
    AL6 0QT Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 The Chase
    AL6 0QT Welwyn
    Hertfordshire
    British66621160001
    HOWELL, Sarah
    Flat 4, 66 Elgin Avenue
    W9 2HA London
    Administrateur
    Flat 4, 66 Elgin Avenue
    W9 2HA London
    British71116370001
    HYSLOP, Elise Victoria Viviane
    George Street
    HP4 2EJ Berkhamsted
    99
    Hertfordshire
    Administrateur
    George Street
    HP4 2EJ Berkhamsted
    99
    Hertfordshire
    British89122880002
    HYSLOP, Roger Geoffrey
    Mermaid Cottage
    Hawridge Common
    HP5 2UH Chesham
    Bucks
    Administrateur
    Mermaid Cottage
    Hawridge Common
    HP5 2UH Chesham
    Bucks
    British9340850001
    MALCOLM, Frances Martha
    Flat 4
    29 St. James`S Gardens,Holland Park
    W11 4RF London
    Administrateur
    Flat 4
    29 St. James`S Gardens,Holland Park
    W11 4RF London
    British34057400002
    ORBELL, Andrew Mark
    Lindau Currant Hill
    South Bank
    TN16 1EN Westerham
    Kent
    Administrateur
    Lindau Currant Hill
    South Bank
    TN16 1EN Westerham
    Kent
    British20155470003
    PARRY, Christopher Douglas
    Dean Lodge
    16 Frieth Road
    SL7 2QT Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Dean Lodge
    16 Frieth Road
    SL7 2QT Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69601580002
    PRESLEY, Nicholas Ian
    Lobs House
    Fredley Park
    RH5 6DD Mickleham, Nr. Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Lobs House
    Fredley Park
    RH5 6DD Mickleham, Nr. Dorking
    Surrey
    EnglandBritish101807990001

    THE TRIANGLE GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 09 juin 1999
    Livré le 24 juin 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 janv. 1997
    Livré le 10 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or the triangle group limited and/or ocean marketing communications limited and/or eye ii eye communications limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 déc. 1991
    Livré le 16 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Rear of second floor,17 newman street,london borough of city of westminster.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 déc. 1991
    Livré le 15 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 févr. 1990
    Livré le 21 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 15 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 juil. 1988
    Livré le 04 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 maple mews london borough of city of westminster title no. Ngl 585430.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 14 mars 1988
    Livré le 31 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 16 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 21 nov. 1984
    Livré le 04 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    • 15 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 juin 1984
    Livré le 21 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Second floor, 17 newman street, (14A newman passage) westminster london.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 juin 1984Enregistrement d'une charge
    • 19 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 avr. 1984
    Livré le 12 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold ground floor & basement 17, newman street, westminster, london W1.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 19 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 déc. 1983
    Livré le 05 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    • 15 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0