COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01239073 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?
Adresse du siège social | Breakspear Park Breakspear Way HP2 4TZ Hemel Hempstead Hertfordshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 juil. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2021 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de James Douglas Mcfarlane en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 déc. 2021 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2020 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2019 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2018 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 11th Floor Two Snow Hill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6WR | 1 pages | AD03 | ||||||||||
Notification de Redsky It (Crick) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Notification de James Douglas Mcfarlane en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 03 avr. 2018 | 2 pages | PSC09 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 012390730009, créée le 22 nov. 2017 | 83 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Julian Richard Henwood en tant que secrétaire le 25 févr. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFARLANE, James Douglas | Administrateur | 730 Eyremount Drive West Vancouver Bc V76 2a4 Canada | Canada | Canadian | Director | 118810110004 | ||||
COSTER, Malcolm David | Secrétaire | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | British | Director | 39034110001 | |||||
COTTRELL, Paul Alan | Secrétaire | 16 Goldcrest Drive TN22 5QG Uckfield East Sussex | British | Group Financial Controller | 13754300002 | |||||
DURRANT, Zoe Vivienne | Secrétaire | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||
HENWOOD, Julian Richard | Secrétaire | 8 Brickyard Close CV7 7EN Balsall Common Warwickshire | British | 65188860002 | ||||||
TAYLOR, David | Secrétaire | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||
BELLAMY, Paul Anthony | Administrateur | 9 Sadbury Close Worle BS22 0QP Weston Super Mare Avon | British | Sales Director | 34463620001 | |||||
BRADLEY, Michael John | Administrateur | Vantage Point 208 Henwick Road WR2 5PF Worcester | British | Director | 40818740003 | |||||
COSTER, Malcolm David | Administrateur | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | England | British | Director | 39034110001 | ||||
EVANS, Robert Owen | Administrateur | Hollybank 32 Birches Lane CV8 2AD Kenilworth Warwickshire | British | Accountant | 57011000001 | |||||
FLYNN, Thomas Desmond | Administrateur | Larch Cottage 39 Bagley Wood Road Kennington OX1 5LY Oxford Oxfordshire | British | Director | 16993890001 | |||||
FOSTER, Michael | Administrateur | The Ash Grove 91 Bretby Lane DE15 0QP Burton On Trent Staffordshire | British | Director | 34463630001 | |||||
GRAHAM, Ross King | Administrateur | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | Company Director | 61733920001 | ||||
JONES, Nicholas David Brandon | Administrateur | 16 Dallington Park Road NN5 7AA Northampton Northamptonshire | British | Director | 16993910001 | |||||
LOMAX, John Kevin | Administrateur | Hawling Manor Hawling GL54 5TA Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 22190280002 | |||||
MATTHEW, Gordon John | Administrateur | Rogers Lane Ettrington CV37 3TA Stratford Upon Avon Saracens Yard Warwickshire | England | British | Director | 151547160001 | ||||
SINFIELD, Christopher | Administrateur | Stonelea Cottage 24 Whiston Road Cogenhoe NN7 1NL Northampton Northamptonshire | British | Accountant | 37887830001 | |||||
SMITH, Gordon Saville | Administrateur | 32 St Peters Avenue NN16 0HA Kettering Northamptonshire | British | Director | 2436530001 | |||||
SUSSENS, John Gilbert | Administrateur | 25 Jordan Road B75 5AB Sutton Coldfield West Midlands | British | Director | 1442450001 | |||||
TAYLOR, David | Administrateur | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | Director | 1439590001 | |||||
TEBBUTT, Arthur Mark | Administrateur | 26 Grange Road Geddington NN14 1AL Kettering Northamptonshire | United Kingdom | British | Director | 2436540001 | ||||
WINGFIELD, Richard Alan | Administrateur | 1 Town Farm Close Thame OX9 2DA Oxford | England | British | Director | 76932830002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr James Douglas Mcfarlane | 06 avr. 2016 | Breakspear Way HP2 4TZ Hemel Hempstead Breakspear Park Hertfordshire | Oui | ||||||||||
Nationalité: Canadian Pays de résidence: Canada | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Redsky It (Crick) Limited | 06 avr. 2016 | Breakspear Way HP2 4TZ Hemel Hempstead Breakspear Park Hertfordshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
07 nov. 2016 | 03 avr. 2018 | La société a identifié une personne enregistrable en relation avec la société, mais toutes les informations requises sur cette personne n'ont pas été confirmées. |
COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 22 nov. 2017 Livré le 29 nov. 2017 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 janv. 2015 Livré le 03 févr. 2015 | En cours | ||
Brève description Coulson heron associates limited charges by way of fixed charge any right, title or interest which it has now or may subsequently acquire to or in any land (as defined in the debenture).. Coulson heron associates limited charges by way of legal mortgage the land at redsky house, eldon way, crick industrial estate, crick NN6 7SL with title number NN295077.. Coulson heron associates limited charges by way of first fixed charge all trade mark property, copyrights and related rights (as defined in the debenture), including all fees, royalties and other rights of every kind relating to or deriving from such rights. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 31 janv. 2014 Livré le 07 févr. 2014 | En cours | ||
Brève description Fixed charge over any right/ title/ interest which the company has or acquires over any other land.. Fixed charge over trade marks, any good will relating to a trade mark, any other right arising from, relating to, or associated with any trade mark or its use in a chargor’s business, copyrights and all other intellectual property rights (including all fees, royalties, and other rights). This applies to any intellectual property owned presently by the chargor or at any time between the date of the debenture (31 january 2014) and the date on which the security trustee is satisfied (acting reasonably) that all of the liabilities of the loan parties under each finance document are irrevocably discharged in full and no finance party has any commitment or liability, whether present or future, actual or contingent, in relation to the facility made available under the finance documents. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security agreement | Créé le 21 déc. 2010 Livré le 05 janv. 2011 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The collateral being all right in the accounts books chattel paper deposit accounts equipment and fixtures general intangibles inventory investment related property negotiable collateral supporting obligations, commercial tort claims, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
General security agreement | Créé le 21 déc. 2010 Livré le 05 janv. 2011 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The collateral being all right in the undertaking and personal property which includes accounts chattel paper documents of title equipment goods instruments inventory investment property and money, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 21 déc. 2010 Livré le 05 janv. 2011 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, equipment see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Copyright security agreement | Créé le 21 déc. 2010 Livré le 05 janv. 2011 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the copyrights and copyright intellectual property licences all renewals or extensions of the foregoing and all products and proceeds of the foregoing see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Trademark security agreement | Créé le 21 déc. 2010 Livré le 05 janv. 2011 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All its trademarks and trademark intellectual property licences all goodwill of the business and all products and proceeds of the foregoing see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 17 juin 1985 Livré le 24 juin 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/Hold proeprty known as eldon way crick northamptonshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0