COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED

COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOULSON HERON ASSOCIATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01239073
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Breakspear Park
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2021

    4 pagesAA

    Cessation de James Douglas Mcfarlane en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 déc. 2021

    1 pagesPSC07

    Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2020

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2019

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2018

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 11th Floor Two Snow Hill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6WR

    1 pagesAD03

    Notification de Redsky It (Crick) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Notification de James Douglas Mcfarlane en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC01

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 03 avr. 2018

    2 pagesPSC09

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2017

    4 pagesAA

    Inscription de la charge 012390730009, créée le 22 nov. 2017

    83 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2016

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2015

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 déc. 2015

    État du capital au 07 déc. 2015

    • Capital: GBP 96,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Julian Richard Henwood en tant que secrétaire le 25 févr. 2015

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2014

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCFARLANE, James Douglas
    730 Eyremount Drive
    West Vancouver
    Bc V76 2a4
    Canada
    Administrateur
    730 Eyremount Drive
    West Vancouver
    Bc V76 2a4
    Canada
    CanadaCanadianDirector118810110004
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Secrétaire
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    BritishDirector39034110001
    COTTRELL, Paul Alan
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    Secrétaire
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    BritishGroup Financial Controller13754300002
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secrétaire
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    HENWOOD, Julian Richard
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    Secrétaire
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    British65188860002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Secrétaire
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    BELLAMY, Paul Anthony
    9 Sadbury Close
    Worle
    BS22 0QP Weston Super Mare
    Avon
    Administrateur
    9 Sadbury Close
    Worle
    BS22 0QP Weston Super Mare
    Avon
    BritishSales Director34463620001
    BRADLEY, Michael John
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    Administrateur
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    BritishDirector40818740003
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Administrateur
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    EnglandBritishDirector39034110001
    EVANS, Robert Owen
    Hollybank
    32 Birches Lane
    CV8 2AD Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Hollybank
    32 Birches Lane
    CV8 2AD Kenilworth
    Warwickshire
    BritishAccountant57011000001
    FLYNN, Thomas Desmond
    Larch Cottage 39 Bagley Wood Road
    Kennington
    OX1 5LY Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Larch Cottage 39 Bagley Wood Road
    Kennington
    OX1 5LY Oxford
    Oxfordshire
    BritishDirector16993890001
    FOSTER, Michael
    The Ash Grove
    91 Bretby Lane
    DE15 0QP Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    The Ash Grove
    91 Bretby Lane
    DE15 0QP Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishDirector34463630001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Administrateur
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director61733920001
    JONES, Nicholas David Brandon
    16 Dallington Park Road
    NN5 7AA Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    16 Dallington Park Road
    NN5 7AA Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector16993910001
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector22190280002
    MATTHEW, Gordon John
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    Administrateur
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector151547160001
    SINFIELD, Christopher
    Stonelea Cottage 24 Whiston Road
    Cogenhoe
    NN7 1NL Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Stonelea Cottage 24 Whiston Road
    Cogenhoe
    NN7 1NL Northampton
    Northamptonshire
    BritishAccountant37887830001
    SMITH, Gordon Saville
    32 St Peters Avenue
    NN16 0HA Kettering
    Northamptonshire
    Administrateur
    32 St Peters Avenue
    NN16 0HA Kettering
    Northamptonshire
    BritishDirector2436530001
    SUSSENS, John Gilbert
    25 Jordan Road
    B75 5AB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    25 Jordan Road
    B75 5AB Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector1442450001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    BritishDirector1439590001
    TEBBUTT, Arthur Mark
    26 Grange Road
    Geddington
    NN14 1AL Kettering
    Northamptonshire
    Administrateur
    26 Grange Road
    Geddington
    NN14 1AL Kettering
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector2436540001
    WINGFIELD, Richard Alan
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    Administrateur
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    EnglandBritishDirector76932830002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr James Douglas Mcfarlane
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    06 avr. 2016
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    Oui
    Nationalité: Canadian
    Pays de résidence: Canada
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    06 avr. 2016
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02688394
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    07 nov. 201603 avr. 2018La société a identifié une personne enregistrable en relation avec la société, mais toutes les informations requises sur cette personne n'ont pas été confirmées.

    COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 nov. 2017
    Livré le 29 nov. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada as Collateral Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 29 nov. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 janv. 2015
    Livré le 03 févr. 2015
    En cours
    Brève description
    Coulson heron associates limited charges by way of fixed charge any right, title or interest which it has now or may subsequently acquire to or in any land (as defined in the debenture).. Coulson heron associates limited charges by way of legal mortgage the land at redsky house, eldon way, crick industrial estate, crick NN6 7SL with title number NN295077.. Coulson heron associates limited charges by way of first fixed charge all trade mark property, copyrights and related rights (as defined in the debenture), including all fees, royalties and other rights of every kind relating to or deriving from such rights.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transactions
    • 03 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 31 janv. 2014
    Livré le 07 févr. 2014
    En cours
    Brève description
    Fixed charge over any right/ title/ interest which the company has or acquires over any other land.. Fixed charge over trade marks, any good will relating to a trade mark, any other right arising from, relating to, or associated with any trade mark or its use in a chargor’s business, copyrights and all other intellectual property rights (including all fees, royalties, and other rights). This applies to any intellectual property owned presently by the chargor or at any time between the date of the debenture (31 january 2014) and the date on which the security trustee is satisfied (acting reasonably) that all of the liabilities of the loan parties under each finance document are irrevocably discharged in full and no finance party has any commitment or liability, whether present or future, actual or contingent, in relation to the facility made available under the finance documents. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transactions
    • 07 févr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Security agreement
    Créé le 21 déc. 2010
    Livré le 05 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The collateral being all right in the accounts books chattel paper deposit accounts equipment and fixtures general intangibles inventory investment related property negotiable collateral supporting obligations, commercial tort claims, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transactions
    • 05 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    General security agreement
    Créé le 21 déc. 2010
    Livré le 05 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The collateral being all right in the undertaking and personal property which includes accounts chattel paper documents of title equipment goods instruments inventory investment property and money, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transactions
    • 05 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2010
    Livré le 05 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, equipment see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transactions
    • 05 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Copyright security agreement
    Créé le 21 déc. 2010
    Livré le 05 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the copyrights and copyright intellectual property licences all renewals or extensions of the foregoing and all products and proceeds of the foregoing see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transactions
    • 05 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Trademark security agreement
    Créé le 21 déc. 2010
    Livré le 05 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its trademarks and trademark intellectual property licences all goodwill of the business and all products and proceeds of the foregoing see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transactions
    • 05 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal mortgage
    Créé le 17 juin 1985
    Livré le 24 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold proeprty known as eldon way crick northamptonshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 juin 1985Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0