RUBY DCO NINE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRUBY DCO NINE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01239799
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RUBY DCO NINE LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe RUBY DCO NINE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Office 5, International House
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RUBY DCO NINE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HYWEL DAVIES (CAERPHILLY) LIMITED08 janv. 197608 janv. 1976

    Quels sont les derniers comptes de RUBY DCO NINE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour RUBY DCO NINE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Notification de Dunamis Mind Accelerator Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2023

    2 pagesPSC02

    Cessation de Admenta Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2023

    1 pagesPSC07

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re: change of name / company shall be entitled to appoint a sole director / such director shall have the authority to exercise all powers and discretions of the directors confered by the articles 31/08/2023
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Graham Wiseman en tant que directeur le 31 août 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Thorsten Sprank en tant qu'administrateur le 31 août 2023

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Sapphire Court Walsgrave Triangle Coventry West Midlands CV2 2TX à Office 5, International House Cray Avenue Orpington BR5 3RS le 04 sept. 2023

    1 pagesAD01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed hywel davies (caerphilly) LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 sept. 2023

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    État du capital au 15 août 2023

    • Capital: GBP 0.01
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 25 janv. 2023 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    3 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Ratification of sole directors actions 07/09/2022
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    33 pagesMA

    Cessation de la nomination de Wendy Margaret Hall en tant que directeur le 09 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nichola Louise Legg en tant que secrétaire le 09 sept. 2022

    1 pagesTM02

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Nomination de Graham Wiseman en tant qu'administrateur le 07 sept. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Christian Keen en tant que directeur le 18 mai 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2022 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de RUBY DCO NINE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SPRANK, Thorsten
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Administrateur
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandGerman203900280002
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secrétaire
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Other128834920001
    DAVIES, Gwynneth
    8 Oakfield Gardens
    Royal Oak Machen
    CF83 8RS Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    8 Oakfield Gardens
    Royal Oak Machen
    CF83 8RS Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British25696710002
    DAVIES, Hywel Thomas
    Westwinds 1 Heol Pwll Y Pant
    CF8 2ND Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    Westwinds 1 Heol Pwll Y Pant
    CF8 2ND Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British3300280001
    LEGG, Nichola Louise
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    West Midlands
    Secrétaire
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    West Midlands
    163214890001
    TYLER, Kathryn Maria
    Uplands Blackbrook Lane
    Caerphilly Mountain
    CF83 1NF Caerphilly
    Secrétaire
    Uplands Blackbrook Lane
    Caerphilly Mountain
    CF83 1NF Caerphilly
    British122331460001
    AUBREY, Lyn John
    Cedarwood Close
    Afon Village Rogerstone
    NP10 0JZ Newport
    1
    Administrateur
    Cedarwood Close
    Afon Village Rogerstone
    NP10 0JZ Newport
    1
    British131848080001
    BEER, Thorsten
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    West Midlands
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    West Midlands
    United KingdomGerman172030260001
    DAVIES, Gwynneth
    8 Oakfield Gardens
    Royal Oak Machen
    CF83 8RS Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    8 Oakfield Gardens
    Royal Oak Machen
    CF83 8RS Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British25696710002
    DAVIES, Hywel Thomas
    Westwinds 1 Heol Pwll Y Pant
    CF8 2ND Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    Westwinds 1 Heol Pwll Y Pant
    CF8 2ND Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British3300280001
    HALL, Wendy Margaret
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    West Midlands
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    West Midlands
    EnglandBritish172979860001
    HILGER, Marcus
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    West Midlands
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    West Midlands
    GermanyGerman238936580003
    KEEN, Christian
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    West Midlands
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    West Midlands
    EnglandBritish54544790004
    LIPP, Hanns Martin
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    West Midlands
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    West Midlands
    United KingdomGerman220582440001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    THOMAS, Geoffrey James
    2 Heol Y Coed
    Rhiwbina
    CF14 6HP Cardiff
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    2 Heol Y Coed
    Rhiwbina
    CF14 6HP Cardiff
    Mid Glamorgan
    British86372480001
    TYLER, Kathryn Maria
    6 Tudor Gardens
    Machen
    CF83 8PD Caerphilly
    Administrateur
    6 Tudor Gardens
    Machen
    CF83 8PD Caerphilly
    British37371780002
    TYLER, Peter Granville
    6 Tudor Gardens
    Machen
    CF83 8PD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    6 Tudor Gardens
    Machen
    CF83 8PD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British120983040001
    TYLER, Sharon Elizabeth
    Westwinds 1 Heol Pwll Y Pant
    CF83 2ND Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    Westwinds 1 Heol Pwll Y Pant
    CF83 2ND Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British65523330001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    WISEMAN, Graham
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Administrateur
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandBritish299860960001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RUBY DCO NINE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Dunamis Mind Accelerator Limited
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    31 août 2023
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    06 avr. 2016
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementGreat Britain
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement244282
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    RUBY DCO NINE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 août 2007
    Livré le 29 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property known as heol penalta gelligaer 31 tonyfelin rd caerphilly heol bro wen caerphilly,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aah Pharmaceuticals Limited, Barclay Pharmaceuticals Limited
    Transactions
    • 29 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 01 juin 2007
    Livré le 11 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Pharmacy unit at court house medical centre heol bro wen caerphilly mid glamorgan. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 01 juin 2007
    Livré le 11 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Ground floor pharmacy k/a gelligaer pharmacy penallta gelligaer and residentialflat above all amounts by way of rent, R. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 avr. 2007
    Livré le 26 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0