RUBY DCO NINE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RUBY DCO NINE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01239799 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RUBY DCO NINE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Office 5, International House Cray Avenue BR5 3RS Orpington England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RUBY DCO NINE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour RUBY DCO NINE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Notification de Dunamis Mind Accelerator Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2023 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Admenta Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2023 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Wiseman en tant que directeur le 31 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Thorsten Sprank en tant qu'administrateur le 31 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Sapphire Court Walsgrave Triangle Coventry West Midlands CV2 2TX à Office 5, International House Cray Avenue Orpington BR5 3RS le 04 sept. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed hywel davies (caerphilly) LIMITED\certificate issued on 04/09/23 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital au 15 août 2023
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 janv. 2023 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Statuts | 33 pages | MA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Wendy Margaret Hall en tant que directeur le 09 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nichola Louise Legg en tant que secrétaire le 09 sept. 2022 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Nomination de Graham Wiseman en tant qu'administrateur le 07 sept. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christian Keen en tant que directeur le 18 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2022 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de RUBY DCO NINE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRANK, Thorsten | Administrateur | Cray Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | England | German | 203900280002 | |||||
| BRIERLEY, Jennifer Anne | Secrétaire | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Other | 128834920001 | ||||||
| DAVIES, Gwynneth | Secrétaire | 8 Oakfield Gardens Royal Oak Machen CF83 8RS Caerphilly Mid Glamorgan | British | 25696710002 | ||||||
| DAVIES, Hywel Thomas | Secrétaire | Westwinds 1 Heol Pwll Y Pant CF8 2ND Caerphilly Mid Glamorgan | British | 3300280001 | ||||||
| LEGG, Nichola Louise | Secrétaire | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court West Midlands | 163214890001 | |||||||
| TYLER, Kathryn Maria | Secrétaire | Uplands Blackbrook Lane Caerphilly Mountain CF83 1NF Caerphilly | British | 122331460001 | ||||||
| AUBREY, Lyn John | Administrateur | Cedarwood Close Afon Village Rogerstone NP10 0JZ Newport 1 | British | 131848080001 | ||||||
| BEER, Thorsten | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court West Midlands | United Kingdom | German | 172030260001 | |||||
| DAVIES, Gwynneth | Administrateur | 8 Oakfield Gardens Royal Oak Machen CF83 8RS Caerphilly Mid Glamorgan | British | 25696710002 | ||||||
| DAVIES, Hywel Thomas | Administrateur | Westwinds 1 Heol Pwll Y Pant CF8 2ND Caerphilly Mid Glamorgan | British | 3300280001 | ||||||
| HALL, Wendy Margaret | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court West Midlands | England | British | 172979860001 | |||||
| HILGER, Marcus | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court West Midlands | Germany | German | 238936580003 | |||||
| KEEN, Christian | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court West Midlands | England | British | 54544790004 | |||||
| LIPP, Hanns Martin | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court West Midlands | United Kingdom | German | 220582440001 | |||||
| SHEPHERD, William | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | 162873980001 | |||||
| SMERDON, Peter | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 16898700002 | |||||
| THOMAS, Geoffrey James | Administrateur | 2 Heol Y Coed Rhiwbina CF14 6HP Cardiff Mid Glamorgan | British | 86372480001 | ||||||
| TYLER, Kathryn Maria | Administrateur | 6 Tudor Gardens Machen CF83 8PD Caerphilly | British | 37371780002 | ||||||
| TYLER, Peter Granville | Administrateur | 6 Tudor Gardens Machen CF83 8PD Caerphilly Mid Glamorgan | British | 120983040001 | ||||||
| TYLER, Sharon Elizabeth | Administrateur | Westwinds 1 Heol Pwll Y Pant CF83 2ND Caerphilly Mid Glamorgan | British | 65523330001 | ||||||
| WILLETTS, Andrew John | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 120451550002 | |||||
| WISEMAN, Graham | Administrateur | Cray Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | England | British | 299860960001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RUBY DCO NINE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunamis Mind Accelerator Limited | 31 août 2023 | Cray Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Admenta Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
RUBY DCO NINE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 28 août 2007 Livré le 29 août 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The property known as heol penalta gelligaer 31 tonyfelin rd caerphilly heol bro wen caerphilly,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 01 juin 2007 Livré le 11 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Pharmacy unit at court house medical centre heol bro wen caerphilly mid glamorgan. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 01 juin 2007 Livré le 11 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Ground floor pharmacy k/a gelligaer pharmacy penallta gelligaer and residentialflat above all amounts by way of rent, R. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 19 avr. 2007 Livré le 26 avr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0