SOUTH BANK TELEVISION HOLDINGS
Vue d'ensemble
Nom de la société | SOUTH BANK TELEVISION HOLDINGS |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
Numéro de société | 01241086 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SOUTH BANK TELEVISION HOLDINGS ?
Adresse du siège social | The London Television Centre Upper Ground SE1 9LT London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SOUTH BANK TELEVISION HOLDINGS ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2008 |
Quels sont les derniers dépôts pour SOUTH BANK TELEVISION HOLDINGS ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Eleanor Kate Irving le 16 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Helen Jane Tautz le 16 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 200 Grays Inn Road London WC1X 8HF le 09 oct. 2009 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 2 pages | AA | ||||||||||||||
Statuts | 8 pages | MA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2007 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||||||
Certificat de réimmatriculation de société à responsabilité limitée à société de personnes à responsabilité illimitée | 1 pages | CERT3 | ||||||||||||||
Réenregistrement des statuts | 16 pages | MAR | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 49(8)(b) | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 49(8)(a) | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | 49(1) | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
|
Qui sont les dirigeants de SOUTH BANK TELEVISION HOLDINGS ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVING, Eleanor Kate | Administrateur | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 79177030002 | ||||
TAUTZ, Helen Jane | Administrateur | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 37564540001 | ||||
BROMLEY, Joanna Elizabeth | Secrétaire | 35a Cromford Road Putney SW18 1NZ London | British | Company Secretary | 53881380001 | |||||
HOWELL, Peter Graham | Secrétaire | 76 Kings Road SW19 8QW London | British | 62634010001 | ||||||
IRVING, Eleanor Kate | Secrétaire | Plimsoll Road N4 2ED London 137 | British | Company Secretary | 79177030002 | |||||
ISAACS, Deborah Jane | Secrétaire | The Burrows Poundfield Lane SL6 9RY Cookham Berkshire | British | Secretary | 82079120002 | |||||
TAUTZ, Helen Jane | Secrétaire | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | Company Secretary | 37564540001 | |||||
GRANADA NOMINEES LIMITED | Secrétaire | 200 Grays Inn Road WC1X 8HF London | 76842820003 | |||||||
BLAND, Francis Christopher Buchan, Sir | Administrateur | Blissamore Hall Clanville SP11 9HL Andover Hampshire | England | British | Director | 89150480001 | ||||
CANETTY CLARKE, Neil Ashley | Administrateur | Horsebrooks Farm Williards Will TN19 7DB Etchingham East Sussex | United Kingdom | British | Director | 85247640001 | ||||
CARTWRIGHT, Stacey Lee | Administrateur | 34 Roedean Crescent SW15 5JU London | United Kingdom | British | Company Director | 150700660001 | ||||
CLEMENTS, Alistair | Administrateur | 71 Somerset Avenue Hook KT9 1PS Chessington Surrey | British | Chartered Surveyor | 87536340001 | |||||
COX, Barry Geoffrey | Administrateur | 17 Bathgate Road SW19 5PW London | United Kingdom | British | Director | 73545310001 | ||||
CRESSWELL, John | Administrateur | Rosslyn House 8 Park Road SO22 6AA Winchester Hampshire | United Kingdom | British | Director | 39795820003 | ||||
DYKE, Gregory | Administrateur | 28 Ailsa Road TW1 1QW Twickenham Middlesex | British | Director | 3581020001 | |||||
HARRISON, Desmond Roger Wingate | Administrateur | Itchen Stoke Mill SO24 0RA Alresford Hampshire | England | British | Director | 98607150001 | ||||
MILLER, Ronald Daniel | Administrateur | Larkspur Oakgrange Road GU4 7UD West Clandon Surrey | British | Director | 40890370001 | |||||
MORRISON, Stephen Roger | Administrateur | 16 East Heath Road NW3 1AL London | England | British | Managing Director | 63326820001 | ||||
PARROTT, Graham Joseph | Administrateur | 30 Kings Road EN5 4EE Barnet Hertfordshire | British | Company Secretary | 6741720001 | |||||
SHERIFF, Thomas David | Administrateur | 105 Ladbroke Road RH1 1JT Redhill Surrey | British | Director | 44429170001 | |||||
SOUTHGATE, Michael George | Administrateur | 44 Cranbourne Drive Otterbourne SO21 2EU Winchester Hampshire | British | Director | 54111740002 | |||||
STROSS, Katherine Elizabeth | Administrateur | Cleeve 27 Stamford Road Bowdon WA14 2JT Altrincham Cheshire | England | British | Director | 10387910002 | ||||
TAUTZ, Helen Jane | Administrateur | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | Company Secretary | 37564540001 | ||||
TAYLOR, Kevan | Administrateur | 11 Meadowbrook Close Lostock BL6 4HX Bolton Lancashire | England | English | Director | 15696820001 | ||||
URQUHART, Henry Victor | Administrateur | Dovecote House Yew Tree Close Middle Winterslow SP5 1RT Salisbury Wiltshire | British | Director | 54430330001 | |||||
WALKER, Janet Sheila | Administrateur | Old Golden Gates Cheapside Road SL5 7DR Ascot Berkshire | British | Accountant | 91902840001 | |||||
GRANADA NOMINEES LIMITED | Administrateur | 200 Grays Inn Road WC1X 8HF London | 76842820003 | |||||||
ITV NP LIMITED | Administrateur | 200 Grays Inn Road WC1X 8HF London | 124747120001 |
SOUTH BANK TELEVISION HOLDINGS a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee & debenture | Créé le 15 déc. 1989 Livré le 21 déc. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti And/or london weekend television limited on any account whatsoever. | |
Brèves mentions I) the south bank television centre, kent house, upper ground london S.E.1. t/n:- sgl 214333 & 214334. ii) part princes wharf, 88, commercial road, lambeth, london. T/n:- 399692. including trade fixtures, tenants fixtures, fixed plant & machinery (see form 395. ref M611C for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0