RFBML REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRFBML REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01243054
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RFBML REALISATIONS LIMITED ?

    • (3663) /

    Où se situe RFBML REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Durnsford Mill House
    Milden Hall
    SN8 2NG Marlborough
    Wiltshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RFBML REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BOOTH-MUIRIE LTD21 janv. 200821 janv. 2008
    COLAMET MANUFACTURING LIMITED17 déc. 200117 déc. 2001
    D.H. MUIRIE & CO. LIMITED05 févr. 197605 févr. 1976

    Quels sont les derniers comptes de RFBML REALISATIONS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2009
    Date d'échéance des prochains comptes31 janv. 2010
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2008

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour RFBML REALISATIONS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 déc. 2016
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 janv. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RFBML REALISATIONS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour RFBML REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Démission d'un administrateur

    1 pages2.38B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 22 mai 2011

    7 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 22 nov. 2010

    4 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 22 mai 2010

    9 pages2.24B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    26 pages2.17B

    Certificat de changement de nom

    Company name changed booth-muirie LTD\certificate issued on 21/01/10
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    21 janv. 2010

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    15 pages2.16B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages288b

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2008

    7 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2007

    8 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed colamet manufacturing LIMITED\certificate issued on 21/01/08
    2 pagesCERTNM

    legacy

    8 pages395

    legacy

    3 pages395

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    7 pages155(6)b

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    7 pages155(6)a

    legacy

    1 pages225

    Qui sont les dirigeants de RFBML REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LETHAM, Ian William
    15 Alexandra Park
    Lenzie
    G66 5BH Glasgow
    Administrateur
    15 Alexandra Park
    Lenzie
    G66 5BH Glasgow
    ScotlandBritishCompany Director59102040002
    BOOTH, Steven
    Flat 6
    4 Woodlands Court
    G60 5HH Old Kilpatrick
    Lanarkshire
    Secrétaire
    Flat 6
    4 Woodlands Court
    G60 5HH Old Kilpatrick
    Lanarkshire
    BritishAccountant108687430001
    CATHCART, Ewan Chalmers Fawcett
    Burnbank, 79 Muirs
    KY13 8AZ Kinross
    Perth & Kinross
    Secrétaire
    Burnbank, 79 Muirs
    KY13 8AZ Kinross
    Perth & Kinross
    British94214620001
    FERGUSSON, Alastair Syme
    8 Langlees Avenue
    Newton Mearns
    G77 5ED Glasgow
    Secrétaire
    8 Langlees Avenue
    Newton Mearns
    G77 5ED Glasgow
    British37575130003
    WATSON, Dawn
    52 Cleveden Road
    G12 0JW Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    52 Cleveden Road
    G12 0JW Glasgow
    Lanarkshire
    British126355130001
    YACOUBIAN, Paul
    The Bishops House
    Porterfield Road
    PA13 4PD Kilmacolm
    Secrétaire
    The Bishops House
    Porterfield Road
    PA13 4PD Kilmacolm
    BritishDirector82368330001
    BURDEN, Arthur James
    Axholme 288 Wilbraham Road
    Whalley Range
    M16 8LT Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    Axholme 288 Wilbraham Road
    Whalley Range
    M16 8LT Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishChartered Accountant123652250001
    CATHCART, Ewan Chalmers Fawcett
    Burnbank, 79 Muirs
    KY13 8AZ Kinross
    Perth & Kinross
    Administrateur
    Burnbank, 79 Muirs
    KY13 8AZ Kinross
    Perth & Kinross
    BritishEngineer And Director94214620001
    DOUGLAS, Ian George
    24 Abbotsford Crescent
    ML10 6EQ Strathaven
    Lanarkshire
    Administrateur
    24 Abbotsford Crescent
    ML10 6EQ Strathaven
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector46671430001
    GIBSON, Ian Sutherland
    23 Stonehouse Road
    ML10 6LF Strathaven
    Lanarkshire
    Administrateur
    23 Stonehouse Road
    ML10 6LF Strathaven
    Lanarkshire
    BritishOperations Director62266000001
    MUIRIE, David Henry
    49 Durness Avenue
    Bearsden
    G61 2AL Glasgow
    Administrateur
    49 Durness Avenue
    Bearsden
    G61 2AL Glasgow
    BritishDirector2066610001
    WALLACE, Stewart John
    46 Cleveden Drive
    G12 0NU Glasgow
    Administrateur
    46 Cleveden Drive
    G12 0NU Glasgow
    ScotlandOtherCompany Director40874620002
    WATSON, Dawn
    52 Cleveden Road
    G12 0JW Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    52 Cleveden Road
    G12 0JW Glasgow
    Lanarkshire
    BritishChartered Accountant126355130001
    YACOUBIAN, Paul
    The Bishops House
    Porterfield Road
    PA13 4PD Kilmacolm
    Administrateur
    The Bishops House
    Porterfield Road
    PA13 4PD Kilmacolm
    ScotlandBritishDirector82368330001

    RFBML REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 mars 2007
    Livré le 29 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge
    Créé le 19 mars 2007
    Livré le 30 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited (The Security Holder)
    Transactions
    • 30 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Assignment of life policy
    Créé le 07 août 2002
    Livré le 28 août 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Policy of assurance with halifax life limited numbered ASSHOO1766 on the life of dawn watson.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Assignment of keyman life policy intimation dated 25 july 2002 and assignation
    Créé le 24 juil. 2002
    Livré le 06 août 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy no. X71984052 with standard life assurance company dated 14/5/2001 in the sum of £125,000.00 and life assured: ian george douglas together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Assignation of keyman life policy
    Créé le 26 août 1998
    Livré le 03 sept. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Life policy number 7107033LB with general accident life assurance dated 21ST may 1998 on the life of stewart john wallace for the sum of £250,000 and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security
    Créé le 13 août 1990
    Livré le 28 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Units 1, 2, 3, 4, 5/6, & 7 albion trading estate, south street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 28 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 27 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 août 1990
    Livré le 11 août 1990
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 11 août 1990Enregistrement d'une charge

    RFBML REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 nov. 2009Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    practitioner
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Neil A Armour
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    practitioner
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0