SANTA BARBARA HOTELS LIMITED

SANTA BARBARA HOTELS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSANTA BARBARA HOTELS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01243282
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SANTA BARBARA HOTELS LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe SANTA BARBARA HOTELS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SANTA BARBARA HOTELS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SANTA BARBARA HOTELS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SANTA BARBARA HOTELS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 janv. 2016

    État du capital au 07 janv. 2016

    • Capital: GBP 25,000
    SH01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 55 Baker Street London W1U 7EU

    1 pagesAD04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    9 pagesAA

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2014

    État du capital au 16 déc. 2014

    • Capital: GBP 25,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Elizabeth Fabni le 04 août 2014

    2 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Marriott Harrison Staple Court 11 Staple Inn Buildings London WC1V 7QH United Kingdom à 55 Baker Street London W1U 7EU

    1 pagesAD02

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 avr. 2015 au 31 déc. 2014

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de 189-190 Queen's Gate London SW7 5EX à 55 Baker Street London W1U 7EU le 19 août 2014

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Mh Secretaries Limited en tant que secrétaire le 07 juil. 2014

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Con Christopher Ring en tant que directeur le 07 juil. 2014

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Murphy en tant que directeur le 07 juil. 2014

    2 pagesTM01

    Nomination de Giovanni Battista Decandia en tant qu'administrateur le 07 juil. 2014

    3 pagesAP01

    Nomination de Elizabeth Fabni en tant qu'administrateur le 07 juil. 2014

    3 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2014

    8 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2013

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2012

    12 pagesAA

    Nomination de Peter Murphy en tant qu'administrateur le 25 janv. 2013

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Edward Thomas Bracken en tant que directeur le 25 janv. 2013

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SANTA BARBARA HOTELS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DECANDIA, Giovanni Battista
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    ItalyItalianExecutive189696300001
    FABRI, Elisabetta
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    ItalyItalianPresident And Ceo187748230001
    MCKAY, Peter Beverley
    15 Mayford Road
    SW12 8RZ London
    Secrétaire
    15 Mayford Road
    SW12 8RZ London
    English5263580002
    QUIGLEY, Con
    Horwath House
    The Red Church
    Henry Street
    Horwath Bastow Charleton
    Limerick
    Ireland
    Secrétaire
    Horwath House
    The Red Church
    Henry Street
    Horwath Bastow Charleton
    Limerick
    Ireland
    British148178500001
    MH SECRETARIES LIMITED
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    Secrétaire
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2893220
    39754020001
    MH SECRETARIES LIMITED
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Secrétaire
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    39754020001
    BLAIN, Douglas Ellis
    23 Brompton Square
    SW3 2AD London
    Administrateur
    23 Brompton Square
    SW3 2AD London
    United KingdomBritishCompany Director29943890001
    BRACKEN, Edward Thomas
    40 Herons Place
    Old Isleworth
    TW7 7BE London
    Administrateur
    40 Herons Place
    Old Isleworth
    TW7 7BE London
    United KingdomIrishCompany Director121058070001
    DALE-THOMAS, Brian Dale
    39 Poultons Square
    SW3 London
    Administrateur
    39 Poultons Square
    SW3 London
    BritishHotelier32158880003
    DALE-THOMAS, Norfudd Aminge
    39 Poultons Square
    SW3 London
    Administrateur
    39 Poultons Square
    SW3 London
    BritishHotelier32158890002
    HULTON, Cosmo
    Hill House 3 Upland Road
    St. Peter Port
    GY1 1UJ Guernsey
    Channel Islands
    Administrateur
    Hill House 3 Upland Road
    St. Peter Port
    GY1 1UJ Guernsey
    Channel Islands
    GuernseyEnglishCompany Director7215070003
    MCKAY, Peter Beverley
    15 Mayford Road
    SW12 8RZ London
    Administrateur
    15 Mayford Road
    SW12 8RZ London
    United KingdomEnglishCompany Director5263580002
    MURPHY, Peter
    189-190 Queen's Gate
    London
    SW7 5EX
    Administrateur
    189-190 Queen's Gate
    London
    SW7 5EX
    IrelandIrishCompany Director114920360002
    RING, Con Christopher
    Halford Road
    TW10 6AP Richmond
    6
    Surrey
    Administrateur
    Halford Road
    TW10 6AP Richmond
    6
    Surrey
    United KingdomIrishCompany Director115593320001

    SANTA BARBARA HOTELS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 juin 2007
    Livré le 04 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 sept. 2006
    Livré le 09 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Ireland Limited
    Transactions
    • 09 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 18 août 1999
    Livré le 20 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold property known as 189-190 queensgate london SW7 5EX. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 mai 1994
    Livré le 06 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific charge over its goodwill and the benefit of any licences all patents patent applications inventions trade-marks trade names registered designs copyrights know-how and any other intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 avr. 1990
    Livré le 28 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a the gove hotel 189/190 queens gate london SW7 title no ln 131122.
    Personnes ayant droit
    • National Investment Bank LTD
    Transactions
    • 28 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 31 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 1980
    Livré le 01 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property known as the gore hotel 189/190 queens gate S.w 7 together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery title no. Ln 131122. all other f/h & l/h property of the company now vested in it together with. Buildings fixtures fixed plant and machinery. Fixed charge all future f/h & l/h property of the company together with all buildings fixtures & fixed plant and machinery and all the goodwill & uncalled capital of the company. Fixed charge on book & other debts of the company floating charge over all other the undertaking and assets of the company whatsoever.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank LTD
    Transactions
    • 01 avr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 01 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0