GREYCOAT EXECUTIVE RESOURCING LIMITED

GREYCOAT EXECUTIVE RESOURCING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGREYCOAT EXECUTIVE RESOURCING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01252518
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GREYCOAT EXECUTIVE RESOURCING LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe GREYCOAT EXECUTIVE RESOURCING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    Bedfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GREYCOAT EXECUTIVE RESOURCING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    UYJ (SUNBURY) LIMITED24 mai 199424 mai 1994
    SERVICELINK PERSONNEL SERVICES LIMITED10 sept. 199010 sept. 1990
    HEMAN CONTRACTS LIMITED25 oct. 198325 oct. 1983
    KENTSTAR CONSTRUCTION LIMITED31 mars 197631 mars 1976

    Quels sont les derniers comptes de GREYCOAT EXECUTIVE RESOURCING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour GREYCOAT EXECUTIVE RESOURCING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Retrait de la demande de radiation de la société

    2 pagesDS02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    15 pagesMG01

    legacy

    15 pagesMG01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 déc. 2011

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 avr. 2012

    État du capital au 12 avr. 2012

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 1st Floor Pellipar House 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom

    1 pagesAD02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2010

    9 pagesAA

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom

    1 pagesAD02

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2009

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Burchall le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Rebecca Jane Watson le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Rebecca Jane Watson le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2008

    10 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de GREYCOAT EXECUTIVE RESOURCING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    BritishSolicitor70686070002
    BURCHALL, Andrew Jeremy
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director69904570002
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor70686070002
    ABRAHAMSON, John David
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    Secrétaire
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    BritishChartered Accountant26433460001
    BROWN, Gareth Trevor
    11 Manor Fields
    RH13 6SA Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    11 Manor Fields
    RH13 6SA Horsham
    West Sussex
    British15885460001
    CATT, Richard John
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    Secrétaire
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    BritishLawyer1367810004
    DRUMMOND, Gordon Clelland
    100 Cocker Street
    FY1 2EB Blackpool
    Lancashire
    Secrétaire
    100 Cocker Street
    FY1 2EB Blackpool
    Lancashire
    British46763930001
    MARTIN, Christopher Paul
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    Secrétaire
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    British64640450003
    ABRAHAMSON, John David
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    Administrateur
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    BritishChartered Accountant26433460001
    BALDWIN, Alan Peter
    Field House
    Churt
    GU10 2QE Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Field House
    Churt
    GU10 2QE Farnham
    Surrey
    BritishDirector56675660001
    BALDWIN, Paul Graham
    10 Copse Road
    KT11 2TN Cobham
    Surrey
    Administrateur
    10 Copse Road
    KT11 2TN Cobham
    Surrey
    BritishCompany Director9801390001
    BRAILEY, Geoffrey Ian
    Oakfields Theobalds Road
    RH15 0SS Burgess Hill
    East Sussex
    Administrateur
    Oakfields Theobalds Road
    RH15 0SS Burgess Hill
    East Sussex
    BritishChartered Accountant10317690002
    CATT, Richard John
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    Administrateur
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    EnglandBritishLawyer1367810004
    CORNISH, Diana Frederica
    Green Acres Lower Luton Road
    AL5 5EG Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Green Acres Lower Luton Road
    AL5 5EG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChairman Recruitment6048720001
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    Administrateur
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    EnglandBritishDirector266121440001
    DRUMMOND, Gordon Clelland
    100 Cocker Street
    FY1 2EB Blackpool
    Lancashire
    Administrateur
    100 Cocker Street
    FY1 2EB Blackpool
    Lancashire
    BritishAccountant46763930001
    DUNCKLEY, Peter John
    Lake House Deerleap Road
    Westcott
    RH4 3LE Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Lake House Deerleap Road
    Westcott
    RH4 3LE Dorking
    Surrey
    EnglandBritishAccountant1173580001
    DUNCKLEY, Peter John
    Lake House Deerleap Road
    Westcott
    RH4 3LE Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Lake House Deerleap Road
    Westcott
    RH4 3LE Dorking
    Surrey
    EnglandBritishAccountant1173580001
    EDEN, Roger Charles
    Peters Court Plymouth Drive
    Barnt Green
    B45 8JB Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    Peters Court Plymouth Drive
    Barnt Green
    B45 8JB Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishChartered Accountant41649520001
    LAKE, David Anthony
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Administrateur
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    EnglandBritishDirector59820940001
    MARTIN, Christopher Paul
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    Administrateur
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    United KingdomBritishDirector64640450003
    PEARCE, Christopher Thomas
    Felcourt
    RH19 2JY East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    Felcourt
    RH19 2JY East Grinstead
    West Sussex
    BritishGroup Finance Director56051620001
    ROWLEY, John
    Hickling Lodge
    Melton Road
    LE14 3QG Hickling Pastures
    Leicestershire
    Administrateur
    Hickling Lodge
    Melton Road
    LE14 3QG Hickling Pastures
    Leicestershire
    EnglandBritishCompany Director11900790002
    SARSON, Michael Robert
    12 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BS Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    12 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BS Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector27419330001
    WARD JONES, Robert
    Merryn
    33 Roedean Crescent
    SW15 5JX London
    Administrateur
    Merryn
    33 Roedean Crescent
    SW15 5JX London
    BritishGroup Secretary46039780001

    GREYCOAT EXECUTIVE RESOURCING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and fixed and floating charge
    Créé le 23 août 2012
    Livré le 28 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Créé le 08 août 2012
    Livré le 14 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Guarantee & debenture
    Créé le 06 mai 2008
    Livré le 17 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 27 avr. 2007
    Livré le 12 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company (jointly and severally with each security obligor) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 avr. 2004
    Livré le 12 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee (whether for its own account or as agent or trustee for the finance parties) or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The chargor charges all the mortgaged property all real property the mortgaged property being the freehold property 39 ardwick green north manchester t/n GM654955, l/h property brierley hill shaw house wychbury court two woods lane dudley & l/h property being newcastle suite 2 gunner house by way of fixed charge its insurances its intellectual property rights any beneficial interest claim or entitlement it may have in any pension fund its uncalled capital by way of floating charge all present and future assets property business undertaking and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited as Security Trustee
    Transactions
    • 12 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 31 août 2000
    Livré le 20 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities owing by any obligor to the chargee under any of the finance documents whether a). Present or future b). Actual or contingent or c). Owed solely, jointly or severally
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Credit Llc the ("Security Trustee" and "Security Bene Ficiary") and Gmac Commercial Credit Development Limited ("Gmac UK") ("Security Beneficiary")
    Transactions
    • 20 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 13 mai 1999
    Livré le 20 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 22 avr. 1991
    Livré le 10 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all goodwill & uncalled capital & all patents patent applications inventions trade marks etc (see 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 03 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 mai 1990
    Livré le 10 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    17 back bridge street manchester title no gm 349982.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 19 janv. 1990
    Livré le 07 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed chargee over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding uncalled capital those mentioned above).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 juil. 1988
    Livré le 11 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    17 back bridge street manchester title no gm 349982. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 03 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 oct. 1981
    Livré le 09 nov. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H locking sharp 1 & 2 & basement of cortlets house 38 king street west manchester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1981Enregistrement d'une charge
    • 03 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 juin 1981
    Livré le 19 juin 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable change over the companys f/h or l/h properties fixed & floating charges over lee undertaking and all property and assets present and futurea specific equitable charge over the company f/h or l/h properties fixed & floating charges over lee undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1981Enregistrement d'une charge
    • 03 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 mai 1980
    Livré le 10 mai 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 27,000
    Brèves mentions
    L/H interest at units 1 & 2 and basement courtlets house king street manchester together with all fixtures etc.
    Personnes ayant droit
    • R Ahmed Awan
    Transactions
    • 10 mai 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0