PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED

PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01258241
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED ?

    • (6521) /

    Où se situe PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BSM LIMITED17 oct. 200017 oct. 2000
    BSM HOLDINGS LIMITED31 déc. 198131 déc. 1981
    TAURUS VEHICLE LEASING LIMITED31 déc. 197631 déc. 1976
    VAZMOSS LIMITED12 mai 197612 mai 1976

    Quels sont les derniers comptes de PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2016

    16 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    11 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2015

    12 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2014

    14 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 21 janv. 2013

    28 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 30 juin 2012

    20 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 31 déc. 2011

    20 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 30 juil. 2011

    27 pages2.24B

    Certificat de changement de nom

    Company name changed bsm LIMITED\certificate issued on 31/03/11
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name31 mars 2011

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Résultat de la réunion des créanciers

    1 pages2.23B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.15B/2.14B

    7 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    65 pages2.17B

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Changement d'adresse du siège social de * 2Nd Floor Building 2610 the Quadrant Aztec West Bristol BS32 4TR* le 09 févr. 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juil. 2010

    État du capital au 28 juil. 2010

    • Capital: GBP 618,038.23
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Abu-Haris Shafi le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nikolai Kesting le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Willoughby Corporate Secretarial Limited le 01 oct. 2009

    2 pagesCH04

    Qui sont les dirigeants de PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    80
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    80
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02691637
    68522760005
    KESTING, Nikolai
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    Administrateur
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    GermanyGermanManaging Director137231520001
    SHAFI, Abu-Haris
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    Administrateur
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director137231430002
    ATKINSON, Paul Robert
    29 Longlands Road
    DA15 7LU Sidcup
    Kent
    Secrétaire
    29 Longlands Road
    DA15 7LU Sidcup
    Kent
    British5884180001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    BritishSolicitor32782910002
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    Secrétaire
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    1278390005
    ATKINSON, Paul Robert
    4 Victoria Road
    DA15 7HD Sidcup
    Kent
    Administrateur
    4 Victoria Road
    DA15 7HD Sidcup
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant5884180002
    CALDWELL, Findlay Martin
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    GbBritishDirector50777030001
    CAMP, Michael James
    Heath Cottage
    Marriotts Avenue, South Heath
    HP16 9QW Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Heath Cottage
    Marriotts Avenue, South Heath
    HP16 9QW Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director12204760003
    DAUMANN, Christian
    Gam-Bischefsheim
    Rulaenderweg 11
    55296
    Germany
    Administrateur
    Gam-Bischefsheim
    Rulaenderweg 11
    55296
    Germany
    GermanDirector132789860001
    DEAKIN, Janice
    Field Barn
    Broad Road
    IP20 0AZ Alburgh
    Norfolk
    Administrateur
    Field Barn
    Broad Road
    IP20 0AZ Alburgh
    Norfolk
    EnglandBritishInsurance Company Official238355920001
    EASTER, Philip Charles
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    Administrateur
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    EnglandBritishInsurance Company Official105999210001
    EGAN, Scott
    18 Broadmead Green
    Thorpe End
    NR13 5DE Norwich
    Administrateur
    18 Broadmead Green
    Thorpe End
    NR13 5DE Norwich
    BritishInsurance Company Official111697420001
    GLOVER, Richard Gordon Finlay
    86 Grange Road
    Ealing
    W5 3PJ London
    Administrateur
    86 Grange Road
    Ealing
    W5 3PJ London
    EnglandBritishCompany Director5884200002
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Administrateur
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director116885790001
    HEWITT, Alison Deborah
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director66782800004
    LEVER, Paul Ronald Scott
    Great Peter Street
    SW1P 3LR London
    35
    Administrateur
    Great Peter Street
    SW1P 3LR London
    35
    United KingdomBritishCompany Director106971650001
    MACHELL, Simon Christopher
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    Administrateur
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official145338560001
    MASSEY, Paul Ashley
    20 Elwill Way
    Park Langley
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    Administrateur
    20 Elwill Way
    Park Langley
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant24243460001
    SNOWBALL, Patrick Joseph Robert
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Administrateur
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    BritishInsurance Company Official38351740003
    SPICKER, Richard Harold
    Honeysuckle Barn
    Brands Lane, Felthorpe
    NR10 4EA Norwich
    Administrateur
    Honeysuckle Barn
    Brands Lane, Felthorpe
    NR10 4EA Norwich
    EnglandBritishInsurance Company Official120021510001
    TODD, David
    64 Long Road
    Framingham Earl
    NR14 7RZ Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    64 Long Road
    Framingham Earl
    NR14 7RZ Norwich
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official70494790001
    WALDEN, Jonathan Kim
    Hyatt Lodge
    Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Hyatt Lodge
    Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishDirector3809630002

    PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 09 juil. 2010
    Livré le 22 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of change of deposited monies
    Créé le 16 sept. 2009
    Livré le 18 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The debt or debts repesented by any money from time to time standing to the credit of or treated as part of the companys account number 8067436 at 20-13-42 (security account) see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 18 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 10 févr. 2009
    Livré le 13 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Rac PLC (Noteholder)
    Transactions
    • 13 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 14 févr. 1997
    Livré le 25 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as 81/87 hartfield road london borough of merton, title numbers SY257925 the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 20 mai 1993
    Livré le 07 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter and or the guarantee and debenture
    Brèves mentions
    Fixed charge over all stocks shares and all copyrights patents trademarks etc. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties as Defined
    Transactions
    • 07 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee debenure
    Créé le 13 avr. 1990
    Livré le 20 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee unde the terms of the facilities agreement and the interest rate protection agreements and this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of mortgage and charge
    Créé le 30 janv. 1987
    Livré le 16 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 28.1.87 and/or this charge
    Brèves mentions
    Mortgage & charge of the aircraft described in schedule 1 to the deed including the engines and all equipment instanlled at delivery or installed on the aircraft and all replacements renewals and additions (please see form 395 M21/17 feb/ln and schedule for full details).
    Personnes ayant droit
    • Svenska Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 16 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Aircraft & mortgage
    Créé le 11 avr. 1985
    Livré le 17 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For accuring £3,300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Bristol aeropace 125 series 800B aircraft constructors serial no 258028 (please see doc M23 for details).
    Personnes ayant droit
    • Lombart North Central PLC
    Transactions
    • 17 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Chattel mortgage
    Créé le 31 déc. 1984
    Livré le 03 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing £3,600,00/ and all other moneys due or to become due from the comapny to the chargee under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    British aerospace 125 series 800B aircraft constructors serial no:- 258028.
    Personnes ayant droit
    • Combard North Central PLC
    Transactions
    • 03 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 20 déc. 1984
    Livré le 04 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the contract dted 14TH december 1984 and/or this charge
    Brèves mentions
    Motor vehicles belonging to the company from time to time, purcharsed pursuant tto the said agreement dated 14TH decembeer, 1984.
    Personnes ayant droit
    • Austin Rover Finance Limited
    Transactions
    • 04 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    Deed of mortgage
    Créé le 25 janv. 1983
    Livré le 03 févr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan facility letter dated 29TH november, 1982.
    Brèves mentions
    British aeordspace 125 series 700 b aircraft serial no 257189 reg mark g-osam with all equipments and engines.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 1983Enregistrement d'une charge

    PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2011Administration started
    31 janv. 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers
    One Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers
    One Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    2
    DateType
    16 sept. 2016Dissolved on
    31 janv. 2013Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers
    One Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers
    One Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0