BRIGHTON & HOVE SPORTS AND LEISURE LIMITED

BRIGHTON & HOVE SPORTS AND LEISURE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRIGHTON & HOVE SPORTS AND LEISURE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01258519
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRIGHTON & HOVE SPORTS AND LEISURE LIMITED ?

    • Autres activités sportives (93199) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe BRIGHTON & HOVE SPORTS AND LEISURE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Maria House
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRIGHTON & HOVE SPORTS AND LEISURE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ADDYPOOL LIMITED14 mai 197614 mai 1976

    Quels sont les derniers comptes de BRIGHTON & HOVE SPORTS AND LEISURE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour BRIGHTON & HOVE SPORTS AND LEISURE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Grant Bloom le 27 juil. 2018

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 déc. 2015

    État du capital au 02 déc. 2015

    • Capital: GBP 121,711
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 déc. 2014

    État du capital au 01 déc. 2014

    • Capital: GBP 121,711
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 déc. 2013

    État du capital au 02 déc. 2013

    • Capital: GBP 121,711
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Francis Comer le 23 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Raymond Alexander Bloom le 23 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Robert Francis Comer le 23 nov. 2013

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Derek Leonard Chapman le 23 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Grant Bloom le 23 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Martin John Perry le 23 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de BRIGHTON & HOVE SPORTS AND LEISURE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COMER, Robert Francis
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Maria House
    England
    Secrétaire
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Maria House
    England
    British67614720001
    BLOOM, Anthony Grant
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Maria House
    England
    Administrateur
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Maria House
    England
    EnglandBritishDirector49338470004
    BLOOM, Raymond Alexander
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Maria House
    England
    Administrateur
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Maria House
    England
    EnglandBritishDirector2562110001
    CHAPMAN, Derek Leonard
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Maria House
    England
    Administrateur
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Maria House
    England
    EnglandBritishDirector7734800005
    COMER, Robert Francis
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Maria House
    England
    Administrateur
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Maria House
    England
    EnglandBritishDirector67614720001
    PERRY, Martin John
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Maria House
    England
    Administrateur
    35 Millers Road
    BN1 5NP Brighton
    Maria House
    England
    United KingdomBritishDirector54870840002
    BELLOTTI, David Frank
    29 St Davids Close
    BN22 0UZ Eastbourne
    East Sussex
    Secrétaire
    29 St Davids Close
    BN22 0UZ Eastbourne
    East Sussex
    BritishSecretary39541640001
    CLARKE, Bernard Edward
    65 Dyke Road Avenue
    BN3 6DA Hove
    East Sussex
    Secrétaire
    65 Dyke Road Avenue
    BN3 6DA Hove
    East Sussex
    British2237450001
    LEIGH, Timothy Roy
    18 Byng Road
    TN4 8EJ Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    18 Byng Road
    TN4 8EJ Tunbridge Wells
    Kent
    British84964570001
    PINNOCK, Robert Leonard
    25 Hurst Road
    BN6 9NJ Hassocks
    West Sussex
    Secrétaire
    25 Hurst Road
    BN6 9NJ Hassocks
    West Sussex
    BritishCompany Director3274400002
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    BritishDirector15170380004
    BELLOTTI, David Frank
    29 St Davids Close
    BN22 0UZ Eastbourne
    East Sussex
    Administrateur
    29 St Davids Close
    BN22 0UZ Eastbourne
    East Sussex
    BritishChief Executive39541640001
    BLOOM, Raymond Alexander
    Tongdean Road
    BN3 6QE Hove
    21
    East Sussex
    Administrateur
    Tongdean Road
    BN3 6QE Hove
    21
    East Sussex
    EnglandBritishDirector2562110001
    CAMPBELL, John Leslie
    Beechwood House
    Chelworth Park
    RH17 7LE Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Beechwood House
    Chelworth Park
    RH17 7LE Haywards Heath
    West Sussex
    BritishDirector25582530001
    CAMPBELL, John Leslie
    Beechwood House
    Chelworth Park
    RH17 7LE Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Beechwood House
    Chelworth Park
    RH17 7LE Haywards Heath
    West Sussex
    BritishDirector25582530001
    CLARKE, Bernard Edward
    65 Dyke Road Avenue
    BN3 6DA Hove
    East Sussex
    Administrateur
    65 Dyke Road Avenue
    BN3 6DA Hove
    East Sussex
    United KingdomBritishAccountant2237450001
    FAULKNER, Richard Oliver, Lord Faulkner Of Worcester
    13 Wilton Crescent
    Wimbledon
    SW19 3QY London
    Administrateur
    13 Wilton Crescent
    Wimbledon
    SW19 3QY London
    EnglandBritishManaging Director68334050001
    GRIFFITHS, Kevin Ralph Patrick
    Parkmead 22 Lodge Lane
    BN6 8NA Hassocks
    West Sussex
    Administrateur
    Parkmead 22 Lodge Lane
    BN6 8NA Hassocks
    West Sussex
    BritishInvestment Banker71268040001
    KENT, Peter Frederick
    Riseholme Tylers Green
    Cuckfield
    RH17 5EA Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Riseholme Tylers Green
    Cuckfield
    RH17 5EA Haywards Heath
    West Sussex
    BritishDirector16555890001
    KNIGHT, Harry Richard
    Flat 6 6 Third Avenue
    BN3 2PD Hove
    East Sussex
    Administrateur
    Flat 6 6 Third Avenue
    BN3 2PD Hove
    East Sussex
    EnglandBritishDirector82103400002
    LLOYD, Barry David
    34 Arundel Road
    BN13 3EQ Worthing
    West Sussex
    Administrateur
    34 Arundel Road
    BN13 3EQ Worthing
    West Sussex
    BritishFootball Club Manager24424970001
    PINNOCK, Robert Leonard
    25 Hurst Road
    BN6 9NJ Hassocks
    West Sussex
    Administrateur
    25 Hurst Road
    BN6 9NJ Hassocks
    West Sussex
    GbBritishCompany Director3274400002
    SIZEN, Dudley Charles
    East End 103 East End Lane
    Ditchling
    BN6 8UR Hassocks
    West Sussex
    Administrateur
    East End 103 East End Lane
    Ditchling
    BN6 8UR Hassocks
    West Sussex
    BritishDirector2237460001
    SMITH, John Alfred, Sir
    23 Winterbourne
    RH12 5JW Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    23 Winterbourne
    RH12 5JW Horsham
    West Sussex
    UkCompany Director49209950003
    STANLEY, Gregory Alexander
    Street Farm
    Fittleworth
    RH20 1EL Pulborough
    West Sussex
    Administrateur
    Street Farm
    Fittleworth
    RH20 1EL Pulborough
    West Sussex
    BritishDirector55200780001
    SULLIVAN, Dennis
    49 Shirley Drive
    BN3 6UB Hove
    East Sussex
    Administrateur
    49 Shirley Drive
    BN3 6UB Hove
    East Sussex
    BritishAdvertising Executive2562160001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRIGHTON & HOVE SPORTS AND LEISURE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Brighton & Hove Albion Holdings Limited
    Village Way
    Falmer
    BN1 9BL Brighton
    American Express Community Stadium
    England
    06 avr. 2016
    Village Way
    Falmer
    BN1 9BL Brighton
    American Express Community Stadium
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légale2006 Companies Act
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement02849319
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    BRIGHTON & HOVE SPORTS AND LEISURE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 mai 2000
    Livré le 22 mai 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transactions
    • 22 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 juin 1999
    Livré le 15 juil. 1999
    En cours
    Montant garanti
    £250,000.00 due or to become due from brighton & hove albion football club limited to the chargee and guaranteed by the company and brighton & hove albion holdings limited to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Derek Leonard Chapman
    Transactions
    • 15 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 23 avr. 1999
    Livré le 14 mai 1999
    En cours
    Montant garanti
    £500,000 due or to become due from the brighton & hove albion football club limited to the chargee and guaranteed by the company and brighton & hove albion holdings limited to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Kevin Ralph Patrick Griffiths
    Transactions
    • 14 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 30 nov. 1998
    Livré le 04 déc. 1998
    En cours
    Montant garanti
    £500,213.00 due from the company to the chargee and guaranteed by the brighton & hove albion football club limited and brighton & hove albion holdings limited under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Raymond Bloom
    Transactions
    • 04 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee & debenture
    Créé le 02 sept. 1997
    Livré le 11 sept. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the loan agreement of even date and the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Harry Richard Knight
    Transactions
    • 11 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 02 sept. 1997
    Livré le 11 sept. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in connection with a loan agreement of even date and the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Robert Leonard Pinnock
    Transactions
    • 11 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debentrue
    Créé le 02 sept. 1997
    Livré le 16 sept. 1997
    En cours
    Montant garanti
    £1,319,474 due or to become due from the brighton & hove albion football club limited to the chargee and guaranteed by the company and foray 585 limited to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • William Ernest Archer
    Transactions
    • 16 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 09 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Foray 585 Limited
    Transactions
    • 09 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 04 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0