EC INSURANCE COMPANY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EC INSURANCE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01266206 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EC INSURANCE COMPANY LIMITED ?
| Adresse du siège social | 20 Fenchurch Street EC3M 3AZ London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EC INSURANCE COMPANY LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour EC INSURANCE COMPANY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 31 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital au 16 déc. 2020
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Cessation de la nomination de John William James Spencer en tant que directeur le 30 nov. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew John Davies en tant que directeur le 30 nov. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anne Whitaker en tant que directeur le 30 nov. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 07 août 2020
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Christopher Barrett en tant que directeur le 31 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 39 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Wilson en tant que directeur le 31 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew John Bailey en tant que secrétaire le 01 juil. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Ms Lara Simone Teesdale en tant que secrétaire le 01 juil. 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 39 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EC INSURANCE COMPANY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEESDALE, Lara Simone | Secrétaire | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | 260051420001 | |||||||||||
| FORREST SMITH, Richard David | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | England | British | 102435300002 | |||||||||
| GALJAARD, Neil Edward | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | England | British | 204442520001 | |||||||||
| BAILEY, Andrew John | Secrétaire | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | 240711450001 | |||||||||||
| BOORMAN, John Edward | Secrétaire | 5 Birchwood Avenue DA14 4JY Sidcup Kent | British | 15508940001 | ||||||||||
| BROMLEY, Diane | Secrétaire | 24-26 South Park TN13 1DU Sevenoaks Eca Court Kent England | 198910410001 | |||||||||||
| BURNLEY, Martyn James | Secrétaire | 14 Rectory Road BR3 1HW Beckenham 12 Kent United Kingdom | British | 27337290001 | ||||||||||
| HUDSON, Roger William | Secrétaire | Esca House 32-34 Palace Crt W2 4HY Bayswater London | 158258790001 | |||||||||||
| CS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 55 King Street M2 4LQ Manchester Fifth Floor England |
| 110006210003 | ||||||||||
| ELEMENTAL COSEC LIMITED | Secrétaire | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 England |
| 197411090001 | ||||||||||
| ELEMENTAL COSEC LIMITED | Secrétaire | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 England |
| 197411090001 | ||||||||||
| ABLETT, Timothy Andrew, The Estate Of Mr | Administrateur | Esca House 32-34 Palace Crt W2 4HY Bayswater London | England | British | 65924000005 | |||||||||
| ADAMSON, William Richard | Administrateur | 62 The Drive TN9 2LR Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 58631570003 | |||||||||
| BARRETT, Simon Christopher | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 265262510001 | |||||||||
| BELDHAM, David Thomas Anthony | Administrateur | Esca House 32-34 Palace Crt W2 4HY Bayswater London | United Kingdom | British | 72444750001 | |||||||||
| BRATT, Stephen John | Administrateur | 24-26 South Park TN13 1DU Sevenoaks Eca Court Kent England | United Kingdom | British | 157959100001 | |||||||||
| BROMLEY, Diane Elizabeth, Ma | Administrateur | 24-26 South Park TN13 1DU Sevenoaks Eca Court Kent England | England | British | 149175470001 | |||||||||
| BROOKS, Stephen Thomas | Administrateur | 24-26 South Park TN13 1DU Sevenoaks Eca Court Kent England | England | British | 43905590001 | |||||||||
| BROWN, Roger Stewart | Administrateur | Somersbury 6 Stoneyfields GU9 8DX Farnham Surrey | United Kingdom | British | 31524860001 | |||||||||
| BURNLEY, Martyn James | Administrateur | 24-26 South Park TN13 1DU Sevenoaks Eca Court Kent England | England | British | 155149100001 | |||||||||
| COCKERILL, Desmond Frank | Administrateur | 54 Angel Hill SM1 3EW Sutton Surrey | United Kingdom | British | 1674730001 | |||||||||
| CRILLEY, Mark Stewart | Administrateur | Esca House 32-34 Palace Crt W2 4HY Bayswater London | England | British | 64359420001 | |||||||||
| CROSBY, Ian Paul | Administrateur | 56 Baldwins Hill IG10 1SF Loughton Essex | United Kingdom | British | 20521820001 | |||||||||
| DAVIES, Andrew John | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 240686570001 | |||||||||
| DAWSON, Peter | Administrateur | Whitfield 138 Whalley Road Wilpshire BB1 9LJ Blackburn | British | 77394370001 | ||||||||||
| FEARN, Garry Michael | Administrateur | 24-26 South Park TN13 1DU Sevenoaks Eca Court Kent England | England | British | 50970000002 | |||||||||
| FORD, Arthur Bryan | Administrateur | Deer Leap Southwell Road Oxton NG25 0RJ Nottingham | United Kingdom | British | 35677080001 | |||||||||
| GIFFEN, George | Administrateur | Delaport Lodge Lamer Lane Wheathampstead AL4 8RQ St Albans Hertfordshire | British | 9652340003 | ||||||||||
| GUIRY, Paul Philip | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 United Kingdom | England | Irish | 202435410001 | |||||||||
| HALL, Robert Michael | Administrateur | 55 Vastern Road RG1 8BU Reading Berkshire | British | 62702340002 | ||||||||||
| HANNAN, John Stephen | Administrateur | 16 Hatchlands RH12 5JX Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 102435400001 | |||||||||
| HOPE, Alistair Robert | Administrateur | 16 Downs Cote Drive Westbury On Trym BS9 3TP Bristol Avon | England | British | 23445410001 | |||||||||
| HUMPHREYS, Peter David | Administrateur | 38 Sargison Road RH16 1HX Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | 102435480002 | |||||||||
| HURSTHOUSE, Trevoe George | Administrateur | Lingwood Lane Woodborough NG14 6DX Nottingham The Old Vicarage Nottinghamshire | United Kingdom | British | 138919350001 | |||||||||
| JENNINGS, George William Bryan | Administrateur | 52 Grove Park Terrace Chiswick W4 3QE London | British | 15508950001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EC INSURANCE COMPANY LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markel Capital Holdings Limited | 28 nov. 2017 | Fenchurch Street EC3M 3AZ London 20 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ec Insurance Holdings Limited | 06 avr. 2016 | South Park TN13 1DU Sevenoaks 24-25 Kent England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
EC INSURANCE COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Memorandum of deposit and charge and escrow agreement | Créé le 11 mars 1994 Livré le 12 mars 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed supplemental to risk excess of loss reinsurance agreement dated 11TH march 1994 | |
Brèves mentions The bearer and reg: UK government debt securities as are deposited with the escrow agent pursuant to the provisions of the charge all other rights securities moneys and property in respect of the securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0