GCI LONDON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGCI LONDON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01269264
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GCI LONDON LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe GCI LONDON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Rose Court
    2 Southwark Bridge Road
    SE1 9HS London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GCI LONDON LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PCI LONDON LTD30 juin 200830 juin 2008
    GCI LONDON LIMITED12 févr. 199212 févr. 1992
    GCI STERLING LIMITED26 mai 198926 mai 1989
    STERLING PUBLIC RELATIONS LIMITED31 déc. 197631 déc. 1976
    BONDTIME LIMITED16 juil. 197616 juil. 1976

    Quels sont les derniers comptes de GCI LONDON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour GCI LONDON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01
    XBJ91JW1

    Déclaration de confirmation établie le 18 nov. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XBH0D2PX

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04
    XAYW9H8I

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04
    XAYW9HXM

    Changement d'adresse du siège social de Lynton House 7-12 Tavistock Square London WC1H 9LT à Rose Court 2 Southwark Bridge Road London SE1 9HS le 14 janv. 2022

    1 pagesAD01
    XAVOTBH5

    Déclaration de confirmation établie le 17 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XAID18L4

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    9 pagesAA
    AA3VZOIH

    Déclaration de confirmation établie le 17 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X9I6MOD6

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    9 pagesAA
    A904BSRS

    Déclaration de confirmation établie le 17 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X8IRTECP

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    9 pagesAA
    A8D9EKU3

    Déclaration de confirmation établie le 17 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X7KT2A2R

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    9 pagesAA
    A6YXBNSZ

    Déclaration de confirmation établie le 17 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X6JEZ42Y

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    4 pagesAA
    A63CBSSH

    Déclaration de confirmation établie le 17 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X5K10NHV

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    4 pagesAA
    A510MX49

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 déc. 2015

    État du capital au 17 déc. 2015

    • Capital: GBP 200,001
    SH01
    X4MEO4WB

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    4 pagesAA
    A481BVBE

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 nov. 2014

    État du capital au 21 nov. 2014

    • Capital: GBP 200,001
    SH01
    X3L4LQ6H

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    4 pagesAA
    A39CX0VT

    Modification des coordonnées du secrétaire Wpp Group (Nominees) Limited le 20 déc. 2013

    1 pagesCH04
    X2NN0AOG

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 déc. 2013

    État du capital au 20 déc. 2013

    • Capital: GBP 200,001
    SH01
    X2NMZD8P

    Qui sont les dirigeants de GCI LONDON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Secrétaire
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement2757919
    80143770001
    WEST, Ian
    2 Southwark Bridge Road
    SE1 9HS London
    Rose Court
    England
    Administrateur
    2 Southwark Bridge Road
    SE1 9HS London
    Rose Court
    England
    United KingdomBritishCompany Director175296410001
    BERGEN, John Donald
    876 Gainsway Road
    PA 19067 Yardley
    Pennsylvania
    Usa
    Secrétaire
    876 Gainsway Road
    PA 19067 Yardley
    Pennsylvania
    Usa
    Us CitizenPulbic Relations Executive36971950001
    GRIFFITHS, Sally Jane
    83 Brian Avenue
    CR2 9NJ South Croydon
    Surrey
    Secrétaire
    83 Brian Avenue
    CR2 9NJ South Croydon
    Surrey
    British91601070001
    LAM, Steve Wye Keong
    5 Oakwood Avenue
    WD6 1SP Borehamwood
    Hertfordshire
    Secrétaire
    5 Oakwood Avenue
    WD6 1SP Borehamwood
    Hertfordshire
    Malaysian56183390001
    LYSIONEK, Susan Mary
    Nightingales
    GU3 1DT Compton
    Surrey
    Secrétaire
    Nightingales
    GU3 1DT Compton
    Surrey
    British78777420001
    AINGER, Colin
    10 Fir Trees
    Tidys Lane
    CM16 6SJ Epping
    Essex
    Administrateur
    10 Fir Trees
    Tidys Lane
    CM16 6SJ Epping
    Essex
    EnglandBritishPublic Relations Consultant18056800001
    ARNOLD, Virginia
    76 Westfield Avenue
    Barnes
    SW13 0AZ London
    Administrateur
    76 Westfield Avenue
    Barnes
    SW13 0AZ London
    BritishCompany Director112176580001
    BEATTIE, Geoffrey Spencer
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    Administrateur
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    United KingdomBritishManaging Director131562650001
    BERGEN, John Donald
    876 Gainsway Road
    PA 19067 Yardley
    Pennsylvania
    Usa
    Administrateur
    876 Gainsway Road
    PA 19067 Yardley
    Pennsylvania
    Usa
    Us CitizenPublic Relations Executive36971950001
    BRILL, John
    Rookhurst Coast Hill Lane
    Westcott
    RH4 3LJ Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Rookhurst Coast Hill Lane
    Westcott
    RH4 3LJ Dorking
    Surrey
    BritishCompany Director10684530001
    BRYAN, Harriet
    141 Acton Lane
    Chiswick
    W4 5HW London
    Administrateur
    141 Acton Lane
    Chiswick
    W4 5HW London
    BritishPublic Relations Executive37442420001
    CARTER, Carolyn
    2 Sterling Street
    SW7 1HN London
    Administrateur
    2 Sterling Street
    SW7 1HN London
    AmericanCompany Director80287820001
    CARTWRIGHT, Roderick Anthony
    46 St Julian's Farm Road
    SE27 0RS London
    Administrateur
    46 St Julian's Farm Road
    SE27 0RS London
    EnglandBritishPr Executive109202680001
    CATER, Mark
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    United Kingdom
    Administrateur
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    United Kingdom
    BritishCompany Director116938400003
    CLARK, Nicholas John
    53 Wick Road
    TW11 9DN Teddington
    Administrateur
    53 Wick Road
    TW11 9DN Teddington
    United KingdomBritishAccount Director75978080002
    DADRA, Raj Kumar
    30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    New Bridge Street House
    Administrateur
    30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    New Bridge Street House
    BritishCompany Director88610840003
    DALBY, Derek George
    Glebe Corner
    Croft Road
    CR3 7EG Woldingham
    Surrey
    Administrateur
    Glebe Corner
    Croft Road
    CR3 7EG Woldingham
    Surrey
    BritishCompany Director16975870001
    DEWHURST, Philip
    29 Chesfield Road
    KT2 5TH Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    29 Chesfield Road
    KT2 5TH Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishPublic Relations Consultant77166960001
    DOBSON, Isabel Claire
    16 Hartley Way
    CR8 4EG Purley
    Surrey
    Administrateur
    16 Hartley Way
    CR8 4EG Purley
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director66065060002
    EDWARDS, Roger John
    The Thatches
    Forest Road
    GU22 8LU Pyrford
    Surrey
    Administrateur
    The Thatches
    Forest Road
    GU22 8LU Pyrford
    Surrey
    BritishAdvertising Executive36176200001
    HARRIES, Rhodri Nicholas Lloyd
    104 Fernside Road
    SW12 8LJ London
    Administrateur
    104 Fernside Road
    SW12 8LJ London
    BritishPr Consultant74124480002
    INGRAM, Tamara
    Middle House
    No 12 Highbury Place
    N5 1QZ London
    Administrateur
    Middle House
    No 12 Highbury Place
    N5 1QZ London
    United KingdomBritishCompany Director76558150002
    KNOWLES, David Christopher
    Flat 4
    56 Nightingale Lane
    SW12 8NY London
    Administrateur
    Flat 4
    56 Nightingale Lane
    SW12 8NY London
    BritishPublic Relations Executive37442460001
    LINNELL, Peter John
    Rivers Reach
    Hamm Court
    KT13 8YA Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Rivers Reach
    Hamm Court
    KT13 8YA Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishFinancial Director63174210002
    MADDOCK, Paul
    Flat 4
    13 Elder Avenue
    N8 9TE London
    Administrateur
    Flat 4
    13 Elder Avenue
    N8 9TE London
    BritishCompany Director102154190001
    MCAVOY, Michael Anthony
    Middleton House
    Milton Abbas
    DT11 0BS Blandford Forum
    Dorset
    Administrateur
    Middleton House
    Milton Abbas
    DT11 0BS Blandford Forum
    Dorset
    BritishCompany Director47510970001
    MEDLEY, Richard David
    21 Wexfenne Gardens
    Pyrford
    GU22 8TX Woking
    Surrey
    Administrateur
    21 Wexfenne Gardens
    Pyrford
    GU22 8TX Woking
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director166924940001
    MOUCHLY-WEISS, Harriet
    777 Third Avenue
    FOREIGN New York 10017
    Usa
    Administrateur
    777 Third Avenue
    FOREIGN New York 10017
    Usa
    AmericanCompany Director16975880001
    NOBLE, Fiona Catherine
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    Administrateur
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    United KingdomBritishCeo146832700001
    PENSON, Alan Anthony
    Fairfield House
    HP8 4EL Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Fairfield House
    HP8 4EL Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Secretary490110001
    PICKERING, Conor
    38 Grafton Terrace
    NW5 London
    Administrateur
    38 Grafton Terrace
    NW5 London
    BritishPublic Relations76542890001
    RANDLE, Caroline Anne Mary
    47 Biddulph Mansions
    Elgin Avenue
    W9 1HT London
    Administrateur
    47 Biddulph Mansions
    Elgin Avenue
    W9 1HT London
    BritishPublic Relations70063750001
    RODLEY, Fiona Elsbeth
    9 Latimer Close
    54 Kensington Park Road
    W11 3BL London
    Administrateur
    9 Latimer Close
    54 Kensington Park Road
    W11 3BL London
    BritishAdvertising Executive96595430001
    RYAN, Susan Frances
    24 Ravenslea Road
    SW12 8RY London
    Administrateur
    24 Ravenslea Road
    SW12 8RY London
    BritishPublic Relations47402280001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GCI LONDON LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Hatton Garden
    EC1N 8JS London
    77
    England
    17 nov. 2016
    Hatton Garden
    EC1N 8JS London
    77
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1795794
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    GCI LONDON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 15 oct. 2001
    Livré le 25 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barclays bank PLC re gci london limited, business premium account number 40256374. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 29 sept. 1998
    Livré le 07 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    In barclays bank PLC business premium account number 60779008. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 sept. 1994
    Livré le 10 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 01 mars 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 25 mars 1987
    Livré le 06 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    22 chelsea manor gardens london SW3 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 06 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 28 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 1982
    Livré le 07 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge overall f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale threof fixed & floating charge overundertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 07 oct. 1982Enregistrement d'une charge
    • 28 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0