BPAC REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBPAC REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01273309
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BPAC REALISATIONS LIMITED ?

    • (2522) /

    Où se situe BPAC REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o RESOLVE PARTNERS LLP
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BPAC REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BELPAC LIMITED06 déc. 198306 déc. 1983

    Quels sont les derniers comptes de BPAC REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2010

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BPAC REALISATIONS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BPAC REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    11 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 juil. 2014

    12 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 janv. 2013

    12 pages2.24B

    Certificat de changement de nom

    Company name changed belpac LIMITED\certificate issued on 23/11/12
    2 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name23 nov. 2012

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesF2.18

    Changement d'adresse du siège social de * Heath Mill Road Wombourne Wolverhampton West Midlands WV5 8AP* le 17 juil. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    2 pagesMG02

    legacy

    9 pagesMG01

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juil. 2011

    État du capital au 07 juil. 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Jeyes Group Ltd 7 Brunel Way Thetford Norfolk IP24 1HF England

    1 pagesAD02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2010

    4 pagesAA

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Cessation de la nomination de Colin Deeley en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gregor Miller en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nicholas Goodwin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Blunt en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Nicholls en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Colin Deeley en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Kevan Michael Howley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de BPAC REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOWLEY, Kevan Michael
    Admirals Walk, West Cliff Road
    BH2 5HF Bournemouth
    99
    England
    Administrateur
    Admirals Walk, West Cliff Road
    BH2 5HF Bournemouth
    99
    England
    United KingdomBritishDirector147457440001
    DEELEY, Colin
    11 Rathlin Close
    Pendeford
    WV9 5RP Wolverhampton
    West Midlands
    Secrétaire
    11 Rathlin Close
    Pendeford
    WV9 5RP Wolverhampton
    West Midlands
    BritishAccountant53046060001
    SMITH, Mark
    1 Gleneagles Avenue
    OL10 2BZ Heywood
    Lancashire
    Secrétaire
    1 Gleneagles Avenue
    OL10 2BZ Heywood
    Lancashire
    British2910100001
    ADAMS, John Bruce
    Heath Mill Road
    Wombourne
    WV5 8AP Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    Heath Mill Road
    Wombourne
    WV5 8AP Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director129805310001
    BIRD, Roger Cornelius
    3 Woodhouse Lane
    Priorslee
    TF2 9SX Telford
    Salop
    Administrateur
    3 Woodhouse Lane
    Priorslee
    TF2 9SX Telford
    Salop
    BritishDirector22445620001
    BLUNT, Ian Roger
    18 The Riddings
    DY9 0XJ Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    18 The Riddings
    DY9 0XJ Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director42465390002
    BRIDGES, Alan Norton
    4 Kings Drive
    CB8 8DG Newmarket
    Suffolk
    Administrateur
    4 Kings Drive
    CB8 8DG Newmarket
    Suffolk
    BritishDirector42127760002
    COLLEY, Michael John
    Strathlene
    The Park, Great Barton
    IP31 2SU Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    Strathlene
    The Park, Great Barton
    IP31 2SU Bury St. Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishDirector63599250001
    DEELEY, Colin
    11 Rathlin Close
    Pendeford
    WV9 5RP Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    11 Rathlin Close
    Pendeford
    WV9 5RP Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritishAccountant53046060001
    GOODWIN, Nicholas David
    Uplands Farmhouse Chandlers Road
    Stoke Holy Cross
    NR14 8RE Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Uplands Farmhouse Chandlers Road
    Stoke Holy Cross
    NR14 8RE Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector49424950001
    LANCASHIRE, Frank, Doctor
    9 Greenfield Lane
    CH2 2PA Chester
    Cheshire
    Administrateur
    9 Greenfield Lane
    CH2 2PA Chester
    Cheshire
    BritishDirector2893710001
    MILLER, Gregor Arthur Livingstone
    Birkdale Court
    Fornham St. Martin
    IP28 6XF Bury St. Edmunds
    11
    Suffolk
    England
    Administrateur
    Birkdale Court
    Fornham St. Martin
    IP28 6XF Bury St. Edmunds
    11
    Suffolk
    England
    EnglandBritishCompany Director129805390002
    MURRAY, Louis
    Derrockstown
    IRISH Dunslaughlin
    County Meath
    Ireland
    Administrateur
    Derrockstown
    IRISH Dunslaughlin
    County Meath
    Ireland
    IrishDirector53248690001
    NICHOLLS, Ian Anthony
    4 Woodland Road
    Finchfield
    WV3 8AR Wolverhampton
    Administrateur
    4 Woodland Road
    Finchfield
    WV3 8AR Wolverhampton
    EnglandBritishSalesman170296530001
    POPHAM, Neil Rowland
    Whitehouse Farm
    Berden
    CM23 1AE Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Whitehouse Farm
    Berden
    CM23 1AE Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChief Executive48644450001
    SMITH, Mark
    1 Gleneagles Avenue
    OL10 2BZ Heywood
    Lancashire
    Administrateur
    1 Gleneagles Avenue
    OL10 2BZ Heywood
    Lancashire
    BritishAccountant2910100001
    SOUTHALL, John Leslie
    3 The Mill Pool
    Oakdrive Seisdon
    WV5 7ET Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    3 The Mill Pool
    Oakdrive Seisdon
    WV5 7ET Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritishAccountant4847600001

    BPAC REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 06 déc. 2011
    Livré le 10 déc. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Pulse Cashflow Finance Limited
    Transactions
    • 10 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Full form debenture
    Créé le 07 juin 2011
    Livré le 13 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Leumi Abl Limited
    Transactions
    • 13 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Accession letter to a guarantee and debenture dated 22 december 2006 and
    Créé le 09 déc. 2010
    Livré le 30 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from jhl to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Legal & General Ventures Partners Limited as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 30 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 2009
    Livré le 05 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 05 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 2009
    Livré le 30 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 2009
    Livré le 30 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 30 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 11 sept. 2002
    Livré le 20 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Unit 16 bromfield lane industrial estate mold t/n CYM82138, units 1 to 5 and 9 to 15 bromfield lane industrial estate and land on the south west side of queens lane mold t/n WA934415 (for details of further properties charged please refer to form 395)(. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 20 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 juin 1990
    Livré le 17 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 29 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 1985
    Livré le 19 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and factory premises fronting to heath mill road, wombourne, staffo rdshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 1985Enregistrement d'une charge
    • 29 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 mai 1983
    Livré le 31 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 mai 1983Enregistrement d'une charge
    • 29 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BPAC REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 juil. 2012Administration started
    09 juil. 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Harris
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    practitioner
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    Cameron Gunn
    One America Square
    EC3N 2LB Crosswall
    London
    practitioner
    One America Square
    EC3N 2LB Crosswall
    London
    Mark Supperstone
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London
    practitioner
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London
    2
    DateType
    09 juil. 2013Commencement of winding up
    26 sept. 2015Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Harris
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    practitioner
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    Cameron Gunn
    One America Square
    EC3N 2LB Crosswall
    London
    practitioner
    One America Square
    EC3N 2LB Crosswall
    London
    Mark Supperstone
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London
    practitioner
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0