STERIPAK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTERIPAK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01273708
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STERIPAK LIMITED ?

    • fabrication de produits pharmaceutiques de base (21100) / Industries manufacturières

    Où se situe STERIPAK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp St Philips Point
    Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STERIPAK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PHARM-MEDICA LABORATORIES LIMITED18 août 197618 août 1976

    Quels sont les derniers comptes de STERIPAK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour STERIPAK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    26 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de Ridings Point Whistler Drive Castleford West Yorkshire WF10 5HX United Kingdom le 09 nov. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 25 oct. 2012

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 août 2012

    État du capital au 29 août 2012

    • Capital: GBP 2,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de Regent House 5-7 Broadhurst Gardens London NW6 3RZ Uk le 10 août 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    8 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Jacquie Gentles Wragge & Co Llp 55 Colmore Row Birmingham West Midlands B3 2AS United Kingdom

    2 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages287

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages190

    Qui sont les dirigeants de STERIPAK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BHATTACHARJEE, Dipankar
    Ridings Point
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    Teva Uk Limited
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ridings Point
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    Teva Uk Limited
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector140709230001
    WILLIAMS, Robert
    Ridings Point
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    Teva Uk Limited
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ridings Point
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    Teva Uk Limited
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant138004470001
    GOODWIN, Trevor John
    32 The Drive
    Snaresbrook
    E18 2BL London
    Secrétaire
    32 The Drive
    Snaresbrook
    E18 2BL London
    British22270330001
    HORSMAN, Peter Brian
    Regent House
    5-7 Broadhurst Gardens, Swiss Cottage
    NW6 3RZ London
    Secrétaire
    Regent House
    5-7 Broadhurst Gardens, Swiss Cottage
    NW6 3RZ London
    BritishFinance Director112816940003
    LIVESEY, Ewan Murray
    Brands Farm
    Hudsons Hill
    CM7 4EH Wethersfield
    Essex
    Secrétaire
    Brands Farm
    Hudsons Hill
    CM7 4EH Wethersfield
    Essex
    British63582200005
    WALL, Graham John
    Melbourne House Hoseley Lane
    Marford
    LL12 8YE Wrexham
    Clwyd
    Secrétaire
    Melbourne House Hoseley Lane
    Marford
    LL12 8YE Wrexham
    Clwyd
    British19885060001
    BAIN, Martyn Robert
    108 Parkstone Avenue
    RM11 3LR Emerson Park
    Essex
    Administrateur
    108 Parkstone Avenue
    RM11 3LR Emerson Park
    Essex
    EnglandBritishFinancial Director60147920004
    BEIGHTON, John
    Regent House
    5-7 Broadhurst Gardens, Swiss Cottage
    NW6 3RZ London
    Administrateur
    Regent House
    5-7 Broadhurst Gardens, Swiss Cottage
    NW6 3RZ London
    BritishManaging Director115332820003
    BENNETT, Clive Ronald Reath
    6 Beaumont Park Drive
    Roydon
    CM19 5HB Harlow
    Essex
    Administrateur
    6 Beaumont Park Drive
    Roydon
    CM19 5HB Harlow
    Essex
    BritishGroup Operations Director58814230002
    BLACK, Ian
    Greys
    Widford Road
    SG10 6AP Much Hadham
    Herts
    Administrateur
    Greys
    Widford Road
    SG10 6AP Much Hadham
    Herts
    BritishPharmaceutical Executive30355790001
    BLANKSBY, David Robert
    21 Clarence Gate
    IG8 8GN Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    21 Clarence Gate
    IG8 8GN Woodford Green
    Essex
    BritishManaging Direct71380130002
    CONDELLA, Frank Charles
    405 Fairway Road
    Ridgewood
    Nj 07450
    Usa
    Administrateur
    405 Fairway Road
    Ridgewood
    Nj 07450
    Usa
    AmericanManaging Director83831030006
    FORRESTER-COLES, Stephen Lannon
    The Old Vicarage
    Shocklach
    SY14 7BN Malpas
    Cheshire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Shocklach
    SY14 7BN Malpas
    Cheshire
    BritishDirector68026420001
    FOSTER, Nicholas Mark
    15 The Granary
    CM19 5EL Roydon
    Essex
    Administrateur
    15 The Granary
    CM19 5EL Roydon
    Essex
    EnglandBritishSales And Marketing Director52253090001
    GILLESPIE, Carol Jean
    The Grand Condominiums
    1717 North Bayshore Drive
    FOREIGN Unit 1446 Miami
    Florida 33132
    Usa
    Administrateur
    The Grand Condominiums
    1717 North Bayshore Drive
    FOREIGN Unit 1446 Miami
    Florida 33132
    Usa
    AmericanSnr Vice President / Secretary61301000001
    GOODWIN, Trevor John
    32 The Drive
    Snaresbrook
    E18 2BL London
    Administrateur
    32 The Drive
    Snaresbrook
    E18 2BL London
    British22270330001
    HORSMAN, Peter Brian
    Regent House
    5-7 Broadhurst Gardens, Swiss Cottage
    NW6 3RZ London
    Administrateur
    Regent House
    5-7 Broadhurst Gardens, Swiss Cottage
    NW6 3RZ London
    BritishFinance Director112816940003
    KING, John Leslie
    8 Brookland Road
    Whitley
    WN1 2QG Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    8 Brookland Road
    Whitley
    WN1 2QG Wigan
    Lancashire
    BritishAccountant50414300001
    LIVESEY, Ewan Murray
    Brands Farm
    Hudsons Hill
    CM7 4EH Wethersfield
    Essex
    Administrateur
    Brands Farm
    Hudsons Hill
    CM7 4EH Wethersfield
    Essex
    BritishSolicitor63582200005
    MCAFFER, Ian Gardner Cameron
    88 Mount Pleasant
    Biggin Hill
    TN16 3TR Westerham
    Kent
    Administrateur
    88 Mount Pleasant
    Biggin Hill
    TN16 3TR Westerham
    Kent
    BritishDirector30355820001
    NORTON, Nigel Niman
    98 Gordon Avenue
    HA7 3QS Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    98 Gordon Avenue
    HA7 3QS Stanmore
    Middlesex
    BritishDirector16781270002
    PFENNIGER, Richard Charles
    6490 Sw 106 Street
    33156 Miami
    Florida
    United States
    Administrateur
    6490 Sw 106 Street
    33156 Miami
    Florida
    United States
    AmericanDirector/Attorney36994190002
    ROSE, Howard
    73 Fluin Lane
    Frodsham
    WA6 7QT Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    73 Fluin Lane
    Frodsham
    WA6 7QT Warrington
    Cheshire
    BritishDirector53550420001
    STRATTON, Anthony Hugh
    15 Lindsay Road
    TW12 1DR Hampton Hill
    Middlesex
    Administrateur
    15 Lindsay Road
    TW12 1DR Hampton Hill
    Middlesex
    EnglandBritishFinance Director234426110001
    TABERNILLA, Armando
    1032 Andalusia Avenue
    Coral Gables
    Florida
    33134
    Usa
    Administrateur
    1032 Andalusia Avenue
    Coral Gables
    Florida
    33134
    Usa
    AmericanAttorney55523920003
    WALL, Graham John
    Melbourne House Hoseley Lane
    Marford
    LL12 8YE Wrexham
    Clwyd
    Administrateur
    Melbourne House Hoseley Lane
    Marford
    LL12 8YE Wrexham
    Clwyd
    BritishDirector19885060001
    WILSON, David Arnold
    52 Derwent Close
    Alsager
    ST7 2EL Stoke On Trent
    Staffs
    Administrateur
    52 Derwent Close
    Alsager
    ST7 2EL Stoke On Trent
    Staffs
    BritishDirector37846080001

    STERIPAK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security deed
    Créé le 22 mai 1989
    Livré le 02 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the financing documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Ruxley Holdings Limited
    Transactions
    • 02 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 30 sept. 1988
    Livré le 07 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Arbuthust Leasing International Limited
    Transactions
    • 07 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 03 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security deed
    Créé le 06 avr. 1988
    Livré le 07 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company and/or waverley pharmacutical limited under the terms fo the charge
    Brèves mentions
    (For fulld etails see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Robert Fleming & Co Limited
    Transactions
    • 07 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security deed registered pursuant to an order of court
    Créé le 13 nov. 1987
    Livré le 22 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to be come due from and/or waverley pharmaceutical limited undder the terms of the financing documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Robert Fleming & Co Limited
    Transactions
    • 22 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 15 juin 1987
    Livré le 22 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & flaoting charge undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1987Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 mai 1987
    Livré le 22 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the and/or waverley pharmaceutical LTD under the terms of me financing documents company to the chargee
    Brèves mentions
    All present and future estates or interst in any f/h or l/h property belonging to it and all buildings and fixtures thereon and all proceeds of sale thereof. (See form 395 for further details).
    Personnes ayant droit
    • William Francis Muddyman
    Transactions
    • 22 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 16 juin 1982
    Livré le 21 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ficed & floating charge on the undertaking and property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 juin 1982Enregistrement d'une charge

    STERIPAK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 mars 2014Dissolved on
    25 oct. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Graham Paul Bushby
    Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    practitioner
    Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Guy Edward Brooke Mander
    The Poynt Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    practitioner
    The Poynt Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0