ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED

ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01277502
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FTMF LEASING MARCH (E) LIMITED01 avr. 199701 avr. 1997
    FORWARD MOTOR FINANCE LIMITED01 mars 199501 mars 1995
    GRIFFIN DISCOUNT LIMITED16 sept. 197616 sept. 1976

    Quels sont les derniers comptes de ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Deuxième dépôt pour la nomination de Crispin Robert John Irvin en tant qu'administrateur

    6 pagesRP04AP01

    Cessation de la nomination de John Richard Kent en tant que directeur le 31 mai 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Rob Irvin en tant qu'administrateur le 22 mars 2017

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    07 juin 2017Clarification A second filed AP01 was registered on 07/06/2017.

    Cessation de la nomination de Michael Connelly Anderson en tant que directeur le 22 mars 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    26 pagesAA

    Cessation de la nomination de Robin Louis Henning Bencard en tant que directeur le 01 août 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 mai 2016

    État du capital au 05 mai 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mr Simon Einar Long en tant qu'administrateur le 15 mars 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David John Cavanna en tant que directeur le 31 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Michael Connelly Anderson en tant qu'administrateur le 16 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    18 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Nomination de Ms Romana Lewis en tant que secrétaire le 12 juin 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Hannah Elizabeth Shepherd en tant que secrétaire le 12 juin 2015

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mai 2015

    État du capital au 08 mai 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Tony Bhambhra en tant que secrétaire le 05 janv. 2015

    1 pagesTM02

    Nomination de Hannah Elizabeth Shepherd en tant que secrétaire le 05 janv. 2015

    2 pagesAP03

    Comptes établis au 31 déc. 2013

    18 pagesAA

    Nomination de Tony Bhambhra en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Katherine Dean en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E14 5HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Secrétaire
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E14 5HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    198529700001
    IRVIN, Crispin Robert John
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish228671160001
    LONG, Simon Einar
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish206202590001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Secrétaire
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    188917860001
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180092010001
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Secrétaire
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Secrétaire
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Secrétaire
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Secrétaire
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    READ, Alice
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    Secrétaire
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    British106168980003
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194209440001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154950760001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    166967360001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Administrateur
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    DEVENISH, William Frederick
    12 Hyde Place
    OX2 7JB Oxford
    Administrateur
    12 Hyde Place
    OX2 7JB Oxford
    British52830160002
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Administrateur
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Administrateur
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Administrateur
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    HOLMES, Timothy Victor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    Administrateur
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    British28497420002
    KELL, Christopher Raymond
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    Administrateur
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    British87307470001
    KENNY, Mary Bridget
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    Administrateur
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    United KingdomBritish118995490002
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    LANE, Robert David
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    Administrateur
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    EnglandBritish150099050001
    MEAD, David Harry
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish254170760001
    PICKEN, Graham Edward
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    Administrateur
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    British144947830001
    QUINN, Noel Paul
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    British72093050001
    SENIOR, Carl Thomas
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish165728830001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    26 oct. 2016
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement229341
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Specific legal mortgage (no 10)
    Créé le 27 févr. 2004
    Livré le 11 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to the equipment identified by the serial numbers described in or attached to schedule 1 to such first priority mortgage, the benefit of all insurances of the specific equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transactions
    • 11 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Specific legal mortgage (no 9)
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 02 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The equipment as specifid in first priority mortgage (specific equipment) , all insurances, compensation payable and warranties, contracts or other agreements relating to the specific equipment.
    Personnes ayant droit
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transactions
    • 02 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Specific legal mortgage (no 8)
    Créé le 31 oct. 2003
    Livré le 04 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The equipment identified by the serial numbers described in or attached to schedule 1 to such first priority mortgage; the benefit of all insurances of the specific equipment; any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment; and all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof.
    Personnes ayant droit
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transactions
    • 04 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Specific legal mortgage (no 7)
    Créé le 30 sept. 2003
    Livré le 02 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right, title and interest present and future in and to the equipment described in schedule 1 of the first priority mortgage (specific equipment) the benefit of all insurances of the specific equipment, any compensation payable in respect of the compulsory purchase or requisition for title of the specific equipment and all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof.
    Personnes ayant droit
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transactions
    • 02 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Specific legal mortgage (no 6)
    Créé le 29 août 2003
    Livré le 08 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right, title and interest present and future in and to the equipment described in schedule 1 of the charge (specific equipment) the benefits of all insurances of the specific equipment any compensation payable in respect of the compulsory acquisition for title of the specific equipment all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof.
    Personnes ayant droit
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transactions
    • 08 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    First priority mortgage
    Créé le 31 juil. 2003
    Livré le 05 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest present and future in and to the equipment, the benefit of all insurances of the specific equiptment, any compensation payable, all warranties, contracts or other agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transactions
    • 05 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A first priority mortgage
    Créé le 30 juin 2003
    Livré le 01 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The equipment, the benefit of all insurances of the specific equipment, any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment and all warraties contracts or other agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transactions
    • 01 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A first priority mortgage
    Créé le 30 mai 2003
    Livré le 03 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the equipment (as further defined therein) the benefit of all insurances, any compensation payable and all warranties contracts or other agreements in respect of the said equioment.
    Personnes ayant droit
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transactions
    • 03 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    First priority mortgage
    Créé le 30 avr. 2003
    Livré le 07 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The equipment and the benefit of all insurances of the specific equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transactions
    • 07 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A first priority mortgage
    Créé le 31 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right, title and interest present and future in and to: (a) the equipment (b) the benefit of all insurances of the specific equipment (c) any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment, and (d) all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use of repair of the specific equipment or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • P&O Nedlloyds Limited
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An account assignment
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company's right, title and interest present and future in and to: (a) the interest bearing dollar account of the company opened by the company with citibank international PLC designated "p&o re asset finance december (w) limited (lessor proceeds ACCOUNT0" and with account number 0020482508 and with swift address "CITTGB2LELA" (the "account") and any re-designation and sub-accounts of the account (b) the moneys, interest and other amounts from time to time credited to, and for the time being standing to the credit of, the account, and (c) any certificates of deposits, deposit receipt or other instruments or securities relating to the items described above. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A first priority mortgage
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right, title, interest and benefit (if any) present and future in and to: (a) the equipment (b) the benefit of all insurances of the equipment, and (c) any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0