COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED

COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01277895
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED ?

    • (3002) /

    Où se situe COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COLUMBIA RIBBON & CARBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED02 mars 199502 mars 1995
    KOLOK MANUFACTURING COMPANY LIMITED31 déc. 197831 déc. 1978
    ALPHA OMICRON LIMITED20 sept. 197620 sept. 1976

    Quels sont les derniers comptes de COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2011
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2012
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 07 sept. 2012

    14 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 15 mars 2012

    12 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    30 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    29 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    10 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de Kangley Bridge Road London SE26 5AW le 30 sept. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2010

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 oct. 2010

    État du capital au 26 oct. 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    legacy

    8 pagesMG01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2009

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2008

    11 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2007

    11 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2006

    11 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    9 pages395

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2005

    11 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2004

    13 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2003

    19 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REECE, Martin John
    56 Ridge Way
    TN8 6AR Edenbridge
    Kent
    Secrétaire
    56 Ridge Way
    TN8 6AR Edenbridge
    Kent
    British76493570001
    MCCARRON, Patrick John
    45 Winsford Road
    Catford
    SE6 4LS London
    Administrateur
    45 Winsford Road
    Catford
    SE6 4LS London
    United KingdomBritishCompany Director95215360001
    REECE, Martin John
    56 Ridge Way
    TN8 6AR Edenbridge
    Kent
    Administrateur
    56 Ridge Way
    TN8 6AR Edenbridge
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director76493570001
    SIMON, Michael John
    Staffhurst Barn
    Nr Whitehouse Farm
    TN8 6QG Edenbridge
    Kent
    Administrateur
    Staffhurst Barn
    Nr Whitehouse Farm
    TN8 6QG Edenbridge
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director95215450001
    BURDETT, Roger Leonard
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    British53792200005
    DUCKWORTH, Simon Charles
    8 Newtons Croft Crescent
    Barlborough
    S43 4WA Chesterfield
    Derbyshire
    Secrétaire
    8 Newtons Croft Crescent
    Barlborough
    S43 4WA Chesterfield
    Derbyshire
    British44867860001
    HALE, Vivien Joan
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishAccountant56115110001
    NEAL, Peter Richard
    Coppers
    Cox Hill Boxford
    CO10 5HR Sudbury
    Suffolk
    Secrétaire
    Coppers
    Cox Hill Boxford
    CO10 5HR Sudbury
    Suffolk
    British11209680002
    PORTER, Michael James Robert
    Woodfield House
    Halifax Road Hipperholme
    HX3 8HD Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Woodfield House
    Halifax Road Hipperholme
    HX3 8HD Halifax
    West Yorkshire
    British22243580001
    RIDLEY, John Henry Wallace
    52 Park Lane
    DY12 2EU Bewdley
    Worcestershire
    Secrétaire
    52 Park Lane
    DY12 2EU Bewdley
    Worcestershire
    British1746550001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secrétaire
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    BARKER, Philip Dennison
    7 Brecks Gardens
    Kippax
    LS25 7LP Leeds
    Administrateur
    7 Brecks Gardens
    Kippax
    LS25 7LP Leeds
    United KingdomBritishDirector40070580001
    BAXTER, Alan John
    Endon Hays Farm Dingle Lane
    Rushton Spencer
    SK11 0RX Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Endon Hays Farm Dingle Lane
    Rushton Spencer
    SK11 0RX Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Director35520050002
    BOWERS, Eric John
    The Viewlands
    Longridge Dunston
    ST18 9AL Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    The Viewlands
    Longridge Dunston
    ST18 9AL Stafford
    Staffordshire
    BritishFinance Director57549940001
    BULLOCK, Paul Richard
    1 Millview
    Alwalton
    PE7 3UW Peterborough
    Administrateur
    1 Millview
    Alwalton
    PE7 3UW Peterborough
    BritishCompany Director44329700001
    BURDETT, Roger Leonard
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    Administrateur
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    BritishChief Executive53792200005
    FLETCHER, Anthony Trevor
    Higher Oaklands Farm House
    Barrowford
    BB9 6QZ Nelson
    Administrateur
    Higher Oaklands Farm House
    Barrowford
    BB9 6QZ Nelson
    BritishCompany Director113788270001
    GUMIENNY, Marek Stefan
    13 Lambolle Road
    Belsize Park
    NW3 4HS London
    Administrateur
    13 Lambolle Road
    Belsize Park
    NW3 4HS London
    BritishInvestment Manager66370740001
    HALE, Vivien Joan
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishAccountant56115110001
    HANCOX, Roger Frederic
    Lower Leys 46 Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HW Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    Lower Leys 46 Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HW Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Director1597600001
    JAMESON, Barry
    Cherry Cottage 2 Beechwood Lane
    Culcheth
    WA3 4HJ Warrington
    Lancashire
    Administrateur
    Cherry Cottage 2 Beechwood Lane
    Culcheth
    WA3 4HJ Warrington
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director13452550001
    MCCORKELL, Henry Nigel Pakenham
    The Hatch
    Gaunts Common
    BH21 4JB Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    The Hatch
    Gaunts Common
    BH21 4JB Wimborne
    Dorset
    EnglandEnglishCompany Director13447260001
    MILLSON, Stephen John
    24 Green Dragon Lane
    N21 2LD London
    Administrateur
    24 Green Dragon Lane
    N21 2LD London
    United KingdomBritishCompany Director72703870002
    PHILLIPS, Alan Jeffrey
    11 Augustine Way
    Charlton
    SP10 4EG Andover
    Hampshire
    Administrateur
    11 Augustine Way
    Charlton
    SP10 4EG Andover
    Hampshire
    BritishDirector12668990001
    PORTER, Michael James Robert
    Woodfield House
    Halifax Road Hipperholme
    HX3 8HD Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Woodfield House
    Halifax Road Hipperholme
    HX3 8HD Halifax
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant22243580001

    COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 juil. 2010
    Livré le 28 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Financial Services Limited
    Transactions
    • 28 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 27 juil. 2006
    Livré le 08 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee and debenture
    Créé le 28 juin 1996
    Livré le 10 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and any of the other companies named therein (the group companies) to the chargee as agent and trustee for the beneficiaries (as defined) and/or any of the beneficiaries under or in connection with the facilities agreement and/or any other senior finance document
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 janv. 1996
    Livré le 05 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 12 août 1994
    Livré le 25 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Please see doc for further details,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC,
    Transactions
    • 25 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 06 mars 1989
    Livré le 15 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 24 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 févr. 1984
    Livré le 04 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Specific & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book & other debts stocks, shares of other securities. (See doc M14).
    Personnes ayant droit
    • Country Bank Limited
    Transactions
    • 04 mars 1984Enregistrement d'une charge
    • 24 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 08 oct. 1982
    Livré le 13 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over all book debts & other debts (see docm M13).. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 1982Enregistrement d'une charge

    COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 sept. 2011Administration started
    07 sept. 2012Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Robert Thomas
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Robert Harry Pick
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    practitioner
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0