P1 ATTRACTIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | P1 ATTRACTIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01284934 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe P1 ATTRACTIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de P1 ATTRACTIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour P1 ATTRACTIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 nov. 2016 | 8 pages | 4.68 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 8 pages | 4.71 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ à 55 Baker Street London W1U 7EU le 15 déc. 2015 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2015 | 9 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012 | 8 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Mark Leslau le 17 sept. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2010 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Sandra Louise Gumm le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy James Evans le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Mark Leslau le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Miss Sandra Louise Gumm le 01 oct. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2009 | 12 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de P1 ATTRACTIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUMM, Sandra Louise | Secrétaire | Baker Street W1U 7EU London 55 | Australian | 57113450003 | ||||||
| EVANS, Timothy James | Administrateur | Baker Street W1U 7EU London 55 | United Kingdom | British | 104934670002 | |||||
| GUMM, Sandra Louise | Administrateur | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | Australian | 57113450003 | |||||
| LESLAU, Nicholas Mark | Administrateur | Baker Street W1U 7EU London 55 | United Kingdom | British | 6815470021 | |||||
| AUSTIN, Terence Nigel | Secrétaire | 73 Balmoral SL6 6SX Maidenhead Berkshire | British | 49056190001 | ||||||
| BURROWS, Peter Anthony | Secrétaire | Tregaron 44 Highland Road HP7 9AY Amersham Buckinghamshire | British | 10051840001 | ||||||
| COOTE, Sarah | Secrétaire | 14 Byron Road Hutton CM13 2RU Brentwood Essex | British | 71252790001 | ||||||
| LESTER, Frances Joan | Secrétaire | 7 Beult Meadow Cage Lane Smarden TN27 8PZ Ashford Kent | British | 63327910001 | ||||||
| TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||
| BARRATT, Raymond | Administrateur | Ivy Cottage Freehay Road ST10 1TR Mobberley Staffordshire | British | 10051870002 | ||||||
| BRITTON, Jill | Administrateur | Flat 6 77 Queens Gate South Kensington SW7 5JU London | British | 73984210001 | ||||||
| CARR, Andrew Christopher | Administrateur | 3 Market Close BH15 1NQ Poole Dorset | United Kingdom | British | 65490970003 | |||||
| CHITTICK, Gavin William | Administrateur | 19 Kitson Road SW13 9HJ Barnes London | England | British | 4524080002 | |||||
| DOUBLE, Michael Stockwell | Administrateur | Arden 37 Grovewood Close Chorleywood WD3 5PX Rickmansworth Hertfordshire | British | 14090870001 | ||||||
| EARLAM, Donald Glenn | Administrateur | Seaforth 26 Ganghill GU1 1XF Guildford Surrey | England | British | 96494270001 | |||||
| HERBERT, Michael | Administrateur | 14 Eaton Place SW1X 8AE London | British | 14090880001 | ||||||
| HOLLINGSWORTH, Andrew Roy | Administrateur | Dadbrook Barn Roundhill Court Oxford Road HP17 3TR Haddenham Buckinghamshire | British | 10051880004 | ||||||
| JOLLY, Michael Gordon | Administrateur | Flat 29 Harmont House 20 Harley Street W1G 9PH London | England | British | 110538760001 | |||||
| PHILLIPSON, Peter William | Administrateur | Woodhall Grange Woodhall Lane SL5 9QW Ascot Berkshire | England | British | 141295120001 | |||||
| ROGER, Robert | Administrateur | 15 Meadway KT10 9HG Esher Surrey | British | 46751430009 | ||||||
| STREETS, William Henry | Administrateur | 28 Causeway RH12 1HE Horsham West Sussex | British | 75769930001 | ||||||
| TANSLEY, Philip Andrew | Administrateur | 11 Montagu Square W1H 2LD London | British | 73984290001 | ||||||
| TAYLOR, Philip Boyd | Administrateur | 23 Castlebar Road W5 2DL London | British | 47270660002 | ||||||
| VARNEY, Nicholas John | Administrateur | 3 Market Close BH15 1NQ Poole Dorset | England | British | 50480360003 | |||||
| WELLS, Pauline Ruth | Administrateur | Fieldways Vicarage Road RH7 6HA Lingfield Surrey | British | 53790450001 |
P1 ATTRACTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage of shares | Créé le 12 mai 1999 Livré le 25 mai 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies and liabilities due or to become due by each obligor in clause 2.1 of the security trust deed (as defined) to the chargee in accordance with clause 12.2 of the funding loan agreement (as defined) | |
Brèves mentions All issued share capital of madame tussaud australia pty limited and all rights thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Pledge of shares | Créé le 12 mai 1999 Livré le 25 mai 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee all monies and liabilities due or to become due from each obligor in clause 2.1 of the security trust deed (as defined) to the chargee in accordance with clause 12.2 of the funding loan agreement (as defined) | |
Brèves mentions All shares and voting rights/dividends thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A security trust deed made between, inter alia, the borrowers (as defined) (which terms includes tussauds attractions limited (the "company")), the parent (as defined), holdings (as defined) and the issuer (as defined) issued by the company | Créé le 12 mai 1999 Livré le 25 mai 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti In favour of the chargee the moneys and liabilities which each obligor (as defined) covenants in clause 2.1 of the security trust deed to pay or discharge and all claims, demands and damages for breach of any such covenant, and references to the secured amounts includes references to any of them and following substitution of the issuer in accordance with clause 12.2 of the funding loan agreement also includes the issuer secured amounts (the "secured amounts") | |
Brèves mentions By way of legal mortgage f/h land on the south side of almshouse lane chessington t/n-SGL498994. F/h "burnt stub" or "burnt stubbs" chessington t/n-TGL155538. F/h land lying to the west of leatherhead road chessington t/n-SGL293017 (see for. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession (to a debenture and guarantee dated 12 october 1998) | Créé le 13 nov. 1998 Livré le 19 nov. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (the security agent) under each or any of the senior finance documents, the subordinated finance documents and the hedging documents | |
Brèves mentions The f/h property k/a warwick castle grounds and stables t/n WK251524. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
P1 ATTRACTIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0