P1 ATTRACTIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéP1 ATTRACTIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01284934
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de P1 ATTRACTIONS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe P1 ATTRACTIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de P1 ATTRACTIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TUSSAUDS ATTRACTIONS LIMITED08 avr. 199908 avr. 1999
    WARWICK CASTLE LIMITED31 déc. 197931 déc. 1979
    GREVILLE ENTERPRISES (WARWICK CASTLE) LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    BANIGORT LIMITED04 nov. 197604 nov. 1976

    Quels sont les derniers comptes de P1 ATTRACTIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour P1 ATTRACTIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 nov. 2016

    8 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ à 55 Baker Street London W1U 7EU le 15 déc. 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 nov. 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juil. 2015

    État du capital au 01 juil. 2015

    • Capital: GBP 2,500,201
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2015

    9 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juil. 2014

    État du capital au 16 juil. 2014

    • Capital: GBP 2,500,201
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 01 juil. 2013

    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Mark Leslau le 17 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Sandra Louise Gumm le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy James Evans le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Mark Leslau le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Miss Sandra Louise Gumm le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de P1 ATTRACTIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GUMM, Sandra Louise
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Secrétaire
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Australian57113450003
    EVANS, Timothy James
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish104934670002
    GUMM, Sandra Louise
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish6815470021
    AUSTIN, Terence Nigel
    73 Balmoral
    SL6 6SX Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    73 Balmoral
    SL6 6SX Maidenhead
    Berkshire
    British49056190001
    BURROWS, Peter Anthony
    Tregaron 44 Highland Road
    HP7 9AY Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Tregaron 44 Highland Road
    HP7 9AY Amersham
    Buckinghamshire
    British10051840001
    COOTE, Sarah
    14 Byron Road
    Hutton
    CM13 2RU Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    14 Byron Road
    Hutton
    CM13 2RU Brentwood
    Essex
    British71252790001
    LESTER, Frances Joan
    7 Beult Meadow
    Cage Lane Smarden
    TN27 8PZ Ashford
    Kent
    Secrétaire
    7 Beult Meadow
    Cage Lane Smarden
    TN27 8PZ Ashford
    Kent
    British63327910001
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secrétaire
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    BARRATT, Raymond
    Ivy Cottage Freehay Road
    ST10 1TR Mobberley
    Staffordshire
    Administrateur
    Ivy Cottage Freehay Road
    ST10 1TR Mobberley
    Staffordshire
    British10051870002
    BRITTON, Jill
    Flat 6 77 Queens Gate
    South Kensington
    SW7 5JU London
    Administrateur
    Flat 6 77 Queens Gate
    South Kensington
    SW7 5JU London
    British73984210001
    CARR, Andrew Christopher
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Administrateur
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    United KingdomBritish65490970003
    CHITTICK, Gavin William
    19 Kitson Road
    SW13 9HJ Barnes
    London
    Administrateur
    19 Kitson Road
    SW13 9HJ Barnes
    London
    EnglandBritish4524080002
    DOUBLE, Michael Stockwell
    Arden 37 Grovewood Close
    Chorleywood
    WD3 5PX Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Arden 37 Grovewood Close
    Chorleywood
    WD3 5PX Rickmansworth
    Hertfordshire
    British14090870001
    EARLAM, Donald Glenn
    Seaforth
    26 Ganghill
    GU1 1XF Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Seaforth
    26 Ganghill
    GU1 1XF Guildford
    Surrey
    EnglandBritish96494270001
    HERBERT, Michael
    14 Eaton Place
    SW1X 8AE London
    Administrateur
    14 Eaton Place
    SW1X 8AE London
    British14090880001
    HOLLINGSWORTH, Andrew Roy
    Dadbrook Barn Roundhill Court
    Oxford Road
    HP17 3TR Haddenham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Dadbrook Barn Roundhill Court
    Oxford Road
    HP17 3TR Haddenham
    Buckinghamshire
    British10051880004
    JOLLY, Michael Gordon
    Flat 29 Harmont House
    20 Harley Street
    W1G 9PH London
    Administrateur
    Flat 29 Harmont House
    20 Harley Street
    W1G 9PH London
    EnglandBritish110538760001
    PHILLIPSON, Peter William
    Woodhall Grange
    Woodhall Lane
    SL5 9QW Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Woodhall Grange
    Woodhall Lane
    SL5 9QW Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish141295120001
    ROGER, Robert
    15 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Administrateur
    15 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    British46751430009
    STREETS, William Henry
    28 Causeway
    RH12 1HE Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    28 Causeway
    RH12 1HE Horsham
    West Sussex
    British75769930001
    TANSLEY, Philip Andrew
    11 Montagu Square
    W1H 2LD London
    Administrateur
    11 Montagu Square
    W1H 2LD London
    British73984290001
    TAYLOR, Philip Boyd
    23 Castlebar Road
    W5 2DL London
    Administrateur
    23 Castlebar Road
    W5 2DL London
    British47270660002
    VARNEY, Nicholas John
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Administrateur
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    EnglandBritish50480360003
    WELLS, Pauline Ruth
    Fieldways
    Vicarage Road
    RH7 6HA Lingfield
    Surrey
    Administrateur
    Fieldways
    Vicarage Road
    RH7 6HA Lingfield
    Surrey
    British53790450001

    P1 ATTRACTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage of shares
    Créé le 12 mai 1999
    Livré le 25 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due by each obligor in clause 2.1 of the security trust deed (as defined) to the chargee in accordance with clause 12.2 of the funding loan agreement (as defined)
    Brèves mentions
    All issued share capital of madame tussaud australia pty limited and all rights thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trustee Company Limited,as Security Trustee
    Transactions
    • 25 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge of shares
    Créé le 12 mai 1999
    Livré le 25 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee all monies and liabilities due or to become due from each obligor in clause 2.1 of the security trust deed (as defined) to the chargee in accordance with clause 12.2 of the funding loan agreement (as defined)
    Brèves mentions
    All shares and voting rights/dividends thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trustee Company Limited,the Security Trustee
    Transactions
    • 25 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A security trust deed made between, inter alia, the borrowers (as defined) (which terms includes tussauds attractions limited (the "company")), the parent (as defined), holdings (as defined) and the issuer (as defined) issued by the company
    Créé le 12 mai 1999
    Livré le 25 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee the moneys and liabilities which each obligor (as defined) covenants in clause 2.1 of the security trust deed to pay or discharge and all claims, demands and damages for breach of any such covenant, and references to the secured amounts includes references to any of them and following substitution of the issuer in accordance with clause 12.2 of the funding loan agreement also includes the issuer secured amounts (the "secured amounts")
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h land on the south side of almshouse lane chessington t/n-SGL498994. F/h "burnt stub" or "burnt stubbs" chessington t/n-TGL155538. F/h land lying to the west of leatherhead road chessington t/n-SGL293017 (see for. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trustee Company Limited (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 25 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession (to a debenture and guarantee dated 12 october 1998)
    Créé le 13 nov. 1998
    Livré le 19 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (the security agent) under each or any of the senior finance documents, the subordinated finance documents and the hedging documents
    Brèves mentions
    The f/h property k/a warwick castle grounds and stables t/n WK251524. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trust Company (The "Security Agent")
    Transactions
    • 19 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    P1 ATTRACTIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 févr. 2017Dissolved on
    30 nov. 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0