COYLE HAMILTON INSURANCE BROKERS LIMITED

COYLE HAMILTON INSURANCE BROKERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOYLE HAMILTON INSURANCE BROKERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01285463
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COYLE HAMILTON INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe COYLE HAMILTON INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COYLE HAMILTON INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RICHARDSON HOSKEN LIMITED11 juil. 198411 juil. 1984
    RICHARDSON HICK & PARTNERS (U.K.) LIMITED31 déc. 198131 déc. 1981
    RICHARDSON HICK & PARTNERS LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    RACKSHAW INSURANCE BROKERS LIMITED08 nov. 197608 nov. 1976

    Quels sont les derniers comptes de COYLE HAMILTON INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour COYLE HAMILTON INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de 51 Lime Street London EC3M 7DQ à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 19 oct. 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 25 sept. 2018

    LRESSP

    legacy

    3 pagesSH20

    État du capital au 20 sept. 2018

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    3 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium account. 19/09/2018
    RES13

    Nomination de Mrs Rosemary Hazel Hammond-West en tant qu'administrateur le 10 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Oliver Hew Wallinger Goodinge en tant que directeur le 28 juin 2018

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Oliver Hew Wallinger Goodinge le 11 juin 2018

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 01 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Oliver Hew Wallinger Goodinge le 09 juil. 2016

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 01 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Alistair Charles Peel en tant que secrétaire le 22 juil. 2016

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Nomination de Katherine Louise Clark en tant qu'administrateur le 29 janv. 2016

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Edward Wood en tant que directeur le 29 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 sept. 2015

    État du capital au 09 sept. 2015

    • Capital: GBP 332,742
    SH01

    Deuxième dépôt de AP03 précédemment soumis à Companies House

    5 pagesRP04
    Annotations
    DateAnnotation
    08 sept. 2015Clarification Second filing AP03 for Alistair Peel

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de COYLE HAMILTON INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLARK, Katherine Louise
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritishAccountant205416970001
    HAMMOND-WEST, Rosemary Hazel
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritishCompany Director205417960001
    WILLIS CORPORATE DIRECTOR SERVICES LIMITED
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    Administrateur
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5059095
    104850230002
    ALLEN, John William
    12 Rosebury Vale
    HA4 6AQ Ruislip
    Middlesex
    Secrétaire
    12 Rosebury Vale
    HA4 6AQ Ruislip
    Middlesex
    BritishAccountant14248170001
    BRYANT, Shaun Kevin
    22 Searle Way
    Eight Ash Green
    CO6 3QS Colchester
    Essex
    Secrétaire
    22 Searle Way
    Eight Ash Green
    CO6 3QS Colchester
    Essex
    BritishChartered Secretary38944420002
    PEEL, Alistair Charles
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    Secrétaire
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    171856760001
    SEOMORE, Paul Bernard
    5 Farm View
    SS6 9PT Rayleigh
    Essex
    Secrétaire
    5 Farm View
    SS6 9PT Rayleigh
    Essex
    British15086520001
    SHAH, Sanjay
    Ravenscroft Addington Drive
    N12 0PH London
    Secrétaire
    Ravenscroft Addington Drive
    N12 0PH London
    BritishChartered Accountant51656730001
    TYRRELL, Declan Joseph
    11 Stanley Road
    IG1 1RW Ilford
    Essex
    Secrétaire
    11 Stanley Road
    IG1 1RW Ilford
    Essex
    Irish64687520001
    WILLIS CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    England
    Secrétaire
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2923054
    154489200001
    ALLEN, John William
    12 Rosebury Vale
    HA4 6AQ Ruislip
    Middlesex
    Administrateur
    12 Rosebury Vale
    HA4 6AQ Ruislip
    Middlesex
    BritishAccountant14248170001
    BARCLAY, David Malcolm
    Tawny Lodge
    258 Main Road Gidea Park
    RM2 6NA Romford
    Essex
    Administrateur
    Tawny Lodge
    258 Main Road Gidea Park
    RM2 6NA Romford
    Essex
    EnglandBritishInsurance Broker36035570001
    BRACEY, Kenneth George Alexander
    41 Peace Road
    Stanway
    CO3 5HL Colchester
    Essex
    Administrateur
    41 Peace Road
    Stanway
    CO3 5HL Colchester
    Essex
    BritishInsurance Broker31469800001
    BRANCH, Brian Leonard
    Red Tiles Ferry Road
    North Fambridge
    CM3 6LS Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Red Tiles Ferry Road
    North Fambridge
    CM3 6LS Chelmsford
    Essex
    BritishInsurance Broker31469810001
    BROSNAN, Ronald Arthur
    7 Tyrells Close
    CM2 6BT Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    7 Tyrells Close
    CM2 6BT Chelmsford
    Essex
    BritishInsurance Broker72003950001
    BRYANT, Shaun Kevin
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    England
    Administrateur
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    England
    United KingdomBritishChartered Secretary38944420002
    FEARON, Ronan Joseph
    Carrisbrook
    Knocksinna
    18 Foxrock
    Dublin 8
    Ireland
    Administrateur
    Carrisbrook
    Knocksinna
    18 Foxrock
    Dublin 8
    Ireland
    IrishAccountant23307630001
    GOODINGE, Oliver Hew Wallinger
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    Administrateur
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    United KingdomBritishLegal Counsel165971630003
    GOVERNEY, Hugh Declan
    Dunmore
    Palmerston Road
    Dublin 6
    Ireland
    Administrateur
    Dunmore
    Palmerston Road
    Dublin 6
    Ireland
    IrishInsurance Broker40191060001
    GRAHAM, Gerard Charles
    31 Exeter Court
    Maple Road
    KT6 4AX Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    31 Exeter Court
    Maple Road
    KT6 4AX Surbiton
    Surrey
    BritishInsurance Broker66647070001
    GRIBBEN, Allan Crawford Adamson
    29 Vogans Mill
    Mill Street
    SE1 2BZ London
    Administrateur
    29 Vogans Mill
    Mill Street
    SE1 2BZ London
    BritishInsurance Broker14914430006
    GRIFFITHS, Stephen Richard
    57a Norsey Street
    CM11 1BM Billercay
    Essex
    Administrateur
    57a Norsey Street
    CM11 1BM Billercay
    Essex
    BritishInsurance Broker114752870001
    HAYES, Malcolm James
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    Administrateur
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    United KingdomBritishInsurance Broker64732940002
    JOHNSTON, Sherman Lewis
    Badgers
    Chelmsford Road
    CM3 6PJ Purleigh
    Essex
    Administrateur
    Badgers
    Chelmsford Road
    CM3 6PJ Purleigh
    Essex
    BritishInsurance Broker15086540001
    KILLINGTON, Keith Charles
    De Efteling
    CM13 2AD Brentwood
    Essex
    Administrateur
    De Efteling
    CM13 2AD Brentwood
    Essex
    BritishInsurance Broker15086570001
    LENNON, Declan Laurence
    The Hut
    Thormanby Road
    IRISH Howth
    Co Dublin
    Ireland
    Administrateur
    The Hut
    Thormanby Road
    IRISH Howth
    Co Dublin
    Ireland
    IrishInsurance Broker23307650001
    LEWIS, Ivor Andrew Ogilvie Charles
    5a Rosary Gardens
    SW7 4NN London
    Administrateur
    5a Rosary Gardens
    SW7 4NN London
    BritishInsurance Broker42928960002
    MCNALLY, Robert
    38 Barnaby Mill
    IRISH Greystones
    Wicklow
    Ireland
    Administrateur
    38 Barnaby Mill
    IRISH Greystones
    Wicklow
    Ireland
    IrishAccountant94928110001
    MITCHELL, Allan John
    Tydings
    Esplanade West
    CM3 7AW Maylandsea
    Essex
    Administrateur
    Tydings
    Esplanade West
    CM3 7AW Maylandsea
    Essex
    BritishInsurance Broker47455510004
    MORGAN, Terry Ronald
    127 Flemming Crescent
    SS9 4HT Leigh On Sea
    Essex
    Administrateur
    127 Flemming Crescent
    SS9 4HT Leigh On Sea
    Essex
    BritishInsurance Broker31469840001
    O'MAHONEY, James Eugene
    80 Mount Anville Park
    Mount Anville Raod
    Dublin 14
    Ireland
    Administrateur
    80 Mount Anville Park
    Mount Anville Raod
    Dublin 14
    Ireland
    IrishInsurance Broker56086420001
    PLANT, Stephen Richard
    229 Greys Road Greys Hill
    RG9 1SJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    229 Greys Road Greys Hill
    RG9 1SJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishInsurance Broker46099610001
    RICHARDSON, Sidney George
    Flat 8 Clune Court
    Shenfield
    CM15 8NQ Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Flat 8 Clune Court
    Shenfield
    CM15 8NQ Brentwood
    Essex
    BritishInsurance Broker10701610001
    SEOMORE, Paul Bernard
    5 Farm View
    SS6 9PT Rayleigh
    Essex
    Administrateur
    5 Farm View
    SS6 9PT Rayleigh
    Essex
    BritishAccountant15086520001
    SHANNON, William Martin
    20 Whitebeam Avenue
    Clonskeagh
    Dublin
    14
    Ireland
    Administrateur
    20 Whitebeam Avenue
    Clonskeagh
    Dublin
    14
    Ireland
    BritishAccountant40191120001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COYLE HAMILTON INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Richardson Hosken Holdings Limited
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    England
    06 avr. 2016
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement01536539
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    COYLE HAMILTON INSURANCE BROKERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of variation (made in addition to and modifying the security and trust deed dated 23RD october 1989 (the "principal deed")
    Créé le 19 nov. 1999
    Livré le 26 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment of all costs charges expenses and other liabilities properly incurred by the chargee its delegates or agents or any receiver appointed under the security and trust deed in or about the exercise of the powers contained in the security and trust deed (as modified) or otherwise in relation thereto including all remuneration payable to any such receiver and the payment of all debts and obligations for the time being due owing or incurred whether actually or contingently by the company in respect of insurance transactions
    Brèves mentions
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets of the company (and all assets which would be approved). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's (A Statutory Corporation) (as Trustee for the Creditors for the Time Being of Thecompany in Respect of Insurance Transactions
    Transactions
    • 26 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental trust deed
    Créé le 24 févr. 1994
    Livré le 04 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any loan or overdraft facility
    Brèves mentions
    Floating charge over loans and overdraft provided in respect of insurance transactions.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 04 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Trust deed
    Créé le 23 oct. 1989
    Livré le 08 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under this deed
    Brèves mentions
    Floating charge over all the brokers insurance transaction assets.
    Personnes ayant droit
    • The Society of Lloyds
    Transactions
    • 08 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 22 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed
    Créé le 15 sept. 1983
    Livré le 05 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All the companys right title & interest in the monies standing to the credit of the companys 'c' account & monies & investments at the date of the trust deed (for full details see doc M57).
    Personnes ayant droit
    • The Corporation of Lloyd's
    Transactions
    • 05 oct. 1983Enregistrement d'une charge
    • 20 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    COYLE HAMILTON INSURANCE BROKERS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    25 sept. 2018Commencement of winding up
    17 déc. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0