DELANEY LUND KNOX WARREN AND PARTNERS LIMITED

DELANEY LUND KNOX WARREN AND PARTNERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDELANEY LUND KNOX WARREN AND PARTNERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01286253
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DELANEY LUND KNOX WARREN AND PARTNERS LIMITED ?

    • Agences de publicité (73110) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DELANEY LUND KNOX WARREN AND PARTNERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Acre House 11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DELANEY LUND KNOX WARREN AND PARTNERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DELANEY FLETCHER BOZELL LIMITED 10 août 199510 août 1995
    DELANEY FLETCHER SLAYMAKER DELANEY BOZELL LIMITED01 juin 199001 juin 1990
    SLAYMAKER COWLEY WHITE19 mai 198819 mai 1988
    SLAYMAKER COWLEY WHITE16 févr. 198716 févr. 1987
    BUTLER DENNIS GARLAND KENYON & ECKHARDT LIMITED06 mars 198506 mars 1985
    BUTLER, DENNIS, GARLAND & PARTNERS LIMITED31 déc. 198031 déc. 1980
    BUTLER, DENNIS & GARLAND LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    STAVGLOW LIMITED12 nov. 197612 nov. 1976

    Quels sont les derniers comptes de DELANEY LUND KNOX WARREN AND PARTNERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour DELANEY LUND KNOX WARREN AND PARTNERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Deuxième dépôt d'un bilan du capital suite à une émission d'actions au 04 déc. 2017

    • Capital: GBP 2,357,268.00
    7 pagesRP04SH01

    Changement d'adresse du siège social de C-Space 37-45 City Road London EC1Y 1AT England à Acre House 11-15 William Road London NW1 3ER le 05 janv. 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 07 déc. 2017

    LRESSP

    État du capital après une attribution d'actions au 04 déc. 2017

    • Capital: GBP 2,660,268
    4 pagesSH01
    Annotations
    DateAnnotation
    07 févr. 2018Clarification A second filed SH01 was registered on 07/02/2018.

    Nomination de Mr Andrew Cooper Page en tant qu'administrateur le 04 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Pool en tant que directeur le 04 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charles Snow en tant que directeur le 04 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Thomas Francis Needham Knox en tant que directeur le 04 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2016

    15 pagesAA

    legacy

    53 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 24 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2015

    17 pagesAA

    legacy

    55 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 24 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur James Pool le 16 juin 2016

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Richard Warren en tant que directeur le 24 mai 2016

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 60 Sloane Avenue London SW3 3XB à C-Space 37-45 City Road London EC1Y 1AT le 10 déc. 2015

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de DELANEY LUND KNOX WARREN AND PARTNERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BEAN, Louise
    Newbury Close
    DA2 6AQ Dartford
    18
    England
    Secrétaire
    Newbury Close
    DA2 6AQ Dartford
    18
    England
    British158540910001
    PAGE, Andrew Cooper
    William Road
    NW1 3ER London
    Acre House 11-15
    Administrateur
    William Road
    NW1 3ER London
    Acre House 11-15
    EnglandBritishAccountant240246840001
    FEI, Peter Benedetto
    29 Airedale Avenue
    W4 2NW London
    Secrétaire
    29 Airedale Avenue
    W4 2NW London
    BritishChartered Accountant44197080001
    GRIFFITHS, Matthew Lloyd
    27 Barrow Green Road
    RH8 0NJ Oxted
    Surrey
    Secrétaire
    27 Barrow Green Road
    RH8 0NJ Oxted
    Surrey
    BritishFinance Director10140500002
    PAGE, John Ross
    Huntsdean Morton Road
    Horsell
    GU21 4TN Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Huntsdean Morton Road
    Horsell
    GU21 4TN Woking
    Surrey
    British5106160001
    CITY GROUP PLC
    City Road
    EC1Y 2AG London
    30
    England
    Secrétaire
    City Road
    EC1Y 2AG London
    30
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1443918
    35794270004
    ADAMSON, David
    Gibson Lane
    Haddenham
    HP17 8AP Aylesbury
    21
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Gibson Lane
    Haddenham
    HP17 8AP Aylesbury
    21
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishCopywriter152153570001
    ANDREWS, Simon
    16 Albion Drive
    Albion Square
    E8 4ET London
    Administrateur
    16 Albion Drive
    Albion Square
    E8 4ET London
    BritishManaging Director E-Brands34236550001
    ANSELL, Martin
    8 Ghyll Side Road
    Northiam
    TN31 6QG Rye
    East Sussex
    Administrateur
    8 Ghyll Side Road
    Northiam
    TN31 6QG Rye
    East Sussex
    EnglandBritishCreative Services Group Head88225820001
    ASLAM, Ziad
    192 Leigh Hunt Drive
    N14 6DQ Southgate
    London
    Administrateur
    192 Leigh Hunt Drive
    N14 6DQ Southgate
    London
    EnglandBritishDeputy Finance Director96977760001
    BALDWIN, John
    106 Celeborn Street
    South Woodham Ferrers
    CM3 7AF Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    106 Celeborn Street
    South Woodham Ferrers
    CM3 7AF Chelmsford
    Essex
    BritishDirector14181270001
    BALDWIN, Richard
    Regency Close
    CM2 6DU Chelmsford
    2
    Essex
    Administrateur
    Regency Close
    CM2 6DU Chelmsford
    2
    Essex
    EnglandBritishJoint Managing Director138929890001
    BERMAN, Scott
    28 Lakeland Close
    IG7 4QU Chigwell
    Essex
    Administrateur
    28 Lakeland Close
    IG7 4QU Chigwell
    Essex
    BritishCreative Services Director79333400001
    BETTS, Gary William
    5 Fairfax Road
    Chiswick
    W4 1EN London
    Administrateur
    5 Fairfax Road
    Chiswick
    W4 1EN London
    BritishCreative Director54987610001
    BIGGINS, Paul
    12 St Dunstans Road
    W6 8RB London
    Administrateur
    12 St Dunstans Road
    W6 8RB London
    BritishChief Executive Dialogue101990460001
    BINNS, Somon
    Flat03 6 Campden Hill Gardens
    Kensington
    W8 7AY London
    Administrateur
    Flat03 6 Campden Hill Gardens
    Kensington
    W8 7AY London
    BritishAccount Director69992060001
    BLAZYE, Christopher John, Dr
    84 Chestnut Grove
    SW12 8JJ London
    Administrateur
    84 Chestnut Grove
    SW12 8JJ London
    BritishStrategic Planning50229110001
    BOSWELL, Stephen
    43 Balfour Road
    N5 2HD London
    Administrateur
    43 Balfour Road
    N5 2HD London
    EnglandBritishCreative Director94919850002
    BRIEN, Barrie Christopher
    24 Stokenchurch Street
    SW6 3TR London
    Administrateur
    24 Stokenchurch Street
    SW6 3TR London
    EnglandBritishDirector68731570002
    BROWN, Ronnie
    52 Fellows Road
    NW3 3LJ London
    Administrateur
    52 Fellows Road
    NW3 3LJ London
    BritishArt Director75167780001
    CHAMBERLAIN, Alexander
    Briarwood Road
    SW4 9PX London
    42
    Administrateur
    Briarwood Road
    SW4 9PX London
    42
    EnglandBritishNew Business Director113346010003
    CHAMBERLAIN, Laura Mary
    Grandison Road
    SW11 6LS London
    37
    Administrateur
    Grandison Road
    SW11 6LS London
    37
    United KingdomBritishBoard Account Director128755150001
    CHATTWELL, Helen
    1 Alwyne Road
    N1 2HH London
    Administrateur
    1 Alwyne Road
    N1 2HH London
    BritishDirector Of Tv69563630001
    COOK, Niki
    11 The Green
    HP22 4AR Quainton
    Magpie Cottage
    Administrateur
    11 The Green
    HP22 4AR Quainton
    Magpie Cottage
    EnglandBritishDeputy Managing Director128803160002
    COOPER, Madeleine Elizabeth
    Browne Close
    GU22 8LJ Old Woking
    2
    Surrey
    Administrateur
    Browne Close
    GU22 8LJ Old Woking
    2
    Surrey
    EnglandBritishBoard Accountant Director193866360001
    COWAN, Paul
    23a Abbeville Road
    SW4 9LA London
    Administrateur
    23a Abbeville Road
    SW4 9LA London
    BritishClient Service Director51591570002
    CULLING, Jonathan
    Broughton Road
    W13 8QW West Ealing London
    21
    Administrateur
    Broughton Road
    W13 8QW West Ealing London
    21
    EnglandBritishInformation Architect132195270001
    DELANEY, Barry John Samuel
    124 B Hamilton Terrace
    NW8 9UT London
    Administrateur
    124 B Hamilton Terrace
    NW8 9UT London
    EnglandBritishCreative Director31229020002
    DELANEY, Greg
    31 Spencer Road
    Chiswick
    W4 3SS London
    Administrateur
    31 Spencer Road
    Chiswick
    W4 3SS London
    EnglandBritishChairman28798800001
    DRYSDALE, Stephen, Mr.
    Stockland Green Road
    TN3 0TY Tunbridge Wells
    1
    Kent
    Administrateur
    Stockland Green Road
    TN3 0TY Tunbridge Wells
    1
    Kent
    EnglandBritishCreative Director155728080001
    ELGIE, Donald Hunter
    Holly Cottage
    Fairmile Park Road
    KT11 2PL Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Holly Cottage
    Fairmile Park Road
    KT11 2PL Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector6661980002
    ELLIOT, Jamie
    48 Amott Road
    SE15 4JD London
    Administrateur
    48 Amott Road
    SE15 4JD London
    EnglandBritishBoard Account Director113345880001
    ELSOM, Jon
    5 Calverdale Road
    Clapham
    SW4 9LY London
    Administrateur
    5 Calverdale Road
    Clapham
    SW4 9LY London
    EnglandBritishCopywriter75167630002
    FEI, Peter Benedetto
    29 Airedale Avenue
    W4 2NW London
    Administrateur
    29 Airedale Avenue
    W4 2NW London
    EnglandBritishChartered Accountant44197080001
    FLETCHER, Winston
    15 Montpelier Square
    SW7 1JU London
    Administrateur
    15 Montpelier Square
    SW7 1JU London
    United KingdomBritishNon Executive Director28798780002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DELANEY LUND KNOX WARREN AND PARTNERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Lowe & Partners Limited
    City Road
    EC1Y 1AT London
    C-Space, 37-45
    England
    06 avr. 2016
    City Road
    EC1Y 1AT London
    C-Space, 37-45
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement7258457
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    DELANEY LUND KNOX WARREN AND PARTNERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 20 avr. 2005
    Livré le 26 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it and any amount to be paid to the company on cancellation. Life assured matthew griffiths policy means the life assurance policy over the life of tom knox with scottish equitable policy number L0199923462DT.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 20 avr. 2005
    Livré le 26 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it and any amount to be paid to the company on cancellation. Life assured tom knox policy means the life assurance policy over the life of tom knox with scottish equitable policy number L0193223462DZ.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 20 avr. 2005
    Livré le 26 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it and any amount to be paid to the company on cancellation. Life assured richard warren policy means the life assurance policy over the life of richard warren with scottish equitable policy number L0191523462DA.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 20 avr. 2005
    Livré le 26 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it and any amount to be paid to the company on cancellation. Life assured mark lund policy means the life assurance policy over the life of mark lund with scottish equitable policy number L0193823462DE.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 20 avr. 2005
    Livré le 26 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it and any amount to be paid to the company on cancellation. Life assured gary betts policy means the life assurance policy over the life of gary betts with scottish equitable policy number L0194323462DQ.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 20 avr. 2005
    Livré le 26 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it and any amount to be paid to the company on cancellation. Life assured greg delaney policy means the life assurance policy over the life of greg delaney with scottish equitable policy number L0194623462DF.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 28 november 2001
    Créé le 09 mars 2005
    Livré le 18 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 avr. 1988
    Livré le 17 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or its members in respect of the "secured liabilities" (as defined in the debenture)
    Brèves mentions
    By way of a fixed charge all present & future book & other debts. (For full details see form 395 ref: 515C).
    Personnes ayant droit
    • Independent Television Association Limited
    Transactions
    • 17 mai 1988Enregistrement d'une charge
    • 08 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 1988
    Livré le 15 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 02 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Confirmatory charge.
    Créé le 29 juil. 1981
    Livré le 14 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplement to a mortgage debenture dated 16/6/77.
    Brèves mentions
    The property and assets of the company as charged by the mortgage debenture rferred to.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 1981Enregistrement d'une charge
    • 02 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 juin 1977
    Livré le 30 juin 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all the company's estate or interest in all freehold and leasehold properties. All stocks shares and other securities, all book debts and other debts assignment of goodwill. Floating charge over all other property and assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1977Enregistrement d'une charge
    • 08 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    DELANEY LUND KNOX WARREN AND PARTNERS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 déc. 2017Commencement of winding up
    10 avr. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0