PARADOR TRAVEL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARADOR TRAVEL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01290266
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARADOR TRAVEL LIMITED ?

    • Activités des agences de voyages (79110) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PARADOR TRAVEL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PARADOR TRAVEL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRACECASTLE LIMITED13 déc. 197613 déc. 1976

    Quels sont les derniers comptes de PARADOR TRAVEL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour PARADOR TRAVEL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Application for striking off 13/05/2013
    RES13

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A28DLRMJ

    État du capital au 22 mars 2013

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19
    A24JHEB7

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    S24KOLFM

    legacy

    1 pagesSH20
    S24KOLFU

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Michelle Haddon en tant que directeur le 14 août 2012

    1 pagesTM01
    X1G8U9DL

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011

    3 pagesAA
    A18STKPL

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    X190TPJN

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Joyce Walter le 09 mai 2012

    2 pagesCH01
    X18Y4TP7

    Cessation de la nomination de Paul Robert Tymms en tant que directeur le 30 mars 2012

    1 pagesTM01
    X16FVVJM

    Nomination de Michelle Haddon en tant qu'administrateur le 27 mars 2012

    2 pagesAP01
    X165PPI8

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    XR52JUHP

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    3 pagesAA
    ABBBTRJA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Robert Tymms le 21 juil. 2010

    2 pagesCH01
    XNCGJLWC

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Joyce Walter le 24 juin 2010

    2 pagesCH01
    XY1RRL87

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Joyce Walter le 24 juin 2010

    1 pagesCH03
    XY1RPL85

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Andrew Lloyd John le 21 juin 2010

    2 pagesCH01
    XVHJAL2P

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Andrew Lloyd John le 17 juin 2010

    2 pagesCH01
    XJQIIKYO

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    XH2D1KAO

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009

    3 pagesAA
    ANWVOISM

    Comptes établis au 30 sept. 2008

    3 pagesAA
    AZEMKB7B

    legacy

    4 pages363a
    XCTKO9SB

    Qui sont les dirigeants de PARADOR TRAVEL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WALTER, Joyce
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Secrétaire
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    BritishChartered Secretary76169540002
    JOHN, Andrew Lloyd
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritishLawyer75467790004
    WALTER, Joyce
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritishChartered Secretary76169540003
    LEVINGER, Peter David
    18 Highgate Close
    N6 4SD London
    Secrétaire
    18 Highgate Close
    N6 4SD London
    British24808690002
    STARLING, Rebecca Jean Godwin
    11 Rossdale Road
    Putney
    SW15 1AD London
    Secrétaire
    11 Rossdale Road
    Putney
    SW15 1AD London
    British45381850004
    YEATMAN, Brenda
    The Haybarn
    Romsey Road Whiteparish
    SP5 2SA Salisbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    The Haybarn
    Romsey Road Whiteparish
    SP5 2SA Salisbury
    Wiltshire
    British27721380002
    CROSTHWAITE EYRE, Antony Francis John
    The Lodge
    OX7 4HX Little Tew
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Lodge
    OX7 4HX Little Tew
    Oxfordshire
    BritishCompany Director18468050003
    CROSTHWAITE EYRE, Mark Edward
    16 Pursers Cross Road
    SW6 4QX London
    Administrateur
    16 Pursers Cross Road
    SW6 4QX London
    BritishSales Executive18468030001
    CROSTHWAITE EYRE, Oliver Nicholas
    Warrens
    Bramshaw
    SO43 7JH Lyndhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Warrens
    Bramshaw
    SO43 7JH Lyndhurst
    Hampshire
    EnglandBritishDirector19429260002
    CROSTHWAITE-EYRE, John Giles
    Toyd Cottage
    Rockbourne
    SP6 3PF Fordingbridge
    Hampshire
    Administrateur
    Toyd Cottage
    Rockbourne
    SP6 3PF Fordingbridge
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor48752360001
    GIFFORD, Mark Anthony
    1 Carylls Meadow
    RH13 8HW West Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    1 Carylls Meadow
    RH13 8HW West Grinstead
    West Sussex
    BritishFinance Director87902570001
    HADDON, Michelle
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant168129060001
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector109591300001
    JONES, Derek
    Brook Lane
    CV37 8UA Newbold-On-Stour
    Stourbank
    Warwickshire
    Administrateur
    Brook Lane
    CV37 8UA Newbold-On-Stour
    Stourbank
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director169115000001
    LEVINGER, Peter David
    18 Highgate Close
    N6 4SD London
    Administrateur
    18 Highgate Close
    N6 4SD London
    EnglandBritishSolicitor24808690002
    LONG, Peter James
    5 Broadwater Down
    TN2 5NJ Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    5 Broadwater Down
    TN2 5NJ Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishDirector141460300001
    LONGMAN, Nicholas Winston
    Salisbury Road
    RH13 0AL Horsham
    Roseland
    West Sussex
    Administrateur
    Salisbury Road
    RH13 0AL Horsham
    Roseland
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director133313580001
    POWELL, Cheryl Frances
    5 Plymouth Drive
    B45 8JB Barnt Green
    Birmingham
    Administrateur
    5 Plymouth Drive
    B45 8JB Barnt Green
    Birmingham
    BritishCommercial Director126672180001
    REILLY, Gerald
    The Spinney Brooks Drive
    Hale Barns
    WA15 8TR Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    The Spinney Brooks Drive
    Hale Barns
    WA15 8TR Altrincham
    Cheshire
    BritishMd-Travel Choice62864580001
    SHANKS, Peter David Kenneth
    4 Orchard Lea Close
    Pyrford Woods Pyrford
    GU22 8QW Woking
    Surrey
    Administrateur
    4 Orchard Lea Close
    Pyrford Woods Pyrford
    GU22 8QW Woking
    Surrey
    BritishManaging Director65659900001
    SWINSON, Margaret Anne
    13 Brook Lane
    RH16 1SF Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    13 Brook Lane
    RH16 1SF Haywards Heath
    West Sussex
    BritishAccountant88953530001
    THOMAS, Hywel David
    Orchard House
    102 Church Road
    KT4 7RZ Worcester Park
    Surrey
    Administrateur
    Orchard House
    102 Church Road
    KT4 7RZ Worcester Park
    Surrey
    EnglandBritishAccountant59274640002
    TYMMS, Paul Robert
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    BritishCompany Director121957630001
    WEINER, Alan David
    2 Loudwater House
    Troutstream Way
    WD3 4HN Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Loudwater House
    Troutstream Way
    WD3 4HN Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant38628180001
    WHEATLEY, David
    Spring Farm Cottage
    TN22 3SA Fletching
    East Sussex
    Administrateur
    Spring Farm Cottage
    TN22 3SA Fletching
    East Sussex
    BritishFinance Director94438480001
    WIMBLETON, John
    Damside House
    Lower Millbank Road Mill Bank
    HX6 3EQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Administrateur
    Damside House
    Lower Millbank Road Mill Bank
    HX6 3EQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    BritishDirector78247680002

    PARADOR TRAVEL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over credit balances
    Créé le 21 mars 1996
    Livré le 09 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee in favour of association of british travel agents for £40,500
    Brèves mentions
    The sum of £40,500 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 16608070.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 14 mars 1995
    Livré le 17 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee in favour of the association of british travel agents limited for £40,000
    Brèves mentions
    The sum of £40,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 16608070. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 21 mars 1994
    Livré le 29 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee in favour of the association of british travel agents for £28000
    Brèves mentions
    The sum of £28000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account no: 16608070 and designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 20 déc. 1993
    Livré le 07 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond dated 16TH march 1993 in favour of the association of british travel agents for £20,000 and in relation to a bond dated 7TH october 1993 in favour of the association of british travel agents for £9,000
    Brèves mentions
    £29,000 with interest held by the bank on account no.16608070 And earmarked or designated to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 06 mars 1992
    Livré le 17 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a terminable indemnity liability re bond given by national westminster bank PLC in favour of the association of british travel agents limited for £20,000 commencing 21/3/91 and terminating 30/9/93.
    Brèves mentions
    The sum oof £20,000 tog. With interest accrued now or to be held by the bank on an account no. 7492847.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on credit balance
    Créé le 19 mars 1991
    Livré le 25 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of the association of british travel agent limited for £20,000 dated 1/4/91
    Brèves mentions
    The sum of £20,000 with interest accrued held by the bend an account no 7492847 earmarked the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 16 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balance
    Créé le 28 avr. 1987
    Livré le 08 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond to the association of british travel agents for £7,500 dated 1-2-1987.
    Brèves mentions
    The sum of £7,500 together with interest accrued held by the bank on an a/c in the name of the bank and earmarked re the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 16 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over contract
    Créé le 03 nov. 1981
    Livré le 05 nov. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that sum of £5,000 or thereabouts held whether in the name of the bank or its nominees or otherwise to the credit of the assignor by coults finance co and deposit account under account number 213381 (for full details see doc M28).
    Personnes ayant droit
    • Coults & Company
    Transactions
    • 05 nov. 1981Enregistrement d'une charge
    • 16 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over contract
    Créé le 16 sept. 1981
    Livré le 18 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that sums of £11,000 or thereabouts held whether in the name of the bank or its nominees or otherwise to the credit of the assignor by coults finance co. On or deposit account under account number 213381 (for full details see doc M27).
    Personnes ayant droit
    • Coults & Company
    Transactions
    • 18 sept. 1981Enregistrement d'une charge
    • 16 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0