GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES (UK) LTD

GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES (UK) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES (UK) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01297192
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES (UK) LTD ?

    • (7420) /
    • (7487) /

    Où se situe GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES (UK) LTD ?

    Adresse du siège social
    89 Bridge Road
    Oulton Broad
    NR32 3LN Lowestoft
    Suffolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES (UK) LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OCB GERMANISCHER LLOYD LIMITED27 oct. 199527 oct. 1995
    OFFSHORE CERTIFICATION BUREAU LIMITED31 déc. 197831 déc. 1978
    HALCROW, EWBANK & ASSOCIATES CERTIFICATION GROUP04 févr. 197704 févr. 1977

    Quels sont les derniers comptes de GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES (UK) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES (UK) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Holywell Park New Ashby Road Loughborough Leicestershire LE11 3GR le 26 avr. 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 11 avr. 2011

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Jane Davies en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 déc. 2010

    État du capital au 21 déc. 2010

    • Capital: GBP 180,374
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    7 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Qui sont les dirigeants de GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES (UK) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHRIEVE, Paul Francis
    Strachan
    AB31 6NL Banchory
    Brownscroft Cottage
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Strachan
    AB31 6NL Banchory
    Brownscroft Cottage
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish131261440001
    STODDART, Arthur William
    Pelham Road
    SW19 1NP London
    40
    Administrateur
    Pelham Road
    SW19 1NP London
    40
    EnglandBritish136580200001
    BUDGEN, Paul James
    1 Paygate Cottages
    Godstone Road
    RH8 9NG Oxted
    Surrey
    Secrétaire
    1 Paygate Cottages
    Godstone Road
    RH8 9NG Oxted
    Surrey
    British53219200001
    CLAXTON, Ronald Bruce
    The Lodge 123 London Road North
    Merstham
    RH1 3AL Redhill
    Surrey
    Secrétaire
    The Lodge 123 London Road North
    Merstham
    RH1 3AL Redhill
    Surrey
    British4931840001
    CLAXTON, Ronald Bruce
    The Lodge 123 London Road North
    Merstham
    RH1 3AL Redhill
    Surrey
    Secrétaire
    The Lodge 123 London Road North
    Merstham
    RH1 3AL Redhill
    Surrey
    British4931840001
    WATTS, Rowena
    The Cranny,
    Crossways
    SA73 1QX Little Honeyborough
    Pembrokeshire West Wales
    Secrétaire
    The Cranny,
    Crossways
    SA73 1QX Little Honeyborough
    Pembrokeshire West Wales
    British73423970002
    WATTS, Rowena
    11 Dacres Lodge
    51 Dacres Road
    SE23 2NL London
    Secrétaire
    11 Dacres Lodge
    51 Dacres Road
    SE23 2NL London
    British73423970001
    BOLTON, Christopher James
    Ruskins
    St Johns Road
    NR31 9JT Great Yarmouth
    Norfolk
    Administrateur
    Ruskins
    St Johns Road
    NR31 9JT Great Yarmouth
    Norfolk
    United KingdomBritish157310560001
    CLARK, Peter John
    24 Burcott Road
    CR8 4AA Purley
    Surrey
    Administrateur
    24 Burcott Road
    CR8 4AA Purley
    Surrey
    British20858900001
    CLAXTON, Ronald Bruce
    The Lodge 123 London Road North
    Merstham
    RH1 3AL Redhill
    Surrey
    Administrateur
    The Lodge 123 London Road North
    Merstham
    RH1 3AL Redhill
    Surrey
    British4931840001
    CORLETT, Brian James
    Thie-Y-Chleree
    Maughold Village
    Maughold
    Isle Of Man
    Administrateur
    Thie-Y-Chleree
    Maughold Village
    Maughold
    Isle Of Man
    British3329680001
    CRAWFORD, James
    36 Heather Avenue
    Bearsden
    G61 3JG Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    36 Heather Avenue
    Bearsden
    G61 3JG Glasgow
    Lanarkshire
    British853890001
    DAVIES, Jane
    1 Chestnut Close
    Sutton Bonnington
    LE12 5RJ Loughborough
    Willoughby Barn
    Leicestershire
    Administrateur
    1 Chestnut Close
    Sutton Bonnington
    LE12 5RJ Loughborough
    Willoughby Barn
    Leicestershire
    United KingdomBritish134407480001
    DAWSON, John Michael
    130 Ravensbourne Avenue
    BR2 0AX Bromley
    Kent
    Administrateur
    130 Ravensbourne Avenue
    BR2 0AX Bromley
    Kent
    British26030780001
    DAY, Renwick Jeffrey
    31 Rivercourt
    SE1 9PC Upper Ground
    London
    Administrateur
    31 Rivercourt
    SE1 9PC Upper Ground
    London
    American36831350001
    FINDLAY, Ian Scott
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British54138670001
    GJEDREM, Trond, Herr
    Albert Einstein Web 17 D 22846
    FOREIGN Norderstedt
    Hamburg
    Germany
    Administrateur
    Albert Einstein Web 17 D 22846
    FOREIGN Norderstedt
    Hamburg
    Germany
    Norwegian82775810001
    GRUND, Dietmar
    Bahnhofstr 52a
    D21218 Seevetal
    Germany
    Administrateur
    Bahnhofstr 52a
    D21218 Seevetal
    Germany
    German45086040001
    HETHERINGTON, William Gerald
    Bracken House Golf Club Drive
    KT2 7DF Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    Bracken House Golf Club Drive
    KT2 7DF Kingston Upon Thames
    Surrey
    British7607980001
    HETHERINGTON, William Gerald
    Bracken House Golf Club Drive
    KT2 7DF Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    Bracken House Golf Club Drive
    KT2 7DF Kingston Upon Thames
    Surrey
    British7607980001
    HINRICHSEN, Hans
    Thesdorfer Weg 59
    25469 Halstenbek
    Germany
    Administrateur
    Thesdorfer Weg 59
    25469 Halstenbek
    Germany
    German45085890001
    MORGAN, John David, Dr
    Osbourne Place
    AB25 2DD Aberdeen
    85
    Scotland
    United Kingdom
    Administrateur
    Osbourne Place
    AB25 2DD Aberdeen
    85
    Scotland
    United Kingdom
    British131886860001
    MURRAY, Morris James
    2 Peveril Avenue
    Burnside Rutherglen
    G73 4RD Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    2 Peveril Avenue
    Burnside Rutherglen
    G73 4RD Glasgow
    Strathclyde
    British17991640001
    REEVES, Ian William
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    Administrateur
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    British71881990001
    SANDBERG, Alexander Christer Edward
    16 Thames Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UY London
    Administrateur
    16 Thames Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UY London
    British69025380001
    SANDBERG, Alexander Christer Edward
    16 Thames Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UY London
    Administrateur
    16 Thames Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UY London
    British69025380001
    SANDBERG, Neil Christer Duncan
    Hurlingham Road
    SW6 3NJ London
    119
    Administrateur
    Hurlingham Road
    SW6 3NJ London
    119
    United KingdomBritish75959760002
    SMITH, Alan Ormand
    17 Foxley Close
    WA13 0BS Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    17 Foxley Close
    WA13 0BS Lymm
    Cheshire
    United KingdomBritish21338110002
    TRICKEY, John Charles Albert Edge
    6 Gainsborough Court
    College Road Dulwich
    SE21 7LT London
    Administrateur
    6 Gainsborough Court
    College Road Dulwich
    SE21 7LT London
    British16758110002
    WITTENBERG, Lutz Hugo Otto, Dipl Ing
    Espellohweg 44
    Hamburg
    FOREIGN 22607
    Germany
    Administrateur
    Espellohweg 44
    Hamburg
    FOREIGN 22607
    Germany
    German122129080001

    GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES (UK) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 07 mars 2002
    Livré le 27 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the rights of the company under a sale agreement between the company and technical indexes limited dated 19 october 2001 including without limitation the company's rights to receive the deferred consideration as defined in the sale agreement.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Germanischer Lloyd Ag
    Transactions
    • 27 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 juil. 1998
    Livré le 30 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Germanisher Lloyd Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 30 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES (UK) LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 mai 2012Dissolved on
    11 avr. 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew John Turner
    Lovewell Blake
    89 Bridge Road
    NR32 3LN Oulton Broad
    Lowestoft
    practitioner
    Lovewell Blake
    89 Bridge Road
    NR32 3LN Oulton Broad
    Lowestoft

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0