SHERIFF PLANT HIRE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSHERIFF PLANT HIRE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01297611
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SHERIFF PLANT HIRE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SHERIFF PLANT HIRE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    100 Cheapside
    EC2V 6DT London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SHERIFF PLANT HIRE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SHERIFF PLANT HIRE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SHERIFF PLANT HIRE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 févr. 2016

    État du capital au 15 févr. 2016

    • Capital: GBP 4,000,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O Ashtead Group Plc Kings House 36-37 King Street London EC2V 8BB à 100 Cheapside London EC2V 6DT le 23 sept. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 févr. 2015

    État du capital au 04 févr. 2015

    • Capital: GBP 4,000,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 févr. 2014

    État du capital au 14 févr. 2014

    • Capital: GBP 4,000,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2012

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Michael Richard Pratt en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stuart Robson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Eric Watkins le 14 févr. 2012

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stuart Ian Robson le 14 févr. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Eric Watkins le 28 août 2009

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2009

    8 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages353

    Qui sont les dirigeants de SHERIFF PLANT HIRE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WATKINS, Eric
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    Secrétaire
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    BritishCompany Secretary Legal Counse100734790001
    PRATT, Michael Richard
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    Administrateur
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    EnglandBritishDirector37254010002
    CLARK, Robert Edmund
    50 Motspur Park
    KT3 6PL New Malden
    Surrey
    Secrétaire
    50 Motspur Park
    KT3 6PL New Malden
    Surrey
    British71028550001
    EVANS, Malcolm John
    22 Brookhill Drive
    NG8 2PS Nottingham
    Secrétaire
    22 Brookhill Drive
    NG8 2PS Nottingham
    British60525740001
    MAIR, James Stewart
    13 Jackson Close
    Oadby
    LE2 4US Leicester
    Leicestershire
    Secrétaire
    13 Jackson Close
    Oadby
    LE2 4US Leicester
    Leicestershire
    British8864270002
    REED, Neil
    16a Church Lane
    Cossall
    NG16 2RW Nottingham
    East Midlands
    Secrétaire
    16a Church Lane
    Cossall
    NG16 2RW Nottingham
    East Midlands
    British85948070001
    ROBSON, Stuart Ian
    8 Belvedere Court Paulin Drive
    Winchmore Hill
    N21 1AZ London
    Secrétaire
    8 Belvedere Court Paulin Drive
    Winchmore Hill
    N21 1AZ London
    BritishFinance Director71308340006
    ANDERSON, Alan
    78 Pennington Road
    Southborough
    TN4 0AF Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    78 Pennington Road
    Southborough
    TN4 0AF Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Director3103840007
    BURNETT, George Barnett
    Kings Court
    41-51 Kingston Road
    KT22 7AP Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Kings Court
    41-51 Kingston Road
    KT22 7AP Leatherhead
    Surrey
    BritishCompany Director55096390004
    CLARK, Robert Edmund
    50 Motspur Park
    KT3 6PL New Malden
    Surrey
    Administrateur
    50 Motspur Park
    KT3 6PL New Malden
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant71028550001
    CLEMENTS, Colin Richard
    47 Water Lane
    Wootton
    NN4 6HA Northampton
    Administrateur
    47 Water Lane
    Wootton
    NN4 6HA Northampton
    BritishCompany Director11419180002
    DUNN, Richard Martin
    84 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    84 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompany Director5376410001
    EVANS, Malcolm John
    22 Brookhill Drive
    NG8 2PS Nottingham
    Administrateur
    22 Brookhill Drive
    NG8 2PS Nottingham
    BritishCompany Director60525740001
    FOX, Derick Henry
    Renard Main Street
    Foston
    NG32 2JU Grantham
    Lincolnshire
    Administrateur
    Renard Main Street
    Foston
    NG32 2JU Grantham
    Lincolnshire
    BritishCompany Director5541820001
    LEWIS, Peter Donald
    Ashtead House Business Park 8
    Barnett Wood Lane
    KT22 7DG Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Ashtead House Business Park 8
    Barnett Wood Lane
    KT22 7DG Leatherhead
    Surrey
    BritishCompany Director55096310003
    MACKAY, Gordon Angus
    39 High Meadow
    Tollerton
    NG12 4DZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    39 High Meadow
    Tollerton
    NG12 4DZ Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director5541810003
    PETCH, Jonathan Leslie
    53 Solway Road
    WF17 6HJ Batley
    West Yorkshire
    Administrateur
    53 Solway Road
    WF17 6HJ Batley
    West Yorkshire
    BritishDirector55719870001
    POWELL, John Michael
    Rosemaund Cottage
    Westonbirt
    GL8 8QT Tetbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    Rosemaund Cottage
    Westonbirt
    GL8 8QT Tetbury
    Gloucestershire
    BritishCompany Director65916250002
    ROBSON, Stuart Ian
    Kings House
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    C/O Ashtead Group Plc
    Uk
    Administrateur
    Kings House
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    C/O Ashtead Group Plc
    Uk
    United KingdomBritishDirector71308340006
    SHEARSTONE, Michael Terence
    The Beeches
    Holme Pierrepont
    NG12 2LD Nottingham
    Administrateur
    The Beeches
    Holme Pierrepont
    NG12 2LD Nottingham
    BritishManaging Director5485470001

    SHERIFF PLANT HIRE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed charge
    Créé le 31 mars 1995
    Livré le 01 avr. 1995
    En cours
    Montant garanti
    £1,500,000 due from the compant to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Various items of property which include: 3 x ford transit 120 vans, 1 x daihatsu fourtrack fieldman commercial jeep, 1 x atlas 1304M wheeled hydraulic excavator.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 01 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge
    Créé le 24 juin 1994
    Livré le 28 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 22 mars 1993
    Livré le 22 mars 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One volvo dump truck a 25 chassis no. 4452 (see schedule attached to form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Chattels mortgage
    Créé le 19 mars 1993
    Livré le 19 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule attached to the form 395.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 19 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 27 févr. 1992
    Livré le 29 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £500,000
    Brèves mentions
    First fixed charge over items as listed on the schedule to the form 395.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 29 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 25 févr. 1992
    Livré le 25 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule attached to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 25 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 juil. 1991
    Livré le 06 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the south and west side of george street, lincoln.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 juil. 1991
    Livré le 06 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the east side of dixon way, lincoln.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 oct. 1988
    Livré le 03 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    • 09 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0